ADSHILTA LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaADSHILTA LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 01052683
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de ADSHILTA LIMITED?

    • Desarrollo de proyectos de construcción (41100) / Construcción

    ¿Dónde se encuentra ADSHILTA LIMITED?

    Dirección de la sede social
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de ADSHILTA LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 mar 2019

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para ADSHILTA LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Declaración de confirmación presentada el 01 ago 2020 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Comptes modifiés de filiale exemptée d'audit établis au 31 mar 2019

    14 páginasAAMD

    legacy

    206 páginasPARENT_ACC

    legacy

    3 páginasGUARANTEE2

    legacy

    1 páginasAGREEMENT2

    Declaración de confirmación presentada el 01 ago 2019 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2019

    3 páginasAA

    Cancelación total de la carga 13

    4 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 6

    4 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 9

    4 páginasMR04

    Declaración de confirmación presentada el 15 ago 2018 con actualizaciones

    4 páginasCS01

    Nombramiento de Mr Jonathan Charles Mcnuff como director el 25 abr 2018

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Mr Bruce Michael James como director el 25 abr 2018

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Timothy Andrew Roberts como director el 25 abr 2018

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mr Charles John Middleton como director el 25 abr 2018

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Sarah Morrell Barzycki como director el 30 mar 2018

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Nigel Mark Webb como director el 25 abr 2018

    1 páginasTM01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2018

    3 páginasAA

    Cese del nombramiento de Lucinda Margaret Bell como director el 19 ene 2018

    1 páginasTM01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2017

    3 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 15 ago 2017 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Notification de Bld Property Holdings Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 06 abr 2016

    1 páginasPSC02

    ¿Quiénes son los directivos de ADSHILTA LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    BRITISH LAND COMPANY SECRETARIAL LIMITED
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Secretario corporativo
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Tipo de identificaciónEEE
    Número de registro8992198
    187856670001
    JAMES, Bruce Michael
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Director
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    EnglandBritishHead Of Secretariat226746900001
    MCNUFF, Jonathan Charles
    Seymour Street
    York House
    W1H 7LX London
    45
    United Kingdom
    Director
    Seymour Street
    York House
    W1H 7LX London
    45
    United Kingdom
    United KingdomBritishChartered Accountant205624050001
    MIDDLETON, Charles John
    Seymour Street
    York House
    W1H 7LX London
    45
    United Kingdom
    Director
    Seymour Street
    York House
    W1H 7LX London
    45
    United Kingdom
    United KingdomBritishCorporate Tax Executive79841030002
    CHIA, Swee Ming
    10 Mount Ephraim Road
    Streatham
    SW16 1NG London
    Secretario
    10 Mount Ephraim Road
    Streatham
    SW16 1NG London
    BritishCertified Accountant57837290001
    EKPO, Ndiana
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Secretario
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Other138446320001
    HUBERMAN, Paul Laurence
    80 Kingsley Way
    N2 0EN London
    Secretario
    80 Kingsley Way
    N2 0EN London
    British3470530003
    SCUDAMORE, Rebecca Jane
    40 Canbury Avenue
    KT2 6JP Kingston Upon Thames
    Surrey
    Secretario
    40 Canbury Avenue
    KT2 6JP Kingston Upon Thames
    Surrey
    Other72249480003
    BARZYCKI, Sarah Morrell
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    Director
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    United KingdomBritishHead Of Finance58016770004
    BELL, Lucinda Margaret
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    Director
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    EnglandBritishChartered Accountant32809050044
    BOWDEN, Robert Edward
    The Chase
    Ongar Road
    CM15 0DG Kelvedon Hatch
    Essex
    Director
    The Chase
    Ongar Road
    CM15 0DG Kelvedon Hatch
    Essex
    United KingdomBritishChartered Surveyor152497530001
    CARTER, Simon Geoffrey
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Director
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    United KingdomBritishTreasury Executive170891060001
    CLARKE, Peter Courtenay
    Oakmeade
    Park Road
    SL2 4PG Stoke Poges
    Berkshire
    Director
    Oakmeade
    Park Road
    SL2 4PG Stoke Poges
    Berkshire
    United KingdomBritishChartered Secretary78691990003
    DAVIDSON, Emanuel Wolfe
    6 Beechworth Close
    NW3 7UT London
    Director
    6 Beechworth Close
    NW3 7UT London
    United KingdomBritishCompany Director3470540001
    DAVIDSON, Gerald Abraham
    Gardnor House
    Flask Walk
    NW3 1HT London
    Director
    Gardnor House
    Flask Walk
    NW3 1HT London
    United KingdomBritishSurveyor35563210002
    DAVIDSON, Gerald Abraham
    Gardnor House
    Flask Walk
    NW3 1HT London
    Director
    Gardnor House
    Flask Walk
    NW3 1HT London
    United KingdomBritishSurveyor35563210002
    FORSHAW, Christopher Michael John
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    Director
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    EnglandBritishCompany Director1898090001
    GROSE, Benjamin Toby
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Director
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    United KingdomBritishChartered Surveyor146546000001
    GROSE, Benjamin Toby
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    Director
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    United KingdomBritishChartered Surveyor146546000001
    HESTER, Stephen Alan Michael
    3 Ilchester Place
    W14 8AA London
    Director
    3 Ilchester Place
    W14 8AA London
    BritishChief Executive51688320001
    HUBERMAN, Paul Laurence
    80 Kingsley Way
    N2 0EN London
    Director
    80 Kingsley Way
    N2 0EN London
    EnglandBritishChartered Accountant3470530003
    JONES, Andrew Marc
    Hazlewell Road
    Putney
    SW15 6LH London
    2
    Director
    Hazlewell Road
    Putney
    SW15 6LH London
    2
    EnglandBritishCompany Director82020730004
    RANGER, Patrick
    2 Park Hill
    Ealing
    W5 2JR London
    Director
    2 Park Hill
    Ealing
    W5 2JR London
    EnglandBritishChartered Surveyor80021100001
    ROBERTS, Graham Charles
    6a Lower Belgrave Street
    SW1W 0LJ London
    Director
    6a Lower Belgrave Street
    SW1W 0LJ London
    EnglandBritishChartered Accountant79807180002
    ROBERTS, Timothy Andrew
    Seymour Street
    York House
    W1H 7LX London
    45
    United Kingdom
    Director
    Seymour Street
    York House
    W1H 7LX London
    45
    United Kingdom
    EnglandBritishChartered Surveyor63986410004
    ROSCOE, Antony David
    54 Fowlers Walk
    W5 1BG London
    Director
    54 Fowlers Walk
    W5 1BG London
    BritishChartered Surveyor12774060001
    ROSE, Jonathan Winston
    44 Park Hall Road
    East Finchley
    N2 9PX London
    Director
    44 Park Hall Road
    East Finchley
    N2 9PX London
    BritishChartered Surveyor92654230001
    SCOTT, James Andrew
    13 Fairfield Lane
    SL2 3BX Farnham Royal
    Buckinghamshire
    Director
    13 Fairfield Lane
    SL2 3BX Farnham Royal
    Buckinghamshire
    BritishChartered Surveyor79599370001
    SMITH, Stephen Paul
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Director
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    EnglandBritishCompany Director148183670001
    STEWART, David Purcell
    The Oast House Best Beech
    TN5 6JH Wadhurst
    East Sussex
    Director
    The Oast House Best Beech
    TN5 6JH Wadhurst
    East Sussex
    United KingdomBritishChartered Accountant56336720001
    VANDEVIVERE, Jean-Marc
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Director
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    United KingdomFrenchCompany Director170947050001
    WARD, Christopher Peter Alan
    36 Bacons Drive
    EN6 4DU Cuffley
    Hertfordshire
    Director
    36 Bacons Drive
    EN6 4DU Cuffley
    Hertfordshire
    United KingdomBritishChartered Accountant80990890001
    WEBB, Nigel Mark
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    Director
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    EnglandBritishChartered Surveyor58059360001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de ADSHILTA LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Bld Property Holdings Limited
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    England
    06 abr 2016
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    England
    No
    Forma jurídicaPrivate Company Limited By Shares
    Autoridad legalCompanies Act 2006
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.
    • La persona tiene el derecho, directa o indirectamente, de nombrar o destituir a la mayoría de la junta directiva de la empresa.
    • La persona tiene el derecho de ejercer, o ejerce realmente, una influencia o control significativo sobre la empresa.
    Bld Property Holdings Limited
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    England
    06 abr 2016
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    England
    No
    Forma jurídicaPrivate Limited Company
    País de registroEngland
    Autoridad legalCompanies Act 2006
    Lugar de registroEngland & Wales
    Número de registro823907
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.

    ¿Tiene ADSHILTA LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Legal charge
    Creado el 07 feb 2000
    Entregado el 10 feb 2000
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to an agreement
    Breve descripción
    The property known as north of the junction of clink street and stoney street in the london borough of southwark.
    Personas con derecho
    • The Trustees of the Borough Market
    Transacciones
    • 10 feb 2000Registro de un cargo (395)
    • 27 oct 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Deed of assurance and release (supplemental to a trust deed and two supplemental trust deeds and a deed of assurance)
    Creado el 30 sept 1997
    Entregado el 07 oct 1997
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    In favour of the chargee the principal of and interest on the orginal stock (as defined) which amounts to £46,000,000 10 5/16% first mortgage debenture stock 2011 of asda property holdings PLC and all other monies intended to be secured by the deed of assurance and release
    Breve descripción
    Bennet court 10/12 bennet road reading berkshire together with all buildings and erections and fixtures (including tenants and trade fixtures) and fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Guardian Royal Exchange Assurance PLC
    Transacciones
    • 07 oct 1997Registro de un cargo (395)
    • 02 nov 2004Declaración de que parte o la totalidad de la propiedad de una carga flotante ha sido liberada (403b)
    • 09 mar 2019Satisfacción de una carga (MR04)
    Legal charge
    Creado el 24 dic 1996
    Entregado el 13 ene 1997
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from furlong homes PLC to the chargee provided that the total amount recoverable shall not exceed £1,041,500
    Breve descripción
    F/Hold land at 70 to 88 pentonville rd,12,14 and 16 penton street and 51,52 and 53 white lion street,london borough of islington; t/no ngl 570448; the goodwill of business; the proceeds of sale thereof and the benefit of all licences. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 13 ene 1997Registro de un cargo (395)
    • 27 oct 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 23 dic 1996
    Entregado el 07 ene 1997
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from asda property holdings PLC to the chargee not exceeding £1,333,333
    Breve descripción
    F/Hold land at 70 to 88 pentonville rd,12,14 and 16 penton street and 51,52 and 53 white lion st,london borough of islington; t/no ngl 570448; the goodwill of business and benefit of licences. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 07 ene 1997Registro de un cargo (395)
    • 27 oct 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 19 dic 1996
    Entregado el 07 ene 1997
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due frpm asda property holdings PLC to the chargee not exceeding £1,333,333
    Breve descripción
    F/Hold land at 70 to 88 pentonville rd,12,14 and 16 penton street and 51,52 and 53 white lion st,london borough of islington; ngl 570448; the goodwill of business,benefit of all licences and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personas con derecho
    • Asda Property Holdings PLC
    Transacciones
    • 07 ene 1997Registro de un cargo (395)
    • 27 oct 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Deed of assurance, supplemental to a trust deed and two supplemental trust deeds and a further deed of assurance
    Creado el 19 abr 1996
    Entregado el 26 abr 1996
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    In favour of the chargee the principal of and interest on the original stock (as defined) which amounts to £46,000,000 10 5/16% first mortgage debenture stock 2011 of asda property holdings PLC and all other monies intended to be secured by the deed of assurance
    Breve descripción
    45 and 47 shelton street and 15,17,19,21 endell street london WC2 together with all buildings erections fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Guardian Royal Exchange Assurance PLC
    Transacciones
    • 26 abr 1996Registro de un cargo (395)
    • 02 nov 2004Declaración de que parte o la totalidad de la propiedad de una carga flotante ha sido liberada (403b)
    • 02 feb 2019Satisfacción de una carga (MR04)
    Legal mortgage
    Creado el 26 feb 1996
    Entregado el 06 mar 1996
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from furlong homes limited to the chargee provided that the total amount recoverable in relation thereto under this mortgage shall not exceed £431,527
    Breve descripción
    F/Hold property - land at the junction of highway and glamis rd,tower hamlets,london and the proceeds of sale thereof; t/no egl 240725 the goodwill of business and benefit of all licences thereto.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 06 mar 1996Registro de un cargo (395)
    • 27 oct 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 19 jul 1995
    Entregado el 28 jul 1995
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee not exceeding £557,713
    Breve descripción
    F/H land at the junction of the highway and glamis road tower hamlets t/n egl 240725.
    Personas con derecho
    • Asda Property Holdings PLC
    Transacciones
    • 28 jul 1995Registro de un cargo (395)
    • 08 may 1998Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Deed of assurance
    Creado el 23 dic 1992
    Entregado el 05 ene 1993
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    For securing the principal amount of the original stock (as defined in the deed of assurance) due from the company to the chargee supplemental to a trust deed dated 26TH march 1986 and deeds supplemental thereto.
    Breve descripción
    1.45 and 47 shelton street and 15,17 19 and 21 endell street (formerly k/as 43,45 and 47 shelton street and 19A,21 23 and 25 endell street) london,WC2 t/no.ngl 234355.2.195 and 197 wardour street,london,W1.t/no.ln 122212,ln 10751.3.14 and 15 quarry street,guildford.t/no.sy 571237.4.bennet court,bennet road,reading.t/no.bk 233850.floating charge the undertaking of the company and all its property assets and rights whatsoever and wheresoever both present and future including its goodwill and any uncalled capital for the time being.
    Personas con derecho
    • Guardian Royal Exchange Assurance PLC
    Transacciones
    • 05 ene 1993Registro de un cargo (395)
    • 02 nov 2004Declaración de que parte o la totalidad de la propiedad de una carga flotante ha sido liberada (403b)
    • 02 feb 2019Satisfacción de una carga (MR04)
    Legal charge
    Creado el 01 jun 1992
    Entregado el 17 jun 1992
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    143 church lane,mill end,hertfordshire.t/no. Hd 132534.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 17 jun 1992Registro de un cargo (395)
    • 17 dic 1994Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 01 jun 1992
    Entregado el 17 jun 1992
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    196 charlton road,kenton,london borough of harrow.t/no.ngl 404900.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 17 jun 1992Registro de un cargo (395)
    • 10 sept 1993Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 01 jun 1992
    Entregado el 17 jun 1992
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    6 willow road,aylesbury,buckinghamshire.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 17 jun 1992Registro de un cargo (395)
    • 27 oct 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 31 dic 1991
    Entregado el 16 ene 1992
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    1-10 (incl) 12 & 14 easthill frome somerset and various others (see 395 for full details).
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 16 ene 1992Registro de un cargo (395)
    • 27 oct 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 01 mar 1973
    Entregado el 08 mar 1973
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    186 willesden lane london nw 2.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 08 mar 1973Registro de una carga
    • 27 oct 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0