M.W. MARSHALL (OVERSEAS) LIMITED

M.W. MARSHALL (OVERSEAS) LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaM.W. MARSHALL (OVERSEAS) LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 01060409
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de M.W. MARSHALL (OVERSEAS) LIMITED?

    • Empresa inactiva (99999) / Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales

    ¿Dónde se encuentra M.W. MARSHALL (OVERSEAS) LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Tower 42 Level 37
    25 Old Broad Street
    EC2N 1HQ London
    United Kingdom
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de M.W. MARSHALL (OVERSEAS) LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2010

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para M.W. MARSHALL (OVERSEAS) LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros

    6 páginas4.71

    Cese del nombramiento de Nicola Challen como secretario el 15 nov 2012

    1 páginasTM02

    Declaración de solvencia

    3 páginas4.70

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    1 páginas600

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    liquidation

    Acuerdo especial para la liquidación el 05 sept 2012

    LRESSP

    Déclaration annuelle établie au 06 ene 2012 avec liste complète des actionnaires

    3 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital02 feb 2012

    Estado de capital el 02 feb 2012

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2010

    13 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 06 ene 2011 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01

    legacy

    1 páginasSH20

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Estado de capital el 20 oct 2010

    • Capital: GBP 1
    4 páginasSH19

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resoluciones

    Share premium account cancelled 20/10/2010
    RES13
    capital

    Resolución de reducción del capital social emitido

    RES06

    Cese del nombramiento de Robert Stevens como director

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Barry Ward como director

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Andrew Evans como director

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mr Robin James Stewart como director

    2 páginasAP01

    Cambio de datos del director Paul Richard Mainwaring el 29 jun 2010

    2 páginasCH01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2009

    14 páginasAA

    Resoluciones

    Resolutions
    13 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resoluciones

    Remove s/cap clause 18/06/2010
    RES13
    capital

    Resolución de asignación de valores

    RES10
    incorporation

    Resolución de adopción de los Artículos de Asociación

    RES01

    Déclaration annuelle établie au 06 ene 2010 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01

    Cambio de datos del director Barry Charles Bernard Ward el 06 ene 2010

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del director Andrew Keith Evans el 06 ene 2010

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del director Paul Richard Mainwaring el 06 ene 2010

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del director Mr Robert Brian Stevens el 06 ene 2010

    2 páginasCH01

    ¿Quiénes son los directivos de M.W. MARSHALL (OVERSEAS) LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    MAINWARING, Paul Richard
    Level 37
    25 Old Broad Street
    EC2N 1HQ London
    Tower 42
    United Kingdom
    Director
    Level 37
    25 Old Broad Street
    EC2N 1HQ London
    Tower 42
    United Kingdom
    EnglandBritish116302540002
    STEWART, Robin James
    Level 37
    25 Old Broad Street
    EC2N 1HQ London
    Tower 42
    United Kingdom
    Director
    Level 37
    25 Old Broad Street
    EC2N 1HQ London
    Tower 42
    United Kingdom
    EnglandBritish161299680001
    ANKERS, Peter
    104 Meridian Place
    Marsh Wall
    E14 9FF London
    Secretario
    104 Meridian Place
    Marsh Wall
    E14 9FF London
    British56413750001
    BENTLEY, Peter John
    10 Myln Meadow
    Stock
    CM4 9NE Ingatestone
    Essex
    Secretario
    10 Myln Meadow
    Stock
    CM4 9NE Ingatestone
    Essex
    British2039000001
    CHALLEN, Nicola
    Level 37
    25 Old Broad Street
    EC2N 1HQ London
    Tower 42
    United Kingdom
    Secretario
    Level 37
    25 Old Broad Street
    EC2N 1HQ London
    Tower 42
    United Kingdom
    Other119903660002
    DE FREITAS, Maria Teresa
    Flat 1 47 Lloyd Baker Street
    WC1X 9AA London
    Secretario
    Flat 1 47 Lloyd Baker Street
    WC1X 9AA London
    British95153090009
    DEARLOVE, Juliet Mary
    Churchgate House
    15 Churchgate Street
    CM17 0JT Old Harlow
    Essex
    Secretario
    Churchgate House
    15 Churchgate Street
    CM17 0JT Old Harlow
    Essex
    British72784040001
    PEEL, Alistair Charles
    Deep Acres
    HP6 5NX Amersham
    6
    Bucks
    England
    Secretario
    Deep Acres
    HP6 5NX Amersham
    6
    Bucks
    England
    Other132896170001
    RAVER, Harold Mark
    21 Colson Gardens
    IG10 3RE Loughton
    Essex
    Secretario
    21 Colson Gardens
    IG10 3RE Loughton
    Essex
    British1493340004
    SHAW, Gary Allan
    63a Cambray Road
    SW12 0ER London
    Secretario
    63a Cambray Road
    SW12 0ER London
    British67579830001
    BALTES, Edward Charles
    23 Independence Drive
    Manhasset Hills
    FOREIGN Long Island
    New York 11040
    Usa
    Director
    23 Independence Drive
    Manhasset Hills
    FOREIGN Long Island
    New York 11040
    Usa
    Usa21696050001
    BENTLEY, Peter John
    10 Myln Meadow
    Stock
    CM4 9NE Ingatestone
    Essex
    Director
    10 Myln Meadow
    Stock
    CM4 9NE Ingatestone
    Essex
    British2039000001
    COLLIS, Sarah Ann
    53 The Avenue
    West Ealing
    W13 8JR London
    Director
    53 The Avenue
    West Ealing
    W13 8JR London
    EnglandBritish35447290002
    COWAN, Christopher Ian
    Ballards
    Ballards Lane
    RH8 0SN Limpsfield
    Surrey
    Director
    Ballards
    Ballards Lane
    RH8 0SN Limpsfield
    Surrey
    British54679190001
    EVANS, Andrew Keith
    Level 37
    25 Old Broad Street
    EC2N 1HQ London
    Tower 42
    United Kingdom
    Director
    Level 37
    25 Old Broad Street
    EC2N 1HQ London
    Tower 42
    United Kingdom
    EnglandBritish124021620001
    FEGEL, Samy
    Lattenstrasse 67
    8142 Uitikon Zurich
    FOREIGN
    Switzerland
    Director
    Lattenstrasse 67
    8142 Uitikon Zurich
    FOREIGN
    Switzerland
    British3143270001
    HOLMES, Deborah Ann
    87 Carrara Wharf
    Ranelagh Gardens Putney Bridge
    SW6 3UE London
    Director
    87 Carrara Wharf
    Ranelagh Gardens Putney Bridge
    SW6 3UE London
    Australian113674080001
    HOOPER, David Charles
    Alouette
    Mayfield Lane
    TN5 6HX Wadhurst
    East Sussex
    Director
    Alouette
    Mayfield Lane
    TN5 6HX Wadhurst
    East Sussex
    British85448170001
    HUGHES, Arthur Mcquade
    Miran San
    11 Windlesham Court Snows Ride
    GU20 6LA Windlesham
    Surrey
    Director
    Miran San
    11 Windlesham Court Snows Ride
    GU20 6LA Windlesham
    Surrey
    United KingdomBritish1458920002
    JACK, Stephen Andrew
    1 Hunter Road
    West Wimbledon
    SW20 8NZ London
    Director
    1 Hunter Road
    West Wimbledon
    SW20 8NZ London
    EnglandBritish13013280001
    KEENAN, Patrick Michael
    10 Plane Tree House
    Duchess Of Bedfords Walk
    W8 7QT London
    Director
    10 Plane Tree House
    Duchess Of Bedfords Walk
    W8 7QT London
    Australian42704380002
    KELSON, Christopher John Kerry
    10 Charles Ii Place
    77 Kings Road Chelsea
    SW3 4NG London
    Director
    10 Charles Ii Place
    77 Kings Road Chelsea
    SW3 4NG London
    British2039010003
    KNOWLES, Michael Anthony
    33 Colbert Avenue
    Thorpe Bay
    SS1 3BH Southend On Sea
    Essex
    Director
    33 Colbert Avenue
    Thorpe Bay
    SS1 3BH Southend On Sea
    Essex
    British17009660001
    PLASCO, Joel Darren
    Flat 5
    1 Chepstow Place
    W2 4TE London
    Director
    Flat 5
    1 Chepstow Place
    W2 4TE London
    British78522900003
    POTTER, Michael John William
    Blackhall Spinney
    Blackhall Lane
    TN15 0HP Sevenoaks
    Kent
    Director
    Blackhall Spinney
    Blackhall Lane
    TN15 0HP Sevenoaks
    Kent
    United KingdomBritish21712170002
    RILEY, Jacqueline Anne Louise
    13 Herald's Place
    Renfrew Road
    SE11 4NP London
    Director
    13 Herald's Place
    Renfrew Road
    SE11 4NP London
    EnglandBritish38508990001
    STEVENS, Robert Brian
    Level 37
    25 Old Broad Street
    EC2N 1HQ London
    Tower 42
    United Kingdom
    Director
    Level 37
    25 Old Broad Street
    EC2N 1HQ London
    Tower 42
    United Kingdom
    EnglandBritish129608370001
    TAYLOR, Kim Michael
    Firholm
    16 St Marys Road
    KT6 5EY Long Ditton
    Surrey
    Director
    Firholm
    16 St Marys Road
    KT6 5EY Long Ditton
    Surrey
    British34697370003
    WARD, Barry Charles Bernard
    Level 37
    25 Old Broad Street
    EC2N 1HQ London
    Tower 42
    United Kingdom
    Director
    Level 37
    25 Old Broad Street
    EC2N 1HQ London
    Tower 42
    United Kingdom
    EnglandBritish126732970001

    ¿Tiene M.W. MARSHALL (OVERSEAS) LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Guarantee & debenture
    Creado el 28 may 1999
    Entregado el 16 jun 1999
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    In favour of the chargee each and every liability arising under the finance documents which the company may have had at the time the debenture was entered into or thereafter have to the security trustee or any of the beneficiaries and pay to the security trustee every sum now or thereafter owing due or incurred by the company to the security trustee or any of the beneficiaries in respect of any such liabilities
    Breve descripción
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Hsbc Investment Bank PLC (As Trustee for the Beneficiaries)
    Transacciones
    • 16 jun 1999Registro de un cargo (395)
    • 18 may 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Deed of charge
    Creado el 15 dic 1993
    Entregado el 23 dic 1993
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Bank of Tokyo International Limitedas Agent for Itself and the Banks
    Transacciones
    • 23 dic 1993Registro de un cargo (395)
    • 15 dic 1999Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Deed of charge
    Creado el 28 feb 1989
    Entregado el 13 mar 1989
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee as agent for itself and the lenders as defined in the loan agreement dated 27/2/89 under the terms of the guarantee & dated 28/2/89 or this deed.
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Security Pacific National Bank
    Transacciones
    • 13 mar 1989Registro de una carga
    • 06 may 1993Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Deed of charge
    Creado el 27 feb 1989
    Entregado el 08 mar 1989
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee as agent for itself and the banks as defined in the loan agreement dated 27/2/89 under the terms of the guarantee of even date and/or this deed and/or if the charger become & an alternative borrower under the loan agreement
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Security Pacific National Bank
    Transacciones
    • 08 mar 1989Registro de una carga
    • 29 dic 1993Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    ¿Tiene M.W. MARSHALL (OVERSEAS) LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    05 sept 2012Inicio de la liquidación
    24 mar 2013Fecha de disolución
    Liquidación voluntaria de socios
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Laura May Waters
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Profesional
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Peter James Greaves
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Profesional
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0