BAKKAVOR FOODS LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | BAKKAVOR FOODS LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Activa |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 01060806 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | No |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de BAKKAVOR FOODS LIMITED?
- Fabricación de comidas y platos preparados (10850) / Industrias manufactureras
¿Dónde se encuentra BAKKAVOR FOODS LIMITED?
| Dirección de la sede social | Fitzroy Place 5th Floor, 8 Mortimer Street W1T 3JJ London England |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de BAKKAVOR FOODS LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| GEEST FOODS LIMITED | 02 sept 1988 | 02 sept 1988 |
| GEEST ASSOCIATES LIMITED | 07 jul 1972 | 07 jul 1972 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de BAKKAVOR FOODS LIMITED?
| Vencido | No |
|---|---|
| Próximas cuentas | |
| Próximo período contable finaliza el | 31 dic 2025 |
| Próximas cuentas vencen el | 30 sept 2026 |
| Últimas cuentas | |
| Últimas cuentas cerradas hasta | 28 dic 2024 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para BAKKAVOR FOODS LIMITED?
| Última declaración de confirmación cerrada hasta | 24 may 2026 |
|---|---|
| Próxima declaración de confirmación vence | 07 jun 2026 |
| Última declaración de confirmación | |
| Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 24 may 2025 |
| Vencido | No |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para BAKKAVOR FOODS LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Domicilio social registrado cambiado de Greencore Manton Wood Retford Road Manton Wood Enterprise Park Worksop S80 2RS England a Fitzroy Place 5th Floor, 8 Mortimer Street London W1T 3JJ el 05 feb 2026 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de Fitzroy Place 5th Floor 8 Mortimer Street London W1T 3JJ England a Greencore Manton Wood Retford Road Manton Wood Enterprise Park Worksop S80 2RS el 29 ene 2026 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Nombramiento de Ms Kirsty Beck como director el 21 ene 2026 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Nombramiento de Lee Finney como director el 21 ene 2026 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Andy Parton como director el 21 ene 2026 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Michael Evans como secretario el 21 ene 2026 | 2 páginas | AP03 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Michael Edwards como director el 21 ene 2026 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Annabel Tagoe-Bannerman como secretario el 21 ene 2026 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 28 dic 2024 | 67 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 24 may 2025 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Lee Miley como director el 01 nov 2024 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Benjamin Jay Waldron como director el 31 oct 2024 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 30 dic 2023 | 62 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 24 may 2024 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2022 | 60 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 24 may 2023 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Agust Gudmundsson como director el 01 nov 2022 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 25 dic 2021 | 65 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 24 may 2022 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 26 dic 2020 | 67 páginas | AA | ||||||||||
Memorándum y Estatutos | 20 páginas | MA | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Nombramiento de Michael Edwards como director el 29 jun 2021 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Benjamin Jay Waldron como director el 29 jun 2021 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 24 may 2021 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de BAKKAVOR FOODS LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVANS, Michael | Secretario | 5th Floor, 8 Mortimer Street W1T 3JJ London Fitzroy Place England | 344775580001 | |||||||
| BECK, Kirsty | Director | 5th Floor, 8 Mortimer Street W1T 3JJ London Fitzroy Place England | England | British | 309013370001 | |||||
| FINNEY, Lee | Director | 5th Floor, 8 Mortimer Street W1T 3JJ London Fitzroy Place England | England | British | 344805430001 | |||||
| MILEY, Lee | Director | 5th Floor, 8 Mortimer Street W1T 3JJ London Fitzroy Place England | United Kingdom | British | 329004310001 | |||||
| PARTON, Andy | Director | 5th Floor, 8 Mortimer Street W1T 3JJ London Fitzroy Place England | England | British | 300811540001 | |||||
| DURRANT, Dawn Elizabeth | Secretario | 112 Empingham Road PE9 2SU Stamford Lincolnshire | British | 47940000002 | ||||||
| HOWES, Richard | Secretario | West Marsh Road PE11 2BB Spalding Lincolnshire | 150178510001 | |||||||
| JOWETT, Jonathan David | Secretario | 43 Armistead Way Cranage CW4 8FE Crewe Cheshire | British | 103825760001 | ||||||
| PUNNETT, Jolyon | Secretario | 37 The Gowans Sutton On The Forest YO61 1DL Sutton On The Forest North Yorkshire | British | 151217690001 | ||||||
| ROBERTSON, Neil Charles | Secretario | 16 Barmstedt Drive LE15 6RG Oakham Rutland | British | 48323870001 | ||||||
| SCRIVEN, Jane Katherine | Secretario | Manor Farm Manor Road Sutton PE5 7XG Wansford Cambridgeshire | British | 3536930008 | ||||||
| STANSBURY, John | Secretario | West Marsh Road PE11 2BB Spalding Lincolnshire | 152846960001 | |||||||
| TAGOE-BANNERMAN, Annabel | Secretario | 5th Floor 8 Mortimer Street W1T 3JJ London Fitzroy Place England | 259991270001 | |||||||
| WALLACE, Brian Godman | Secretario | The Old Barn 28 Main Street LE15 7PL Market Overton Leicestershire | British | 34264790001 | ||||||
| WITHAM, Simon | Secretario | 5th Floor 8 Mortimer Street W1T 3JJ London Fitzroy Place England | 166665110001 | |||||||
| ARNADOTTIR, Hildur | Director | Funafold 87 112 Reykjavic Iceland | Icelandic | 112354460001 | ||||||
| DUTTON, John Edward | Director | 23 Cley Hall Drive PE11 2EB Spalding Lincolnshire | United Kingdom | British | 24867440001 | |||||
| EDWARDS, Michael | Director | 5th Floor 8 Mortimer Street W1T 3JJ London Fitzroy Place England | England | British | 277970310001 | |||||
| GUDMUNDSSON, Agust | Director | 5th Floor 8 Mortimer Street W1T 3JJ London Fitzroy Place England | United Kingdom | Icelandic | 79348500026 | |||||
| GUDMUNDSSON, Lydur | Director | 68 Cadogan Place SW1X 9RS London | England | Icelandic | 113042340001 | |||||
| HOWES, Richard David | Director | The Court 20 Uppingham Road LE15 6JD Oakham Leicestershire | United Kingdom | British | 118715250001 | |||||
| MACIELINSKI, Peter Martin | Director | New Haven Church Road, Cookham SL6 9PG Maidenhead Berkshire | England | British | 68699160001 | |||||
| MENZIES-GOW, Robert Ian | Director | Ashwell Cottage Church Close Ashwell LE15 7LP Oakham Leicestershire | United Kingdom | British | 75693480001 | |||||
| PATES, Gordon Christopher | Director | West Marsh Road PE11 2BB Spalding Lincolnshire | England | British | 44438670001 | |||||
| PULLEN, Jonathan Mark | Director | 1 Beechgrove Gardens Henley Road SL7 2TH Marlow Buckinghamshire | England | British | 38923660001 | |||||
| SAVAGE, Ann | Director | West Marsh Road PE11 2BB Spalding Lincolnshire | England | British | 146046600001 | |||||
| SCRIVEN, Jane Katherine | Director | Manor Farm Manor Road Sutton PE5 7XG Wansford Cambridgeshire | England | British | 3536930008 | |||||
| SPIRLING, John William | Director | 88 North Promenade FY8 2QP Lytham St Annes Lancashire | United Kingdom | British | 208166960001 | |||||
| SUGDEN, David Arnold | Director | Godfreys Farmhouse 19 Main Street LE15 7NJ Greetham Rutland | British | 48181100002 | ||||||
| VAN GEEST, Leonard Waling | Director | Lockerley Hall SO51 0LU Romsey Hampshire | England | British | 59300900001 | |||||
| VOYLE, Gareth John | Director | 6 Northfield Court Conduit Street PE9 1RA Stamford Lincolnshire | United Kingdom | British | 69027440005 | |||||
| WALDRON, Benjamin Jay | Director | 8 Mortimer Street W1T 3JJ London Fitzroy Place 5th Floor England | England | British | 198102510002 | |||||
| WALLACE, Brian Godman | Director | The Old Barn 28 Main Street LE15 7PL Market Overton Leicestershire | British | 34264790001 | ||||||
| WALTON, Francis Brian | Director | West Marsh Road PE11 2BB Spalding Lincolnshire | United Kingdom | British | 146055570001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de BAKKAVOR FOODS LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bakkavor Limited | 06 abr 2016 | 5th Floor 8 Mortimer Street W1T 3JJ London Fitzroy Place England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0