XYZ 123 LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaXYZ 123 LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 01062299
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de XYZ 123 LIMITED?

    • Otras industrias manufactureras n.c.p. (32990) / Industrias manufactureras

    ¿Dónde se encuentra XYZ 123 LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Psl House
    Eastern Avenue
    LU5 4JY Dunstable
    Beds
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de XYZ 123 LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    POWER SEMI-CONDUCTORS LIMITED21 jul 197221 jul 1972

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de XYZ 123 LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 ago 2015

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para XYZ 123 LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Declaración de confirmación presentada el 18 dic 2016 con actualizaciones

    5 páginasCS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 ago 2015

    2 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 18 dic 2015 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital15 ene 2016

    Estado de capital el 15 ene 2016

    • Capital: GBP 70
    SH01

    Cese del nombramiento de Richard Terence Ellis como director el 06 nov 2015

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Christopher Hurst Downton como secretario el 30 jun 2015

    1 páginasTM02

    Certificado de cambio de nombre

    Company name changed power semi-conductors LIMITED\certificate issued on 28/05/15
    2 páginasCERTNM
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    change-of-name

    Resolución de cambio de nombre de la empresa el 17 abr 2015

    RES15

    Aviso de cambio de nombre

    2 páginasCONNOT

    Cuentas de exención total para empresas pequeñas preparadas hasta el 31 ago 2014

    5 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 18 dic 2014 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital19 dic 2014

    Estado de capital el 19 dic 2014

    • Capital: GBP 70
    SH01

    Cuentas de exención total para empresas pequeñas preparadas hasta el 31 ago 2013

    5 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 18 dic 2013 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital23 dic 2013

    Estado de capital el 23 dic 2013

    • Capital: GBP 70
    SH01

    Cuentas de exención total para empresas pequeñas preparadas hasta el 31 ago 2012

    5 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 18 dic 2012 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01

    Cese del nombramiento de Christopher Morgan como director

    1 páginasTM01

    Cuentas de exención total para empresas pequeñas preparadas hasta el 31 ago 2011

    4 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 18 dic 2011 avec liste complète des actionnaires

    7 páginasAR01

    Cuentas de exención total para empresas pequeñas preparadas hasta el 31 ago 2010

    4 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 18 dic 2010 avec liste complète des actionnaires

    7 páginasAR01

    Cambio de datos del director Robert George Golden el 12 nov 2010

    2 páginasCH01

    Déclaration annuelle établie au 18 dic 2009 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01

    Cambio de datos del director Robert George Golden el 02 oct 2009

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del director Christopher David Morgan el 02 oct 2009

    2 páginasCH01

    ¿Quiénes son los directivos de XYZ 123 LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    CROXFORD, Daniel
    40 Down Road
    LU5 4DD Dunstable
    Bedfordshire
    Director
    40 Down Road
    LU5 4DD Dunstable
    Bedfordshire
    United KingdomBritish106036840001
    GOLDEN, Robert George
    Weighbridge Court
    Irlam
    M44 6TJ Manchester
    7
    Lancashire
    Director
    Weighbridge Court
    Irlam
    M44 6TJ Manchester
    7
    Lancashire
    United KingdomBritish105459830001
    DOWNTON, Christopher Hurst
    The Barns
    Little Lane
    DN10 4RY Gringley On The Hill
    South Yorkshire
    Secretario
    The Barns
    Little Lane
    DN10 4RY Gringley On The Hill
    South Yorkshire
    British154777780001
    LEE, Patricia
    3 Farraline Road
    WD18 0DQ Watford
    Hertfordshire
    Secretario
    3 Farraline Road
    WD18 0DQ Watford
    Hertfordshire
    British73649080001
    SYDNEY, Esther
    8 The Dart
    Grovehill
    HP2 6EW Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    Secretario
    8 The Dart
    Grovehill
    HP2 6EW Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    British37242150002
    SYDNEY, Susan Ann
    Hollytree Wood Lane
    South Heath
    HP16 0RB Great Missenden
    Buckinghamshire
    Secretario
    Hollytree Wood Lane
    South Heath
    HP16 0RB Great Missenden
    Buckinghamshire
    British1929090001
    ELLIS, Richard Terence
    Ingleford 3 Orchard Mill
    Riversdale
    SL8 5XP Bourne End
    Buckinghamshire
    Director
    Ingleford 3 Orchard Mill
    Riversdale
    SL8 5XP Bourne End
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish822390003
    MORGAN, Christopher David
    4 Wentworth Road
    SG13 8JP Hertford
    Hertfordshire
    Director
    4 Wentworth Road
    SG13 8JP Hertford
    Hertfordshire
    United KingdomBritish106036970001
    SYDNEY, Peter
    Highways Farm Rushmere Lane
    Orchard Leigh
    HP5 3QY Chesham
    Buckinghamshire
    Director
    Highways Farm Rushmere Lane
    Orchard Leigh
    HP5 3QY Chesham
    Buckinghamshire
    British1929100004

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de XYZ 123 LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Psl Group (Uk) Limited
    Eastern Avenue Industrial Estate, Eastern Avenue
    LU5 4JY Dunstable
    Psl Group
    England
    01 ago 2016
    Eastern Avenue Industrial Estate, Eastern Avenue
    LU5 4JY Dunstable
    Psl Group
    England
    No
    Forma jurídicaLimited Company
    País de registroUk
    Autoridad legalCompanies Act
    Lugar de registroUk
    Número de registro5373856
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.

    ¿Tiene XYZ 123 LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Legal assignment
    Creado el 01 abr 2009
    Entregado el 16 abr 2009
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Any credit balance for the purchase of debts includes any discounting allowances the benefit of all the other provisions of the contract and all securities but only in respect of that credit balance (the contract monies) see image for full details.
    Personas con derecho
    • Hsbc Bank PLC
    Transacciones
    • 16 abr 2009Registro de un cargo (395)
    Fixed charge on purchased debts which fail to vest
    Creado el 14 ago 2008
    Entregado el 16 ago 2008
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    By way of fixed equitable charge all debts purchased or purported to be purchased by the security holder pursuant to an agreement for the purchase of debts between the security holder and the company (including associated rights relating thereto) which fail to vest effectively or absolutely in the security holder for any reason.
    Personas con derecho
    • Hsbc Invoice Finance (UK) LTD ("the Security Holder")
    Transacciones
    • 16 ago 2008Registro de un cargo (395)
    Floating charge
    Creado el 14 ago 2008
    Entregado el 16 ago 2008
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    By way of floating charge all the undertaking of the company and all assets whatsoever and wheresoever including stock in trade and uncalled capital but excluding any debts and associated rights relating thereto.
    Personas con derecho
    • Hsbc Invoice Finance (UK) LTD
    Transacciones
    • 16 ago 2008Registro de un cargo (395)
    • 19 ago 2008
    Debenture
    Creado el 25 abr 2008
    Entregado el 09 may 2008
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Personas con derecho
    • Hsbc Bank PLC
    Transacciones
    • 09 may 2008Registro de un cargo (395)
    Composite all assets guarantee and debenture
    Creado el 15 jun 2005
    Entregado el 23 jun 2005
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and the obligors to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Ge Commercial Finance Limited
    Transacciones
    • 23 jun 2005Registro de un cargo (395)
    • 23 abr 2009Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Charge
    Creado el 15 sept 1994
    Entregado el 16 sept 1994
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed charge on all goodwill and uncalled capital for the time being of the company; and all patents patent applications inventions trade marks trade names etc.
    Personas con derecho
    • Midland Bank PLC
    Transacciones
    • 16 sept 1994Registro de un cargo (395)
    Legal charge
    Creado el 24 mar 1994
    Entregado el 09 abr 1994
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    L/H property k/a unit b caxton centre porters wood st albans herts. Together with all fixtures and fittings now or at any time hereafter on the property. The benefits of all rights licences and the goodwill of the mortgagor in relation to the business from time to time carried on at the property.
    Personas con derecho
    • Midland Bank PLC
    Transacciones
    • 09 abr 1994Registro de un cargo (395)
    • 24 jul 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 01 may 1988
    Entregado el 09 may 1988
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    L/H interest of unit 10 colne way court,colne way,watford,hertfordshire.
    Personas con derecho
    • Midland Bank PLC
    Transacciones
    • 09 may 1988Registro de un cargo (395)
    • 24 jul 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Creado el 14 jun 1984
    Entregado el 19 jun 1984
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed & floating charge over undertaking and all property and assets present and future including book debts and uncalled capital.
    Personas con derecho
    • Midland Bank PLC
    Transacciones
    • 19 jun 1984Registro de un cargo (395)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0