HAWKINS PLANT

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaHAWKINS PLANT
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad privada sin límite de capital
    Número de empresa 01065554
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de HAWKINS PLANT?

    • Actividades de oficinas centrales (70100) / Actividades profesionales, científicas y técnicas

    ¿Dónde se encuentra HAWKINS PLANT?

    Dirección de la sede social
    The Grange 2 Aston Street
    Wem
    SY4 5AY Shrewsbury
    United Kingdom
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de HAWKINS PLANT?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    HAWKINS PLANT HIRE LIMITED02 abr 198402 abr 1984
    CHARLES HAWKINS & SONS(CONTRACTORS)LIMITED11 ago 197211 ago 1972

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de HAWKINS PLANT?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2020

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para HAWKINS PLANT?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01
    ABDZZT2Q

    Cese del nombramiento de Alan Arthur Nixon como secretario el 06 dic 2021

    1 páginasTM02
    XAIQPJ5T

    Declaración de confirmación presentada el 27 nov 2021 sin actualizaciones

    3 páginasCS01
    XAIQPIOQ

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2020

    6 páginasAA
    AACUBHG2

    Declaración de confirmación presentada el 27 nov 2020 sin actualizaciones

    3 páginasCS01
    X9YDRTX5

    Cese del nombramiento de Alan Arthur Nixon como director el 15 feb 2021

    1 páginasTM01
    X9YDQAWH

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2019

    6 páginasAA
    A95C33JC

    Declaración de confirmación presentada el 27 nov 2019 sin actualizaciones

    3 páginasCS01
    X8J521KR

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2018

    6 páginasAA
    A8DOOOII

    Domicilio social registrado cambiado de Charleston House Cruckmoor Lane Prees Green Whitchurch Shropshire SY13 2BS a The Grange 2 Aston Street Wem Shrewsbury SY4 5AY el 04 sept 2019

    1 páginasAD01
    X8DBEBMA

    Declaración de confirmación presentada el 27 nov 2018 sin actualizaciones

    3 páginasCS01
    X7JP4WIP

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2017

    7 páginasAA
    X75HVWQY

    Declaración de confirmación presentada el 27 nov 2017 sin actualizaciones

    3 páginasCS01
    X6K4JBHN

    Cuentas de microempresa preparadas hasta el 31 dic 2016

    5 páginasAA
    A65WFWR4

    Declaración de confirmación presentada el 27 nov 2016 con actualizaciones

    5 páginasCS01
    X5KOM9UP

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2015

    6 páginasAA
    A5CS11BD

    Déclaration annuelle établie au 27 nov 2015 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital01 dic 2015

    Estado de capital el 01 dic 2015

    • Capital: GBP 2
    SH01
    X4LBC8KA

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2014

    6 páginasAA
    A41IJBJS

    Déclaration annuelle établie au 27 nov 2014 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital04 dic 2014

    Estado de capital el 04 dic 2014

    • Capital: GBP 2
    SH01
    X3LZX60Z

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2013

    5 páginasAA
    A3FLXLQJ

    Déclaration annuelle établie au 27 nov 2013 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital10 dic 2013

    Estado de capital el 10 dic 2013

    • Capital: GBP 2
    SH01
    X2MWSHMJ

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2012

    6 páginasAA
    A28Y5029

    Déclaration annuelle établie au 27 nov 2012 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01
    X1MP61SQ

    ¿Quiénes son los directivos de HAWKINS PLANT?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    HAWKINS, Janette Helen
    Grange House
    Loppington
    SY4 5SR Wem
    Shropshire
    Director
    Grange House
    Loppington
    SY4 5SR Wem
    Shropshire
    EnglandBritishDirector37309220001
    BURNS, Christopher
    5 Richards Close
    Wootton Bassett
    SN4 7LE Swindon
    Wiltshire
    Secretario
    5 Richards Close
    Wootton Bassett
    SN4 7LE Swindon
    Wiltshire
    IrishAccountant66007600001
    NIXON, Alan Arthur
    The Old House
    Brown Heath
    SY12 0LB Ellesmere
    Shropshire
    Secretario
    The Old House
    Brown Heath
    SY12 0LB Ellesmere
    Shropshire
    BritishDirector67543830004
    OTTERBURN, Hugh Robert
    28 Longford Turning
    TF9 3PF Market Drayton
    Salop
    Secretario
    28 Longford Turning
    TF9 3PF Market Drayton
    Salop
    British2938860001
    PASS, Alan
    Becketts 11 Kettering Road
    Isham
    NN14 1HQ Kettering
    Northamptonshire
    Secretario
    Becketts 11 Kettering Road
    Isham
    NN14 1HQ Kettering
    Northamptonshire
    BritishFinance Director5179100002
    STOTT, Christopher
    5 Grange Park
    St. Arvans
    NP16 6EA Chepstow
    Secretario
    5 Grange Park
    St. Arvans
    NP16 6EA Chepstow
    BritishAccountant84131830001
    WYCHERLEY, Sian Mair
    Hillside
    The Graig
    NP1 7FA Cwmcarn
    Gwent
    Secretario
    Hillside
    The Graig
    NP1 7FA Cwmcarn
    Gwent
    British60690570001
    A G SECRETARIAL LIMITED
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    Secretario corporativo
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    90084920001
    ATKINSON, Ralph
    5 Ferndene
    BS32 9DG Bradley Stoke
    Bristol
    Director
    5 Ferndene
    BS32 9DG Bradley Stoke
    Bristol
    BritishRisk Director82227730001
    BISH, Andrew Brandon
    Fairfield House
    Malmesbury Road
    SN16 9QX Minety
    Wiltshire
    Director
    Fairfield House
    Malmesbury Road
    SN16 9QX Minety
    Wiltshire
    United KingdomBritishFinancial Director87360330001
    BLACKBURN, Robert Paul
    Willow Cottage Coalpit Lane
    Off Station Road Whittington
    SY11 4BW Oswestry
    Shropshire
    Director
    Willow Cottage Coalpit Lane
    Off Station Road Whittington
    SY11 4BW Oswestry
    Shropshire
    EnglandBritishCompany Director181188220001
    BONGARTEN, Karl James
    27 Lost Mine Place
    06877 Ridgefield
    Connecticut
    Usa
    Director
    27 Lost Mine Place
    06877 Ridgefield
    Connecticut
    Usa
    AmericanCompany Vice President59693970001
    CAMERON, Richard Alexander
    Druidstone House
    64 High Street Stanwick
    NN9 6QA Wellingborough
    Northamptonshire
    Director
    Druidstone House
    64 High Street Stanwick
    NN9 6QA Wellingborough
    Northamptonshire
    BritishCompany Director16715040001
    DODDRELL, Paul Derek
    177 Juniper Way
    BS32 0DP Bradley Stoke
    Bristol
    Director
    177 Juniper Way
    BS32 0DP Bradley Stoke
    Bristol
    BritishChief Financial Officer74659020001
    EDWARDS, David
    12 The Culvert
    BS32 8AB Bradley Stoke
    Bristol
    Director
    12 The Culvert
    BS32 8AB Bradley Stoke
    Bristol
    BritishManaging Director74658940003
    FANELLI, Tom Francis
    No 4 Mendas Road Danbury 06811
    Connecticut
    Usa
    Director
    No 4 Mendas Road Danbury 06811
    Connecticut
    Usa
    AmericanCompany Vice President59691400001
    HAWKINS, Charles Barry Kitley
    SY4
    Director
    SY4
    United KingdomBritishDirector39331910001
    HAWKINS, Charles Ernest Kitley
    Belle Vue Ellesmere Road
    Wem
    SY4 5TX Shrewsbury
    Salop
    Director
    Belle Vue Ellesmere Road
    Wem
    SY4 5TX Shrewsbury
    Salop
    BritishDirector2938910001
    HAWKINS, Evelyn Melrose
    Belle Vue Ellesmere Road
    Wem
    SY4 5TX Shrewsbury
    Salop
    Director
    Belle Vue Ellesmere Road
    Wem
    SY4 5TX Shrewsbury
    Salop
    BritishDirector2938870001
    HAWKINS, Michael Edward Ernest
    Grange House
    Loppington
    SY4 5SR Wem
    Shropshire
    Director
    Grange House
    Loppington
    SY4 5SR Wem
    Shropshire
    United KingdomBritishDirector188706610001
    JACOBS, Christopher
    299 Seneca Place
    Westfield
    New Jersey 07090
    Usa
    Director
    299 Seneca Place
    Westfield
    New Jersey 07090
    Usa
    AmericanChief Financial Officer47655500001
    JONES, Frank Douglas
    Franklyn 10 Prescott Fields
    Baschurch
    SY4 2EL Shrewsbury
    Shropshire
    Director
    Franklyn 10 Prescott Fields
    Baschurch
    SY4 2EL Shrewsbury
    Shropshire
    EnglandBritishPlant Manager53180400001
    LITTLES, Carolyn Sue
    25 River Road
    Apt 3107
    06897 Wilton
    Connecticut
    Usa
    Director
    25 River Road
    Apt 3107
    06897 Wilton
    Connecticut
    Usa
    AmericanCompany Vice President59691910001
    MATTHEW, Jeremy
    Beethovenstraat 132-3
    FOREIGN Amsterdam
    1077 Js
    The Netherlands
    Director
    Beethovenstraat 132-3
    FOREIGN Amsterdam
    1077 Js
    The Netherlands
    British And CanadianDirector115291490001
    NIXON, Alan Arthur
    The Old House
    Brown Heath
    SY12 0LB Ellesmere
    Shropshire
    Director
    The Old House
    Brown Heath
    SY12 0LB Ellesmere
    Shropshire
    United KingdomBritishDirector67543830004
    OTTERBURN, Hugh Robert
    28 Longford Turning
    TF9 3PF Market Drayton
    Salop
    Director
    28 Longford Turning
    TF9 3PF Market Drayton
    Salop
    BritishDirector2938860001
    PASS, Alan
    Becketts 11 Kettering Road
    Isham
    NN14 1HQ Kettering
    Northamptonshire
    Director
    Becketts 11 Kettering Road
    Isham
    NN14 1HQ Kettering
    Northamptonshire
    BritishFinance Director5179100002
    SHUTT, Beverly Vincent
    15 Delphside
    TF12 5EP Broseley
    Salop
    Director
    15 Delphside
    TF12 5EP Broseley
    Salop
    EnglishCompany Director34374060001
    SMITH, Gary John
    1 Eagle Farm Close
    Myddle
    SY4 3RQ Shrewsbury
    Salop
    Director
    1 Eagle Farm Close
    Myddle
    SY4 3RQ Shrewsbury
    Salop
    EnglandBritishService Manager24872600001
    SMITH, Peter Leslie
    Grove House
    Grove Crescent, Woore
    CW3 9SX Crewe
    Cheshire
    Director
    Grove House
    Grove Crescent, Woore
    CW3 9SX Crewe
    Cheshire
    BritishChartered Accountant88329890001
    THOMPSON, Brian
    The Silo 4 The Greenyard
    Yardley Hastings
    NN7 1EQ Northampton
    Northamptonshire
    Director
    The Silo 4 The Greenyard
    Yardley Hastings
    NN7 1EQ Northampton
    Northamptonshire
    United KingdomBritishCompany Director17395050002
    WILLIAMS, Robert Clive
    Cross Keys Farm
    Brown Heath
    SY12 0LA Ellesmere
    Salop
    Director
    Cross Keys Farm
    Brown Heath
    SY12 0LA Ellesmere
    Salop
    BritishDirector2938890001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de HAWKINS PLANT?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Aarco 287 Limited
    Cruckmoor Lane
    Prees Green
    SY13 2BS Whitchurch
    Charleston House
    England
    06 abr 2016
    Cruckmoor Lane
    Prees Green
    SY13 2BS Whitchurch
    Charleston House
    England
    No
    Forma jurídicaLimited Company
    País de registroEngland
    Autoridad legalEnglish
    Lugar de registroEndland And Wales
    Número de registro6144291
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.
    • La persona tiene el derecho, directa o indirectamente, de nombrar o destituir a la mayoría de la junta directiva de la empresa.

    ¿Tiene HAWKINS PLANT alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Fixed and floating charge
    Creado el 12 dic 1995
    Entregado el 20 dic 1995
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital goodwill bookdebts and patents.
    Personas con derecho
    • Midland Bank PLC
    Transacciones
    • 20 dic 1995Registro de un cargo (395)
    • 22 jun 1999Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creado el 10 mar 1993
    Entregado el 31 mar 1993
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 31 mar 1993Registro de un cargo (395)
    • 12 ene 1996Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 23 oct 1992
    Entregado el 13 nov 1992
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the security documents (as defined therein)
    Breve descripción
    Floating charge over all assets and rights of the company present and future.
    Personas con derecho
    • Security Pacific Eurofinance PLC
    Transacciones
    • 13 nov 1992Registro de un cargo (395)
    • 12 ene 1996Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 21 sept 1990
    Entregado el 03 oct 1990
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    The depot on the north west side of mold road buckley, clwyd title no wa 55216.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 03 oct 1990Registro de una carga
    • 14 abr 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Lease purchase agreement
    Creado el 29 jun 1987
    Entregado el 03 jul 1987
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £1,252,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the lease purchase agreement.
    Breve descripción
    All insurance policies whatsoever in respect of items of equipment (see form 395 for full details) and all the benefits thereof.
    Personas con derecho
    • Lefac International Sa
    Transacciones
    • 03 jul 1987Registro de una carga
    • 12 ene 1996Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Guarantee & debenture
    Creado el 02 abr 1984
    Entregado el 19 abr 1984
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 19 abr 1984Registro de una carga
    • 12 ene 1996Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Guarantee & debenture
    Creado el 01 ago 1983
    Entregado el 08 ago 1983
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or charles hawkins & sons (tractors and machinery) limited to the chargee on any account whatsoever.
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 08 ago 1983Registro de una carga
    • 12 ene 1996Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 01 feb 1982
    Entregado el 09 feb 1982
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    F/H land at loppington 1.713 acres shropshire.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 09 feb 1982Registro de una carga
    • 12 ene 1996Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 23 oct 1981
    Entregado el 29 oct 1981
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    F/H grange farm loppington wem shropshire.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 29 oct 1981Registro de una carga
    • 14 abr 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 23 oct 1981
    Entregado el 29 oct 1981
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    F/H the old cheese store ellesmere road wem shropshire.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 29 oct 1981Registro de una carga
    • 10 dic 1991Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 09 oct 1981
    Entregado el 19 oct 1981
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed & floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill, bookdebts uncalled capital. Together with all buildings and trade fixtures including fixed p & m thereon.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 19 oct 1981Registro de una carga
    • 12 ene 1996Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 11 may 1981
    Entregado el 18 may 1981
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    F/H land at loppington shropshire being no 166 on the O.S. map for the area.
    Personas con derecho
    • Midland Bank PLC
    Transacciones
    • 18 may 1981Registro de una carga
    Mortgage
    Creado el 17 sept 1980
    Entregado el 25 sept 1980
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    F/H premises being grange farm, loppington, wem, shropshire together with all fixtures.
    Personas con derecho
    • Midland Bank PLC
    Transacciones
    • 25 sept 1980Registro de una carga
    Irrevocable authority to messrs graham withers & co evidencing equitable assignment of property
    Creado el 12 may 1980
    Entregado el 19 may 1980
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Freehold land and premises being grange farm loppington, wem, shropshire together with all fixtures whatsoever.
    Personas con derecho
    • Midland Bank PLC
    Transacciones
    • 19 may 1980Registro de una carga

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0