KOSSWAY AUTOMATICS WESTERN

KOSSWAY AUTOMATICS WESTERN

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaKOSSWAY AUTOMATICS WESTERN
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad privada sin límite de capital
    Número de empresa 01069441
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de KOSSWAY AUTOMATICS WESTERN?

    • Empresa inactiva (99999) / Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales

    ¿Dónde se encuentra KOSSWAY AUTOMATICS WESTERN?

    Dirección de la sede social
    3 The Maltings
    Wetmore Road
    DE14 1SE Burton On Trent
    Staffordshire
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de KOSSWAY AUTOMATICS WESTERN?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    KOSSWAY AUTOMATICS (WESTERN) LIMITED04 sept 197204 sept 1972

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de KOSSWAY AUTOMATICS WESTERN?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta30 sept 2018

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para KOSSWAY AUTOMATICS WESTERN?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Cuentas para una empresa pequeña preparadas hasta el 30 sept 2018

    14 páginasAA

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Declaración de confirmación presentada el 20 dic 2018 con actualizaciones

    4 páginasCS01

    Declaración de confirmación presentada el 24 jul 2018 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 sept 2017

    5 páginasAA

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resoluciones

    Cancel share prem a/c 18/10/2017
    RES13
    capital

    Resolución de reducción del capital social emitido

    RES06

    Cese del nombramiento de Steven John Holmes como director el 22 sept 2017

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mr Stewart Frank Bradley Baker como director el 21 sept 2017

    2 páginasAP01

    Declaración de confirmación presentada el 24 jul 2017 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 24 sept 2016

    6 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 24 jul 2016 con actualizaciones

    5 páginasCS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 26 sept 2015

    5 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 24 jul 2015 avec liste complète des actionnaires

    3 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital24 jul 2015

    Estado de capital el 24 jul 2015

    • Capital: GBP 50,000
    SH01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 27 sept 2014

    4 páginasAA

    Cese del nombramiento de James William O'halleran como director el 02 abr 2015

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de James William O'halleran como director el 02 abr 2015

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mr Steven John Holmes como director el 24 mar 2015

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Luke Lyon Alvarez como director el 24 mar 2015

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Steven John Holmes como secretario el 23 mar 2015

    1 páginasTM02

    Nombramiento de Mrs Carys Damon como secretario el 23 mar 2015

    2 páginasAP03

    Déclaration annuelle établie au 24 jul 2014 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 28 sept 2013

    1 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 24 jul 2013 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital06 ago 2013

    Estado de capital tras una asignación de acciones el 06 ago 2013

    SH01

    ¿Quiénes son los directivos de KOSSWAY AUTOMATICS WESTERN?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    DAMON, Carys
    3 The Maltings
    Wetmore Road
    DE14 1SE Burton On Trent
    Staffordshire
    Secretario
    3 The Maltings
    Wetmore Road
    DE14 1SE Burton On Trent
    Staffordshire
    196165700001
    BAKER, Stewart Frank Bradley
    3 The Maltings
    Wetmore Road
    DE14 1SE Burton On Trent
    Staffordshire
    Director
    3 The Maltings
    Wetmore Road
    DE14 1SE Burton On Trent
    Staffordshire
    United KingdomBritish230753770001
    ALBION, Susan
    7 Brownsfield Road
    WS13 6BT Lichfield
    Staffordshire
    Secretario
    7 Brownsfield Road
    WS13 6BT Lichfield
    Staffordshire
    British80142740001
    CONWAY, Mark
    Lanaway 14 Cranford Avenue
    EX8 2HT Exmouth
    Devon
    Secretario
    Lanaway 14 Cranford Avenue
    EX8 2HT Exmouth
    Devon
    British17198720001
    HOLMES, Steven John
    3 The Maltings
    Wetmore Road
    DE14 1SE Burton On Trent
    Staffordshire
    Secretario
    3 The Maltings
    Wetmore Road
    DE14 1SE Burton On Trent
    Staffordshire
    British80455940002
    KOSS, Gerald
    62 Montagu Road
    Datchet
    SL3 9DY Slough
    Berkshire
    Secretario
    62 Montagu Road
    Datchet
    SL3 9DY Slough
    Berkshire
    British17198710001
    OLDHAM, Annette
    Edwards Farm Road
    Fradley
    WS13 8NR Lichfield
    29
    Staffordshire
    Secretario
    Edwards Farm Road
    Fradley
    WS13 8NR Lichfield
    29
    Staffordshire
    British135120610001
    PAGE, David
    Rye Croft House
    11 Outwoods Lane Anslow
    DE13 9UB Burton On Trent
    Staffordshire
    Secretario
    Rye Croft House
    11 Outwoods Lane Anslow
    DE13 9UB Burton On Trent
    Staffordshire
    British31059170002
    STANDEN, Reginald James
    7 Warrington Spur
    Old Windsor
    SL4 2NF Windsor
    Berkshire
    Secretario
    7 Warrington Spur
    Old Windsor
    SL4 2NF Windsor
    Berkshire
    British36981610002
    ALVAREZ, Luke Lyon
    3 The Maltings
    Wetmore Road
    DE14 1SE Burton On Trent
    Staffordshire
    Director
    3 The Maltings
    Wetmore Road
    DE14 1SE Burton On Trent
    Staffordshire
    United KingdomBritish63436630003
    BEER, Brian Leslie
    52 Meadow View
    Rolleston On Dove
    DE13 9AN Burton On Trent
    Staffordshire
    Director
    52 Meadow View
    Rolleston On Dove
    DE13 9AN Burton On Trent
    Staffordshire
    British61154670001
    BOARDLEY, Richard Owen
    13 Sandalwood Road
    LE11 3PR Loughborough
    Leicestershire
    Director
    13 Sandalwood Road
    LE11 3PR Loughborough
    Leicestershire
    United KingdomBritish48134520001
    CHILDS, Mervyn Peter
    Riverdale
    Lower High Street
    DE13 9LU Burton On Trent
    Staffordshire
    Director
    Riverdale
    Lower High Street
    DE13 9LU Burton On Trent
    Staffordshire
    British4619870002
    CHINN, Neil
    12 Newton Park
    Newton Solney
    DE15 0SX Burton On Trent
    Staffordshire
    Director
    12 Newton Park
    Newton Solney
    DE15 0SX Burton On Trent
    Staffordshire
    United KingdomBritish61154190002
    CONWAY, Mark
    Lanaway 14 Cranford Avenue
    EX8 2HT Exmouth
    Devon
    Director
    Lanaway 14 Cranford Avenue
    EX8 2HT Exmouth
    Devon
    British17198720001
    CONWAY, Paul Frederick
    32 Queens Acre
    Kings Road
    SL4 2BE Windsor
    Berkshire
    Director
    32 Queens Acre
    Kings Road
    SL4 2BE Windsor
    Berkshire
    British35400650002
    CONWAY, Raymond Edward
    106 Belmont Rise
    Belmont
    SM2 6EE Sutton
    Surrey
    Director
    106 Belmont Rise
    Belmont
    SM2 6EE Sutton
    Surrey
    British34840600001
    DAY, John Michael
    27 Newfield Lane
    S17 3DB Sheffield
    South Yorkshire
    Director
    27 Newfield Lane
    S17 3DB Sheffield
    South Yorkshire
    EnglandBritish69255730001
    HARRISON, Gerald Edward
    57 Furlong Lane
    Alrewas
    DE13 7EE Burton On Trent
    Staffordshire
    Director
    57 Furlong Lane
    Alrewas
    DE13 7EE Burton On Trent
    Staffordshire
    United KingdomBritish47602430001
    HOLMES, Steven John
    3 The Maltings
    Wetmore Road
    DE14 1SE Burton On Trent
    Staffordshire
    Director
    3 The Maltings
    Wetmore Road
    DE14 1SE Burton On Trent
    Staffordshire
    EnglandBritish196165310001
    HOYLE, Russell Blackburn
    5 Orchard Rise
    TW10 5BX Richmond
    Surrey
    Director
    5 Orchard Rise
    TW10 5BX Richmond
    Surrey
    EnglandBritish52822380002
    KOSS, Gerald
    62 Montagu Road
    Datchet
    SL3 9DY Slough
    Berkshire
    Director
    62 Montagu Road
    Datchet
    SL3 9DY Slough
    Berkshire
    United KingdomBritish17198710001
    LANGLEY, Paul
    9 Besbury Close
    Dorridge
    B93 8NT Solihull
    Director
    9 Besbury Close
    Dorridge
    B93 8NT Solihull
    EnglandBritish99802010001
    MASSEY, Timothy John
    Chestnut Cottage Silver Lane
    Marchington
    ST14 8LL Uttoxeter
    Staffordshire
    Director
    Chestnut Cottage Silver Lane
    Marchington
    ST14 8LL Uttoxeter
    Staffordshire
    United KingdomBritish100259370001
    O'HALLERAN, James William
    3 The Maltings
    Wetmore Road
    DE14 1SE Burton On Trent
    Staffordshire
    Director
    3 The Maltings
    Wetmore Road
    DE14 1SE Burton On Trent
    Staffordshire
    EnglandBritish103876820003
    PAGE, David
    Rye Croft House
    11 Outwoods Lane Anslow
    DE13 9UB Burton On Trent
    Staffordshire
    Director
    Rye Croft House
    11 Outwoods Lane Anslow
    DE13 9UB Burton On Trent
    Staffordshire
    EnglandBritish31059170002
    SIMON, Christopher Neil
    89 Ella Road
    West Bridgford
    NG2 5GZ Nottingham
    Director
    89 Ella Road
    West Bridgford
    NG2 5GZ Nottingham
    EnglandBritish95528490001
    SMITH, Keith Ian
    Wythtree
    Manor Park
    DE13 7JA Kings Bromley
    Staffordshire
    Director
    Wythtree
    Manor Park
    DE13 7JA Kings Bromley
    Staffordshire
    United KingdomBritish40284060002
    WITHERS, Roger Dean
    Ivy Cottage The Green
    Dinton
    HP17 8UP Aylesbury
    Buckinghamshire
    Director
    Ivy Cottage The Green
    Dinton
    HP17 8UP Aylesbury
    Buckinghamshire
    EnglandBritish29586130001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de KOSSWAY AUTOMATICS WESTERN?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Inspired Gaming (Uk) Limited
    The Maltings
    Wetmore Road
    DE14 1SE Burton-On-Trent
    3
    Staffordshire
    England
    06 abr 2016
    The Maltings
    Wetmore Road
    DE14 1SE Burton-On-Trent
    3
    Staffordshire
    England
    No
    Forma jurídicaPrivate Limited Company (Ltd)
    País de registroEngland & Wales
    Autoridad legalCompanies Acts 1985 To 1989
    Lugar de registroUk Register Of Private Limited Companies
    Número de registro03565640
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.
    • La persona tiene el derecho, directa o indirectamente, de nombrar o destituir a la mayoría de la junta directiva de la empresa.
    • La persona tiene el derecho de ejercer, o ejerce realmente, una influencia o control significativo sobre la empresa.

    ¿Tiene KOSSWAY AUTOMATICS WESTERN alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Deed of amendment and restatement to a composite guarantee and debenture dated 3RD august 1998 (the "deed")
    Creado el 26 mar 1999
    Entregado el 10 abr 1999
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All indebtedness and liabilities and obligations due owing or incurred pursuant to the revolving credit facility, the mezzanine loan facility and that part of the term loan facility not used to repay indebtedness due under the facilities agreement to the chargee by any group company whether actually or contingently, whether pursuant to the guarantee or otherwise
    Breve descripción
    L/H unit 6B freshfields industrial estate stevenson road kemp town brighton t/n ESX56825 l/h unit 1 spring meadow trading estate lamby way cardiff t/n WA567171 39 woodall road redburn industrial estate enfield t/n NGL500091 (for further details see form 395). fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC(As Security Trustee for the Security Beneficiaries)(the "Security Trustee")
    Transacciones
    • 10 abr 1999Registro de un cargo (395)
    • 05 oct 2001Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Creado el 03 ago 1998
    Entregado el 20 ago 1998
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due pursuant to the revolving credit facility to the security beneficiaries by any group company on any account whatsoever
    Breve descripción
    L/H unit 6B freshfields industrial estate stevenson road kemp town brighton t/n ESX56825 l/h unit 1 spring meadow trading estate lamby way cardiff t/n WA567171 39 woodall road redburn industrial estate enfield t/n NGL500091 for further details of property charged refer to form 395. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 20 ago 1998Registro de un cargo (395)
    • 05 oct 2001Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 04 dic 1979
    Entregado el 14 dic 1979
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed & floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill, bookdebts uncalled capital. Together with all buildings fixtures (including trade fixtures) together with fixed plant from time to time thereof.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank LTD
    Transacciones
    • 14 dic 1979Registro de una carga
    • 31 oct 1996Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0