KOSSWAY AUTOMATICS WESTERN
Visión general
| Nombre de la empresa | KOSSWAY AUTOMATICS WESTERN |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad privada sin límite de capital |
| Número de empresa | 01069441 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de KOSSWAY AUTOMATICS WESTERN?
- Empresa inactiva (99999) / Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales
¿Dónde se encuentra KOSSWAY AUTOMATICS WESTERN?
| Dirección de la sede social | 3 The Maltings Wetmore Road DE14 1SE Burton On Trent Staffordshire |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de KOSSWAY AUTOMATICS WESTERN?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| KOSSWAY AUTOMATICS (WESTERN) LIMITED | 04 sept 1972 | 04 sept 1972 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de KOSSWAY AUTOMATICS WESTERN?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 30 sept 2018 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para KOSSWAY AUTOMATICS WESTERN?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Cuentas para una empresa pequeña preparadas hasta el 30 sept 2018 | 14 páginas | AA | ||||||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 3 páginas | DS01 | ||||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 20 dic 2018 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 24 jul 2018 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 sept 2017 | 5 páginas | AA | ||||||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Cese del nombramiento de Steven John Holmes como director el 22 sept 2017 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||
Nombramiento de Mr Stewart Frank Bradley Baker como director el 21 sept 2017 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 24 jul 2017 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 24 sept 2016 | 6 páginas | AA | ||||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 24 jul 2016 con actualizaciones | 5 páginas | CS01 | ||||||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 26 sept 2015 | 5 páginas | AA | ||||||||||||||
Déclaration annuelle établie au 24 jul 2015 avec liste complète des actionnaires | 3 páginas | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 27 sept 2014 | 4 páginas | AA | ||||||||||||||
Cese del nombramiento de James William O'halleran como director el 02 abr 2015 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||
Cese del nombramiento de James William O'halleran como director el 02 abr 2015 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||
Nombramiento de Mr Steven John Holmes como director el 24 mar 2015 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||||||
Cese del nombramiento de Luke Lyon Alvarez como director el 24 mar 2015 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||
Cese del nombramiento de Steven John Holmes como secretario el 23 mar 2015 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||||||
Nombramiento de Mrs Carys Damon como secretario el 23 mar 2015 | 2 páginas | AP03 | ||||||||||||||
Déclaration annuelle établie au 24 jul 2014 avec liste complète des actionnaires | 4 páginas | AR01 | ||||||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 28 sept 2013 | 1 páginas | AA | ||||||||||||||
Déclaration annuelle établie au 24 jul 2013 avec liste complète des actionnaires | 4 páginas | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
¿Quiénes son los directivos de KOSSWAY AUTOMATICS WESTERN?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAMON, Carys | Secretario | 3 The Maltings Wetmore Road DE14 1SE Burton On Trent Staffordshire | 196165700001 | |||||||
| BAKER, Stewart Frank Bradley | Director | 3 The Maltings Wetmore Road DE14 1SE Burton On Trent Staffordshire | United Kingdom | British | 230753770001 | |||||
| ALBION, Susan | Secretario | 7 Brownsfield Road WS13 6BT Lichfield Staffordshire | British | 80142740001 | ||||||
| CONWAY, Mark | Secretario | Lanaway 14 Cranford Avenue EX8 2HT Exmouth Devon | British | 17198720001 | ||||||
| HOLMES, Steven John | Secretario | 3 The Maltings Wetmore Road DE14 1SE Burton On Trent Staffordshire | British | 80455940002 | ||||||
| KOSS, Gerald | Secretario | 62 Montagu Road Datchet SL3 9DY Slough Berkshire | British | 17198710001 | ||||||
| OLDHAM, Annette | Secretario | Edwards Farm Road Fradley WS13 8NR Lichfield 29 Staffordshire | British | 135120610001 | ||||||
| PAGE, David | Secretario | Rye Croft House 11 Outwoods Lane Anslow DE13 9UB Burton On Trent Staffordshire | British | 31059170002 | ||||||
| STANDEN, Reginald James | Secretario | 7 Warrington Spur Old Windsor SL4 2NF Windsor Berkshire | British | 36981610002 | ||||||
| ALVAREZ, Luke Lyon | Director | 3 The Maltings Wetmore Road DE14 1SE Burton On Trent Staffordshire | United Kingdom | British | 63436630003 | |||||
| BEER, Brian Leslie | Director | 52 Meadow View Rolleston On Dove DE13 9AN Burton On Trent Staffordshire | British | 61154670001 | ||||||
| BOARDLEY, Richard Owen | Director | 13 Sandalwood Road LE11 3PR Loughborough Leicestershire | United Kingdom | British | 48134520001 | |||||
| CHILDS, Mervyn Peter | Director | Riverdale Lower High Street DE13 9LU Burton On Trent Staffordshire | British | 4619870002 | ||||||
| CHINN, Neil | Director | 12 Newton Park Newton Solney DE15 0SX Burton On Trent Staffordshire | United Kingdom | British | 61154190002 | |||||
| CONWAY, Mark | Director | Lanaway 14 Cranford Avenue EX8 2HT Exmouth Devon | British | 17198720001 | ||||||
| CONWAY, Paul Frederick | Director | 32 Queens Acre Kings Road SL4 2BE Windsor Berkshire | British | 35400650002 | ||||||
| CONWAY, Raymond Edward | Director | 106 Belmont Rise Belmont SM2 6EE Sutton Surrey | British | 34840600001 | ||||||
| DAY, John Michael | Director | 27 Newfield Lane S17 3DB Sheffield South Yorkshire | England | British | 69255730001 | |||||
| HARRISON, Gerald Edward | Director | 57 Furlong Lane Alrewas DE13 7EE Burton On Trent Staffordshire | United Kingdom | British | 47602430001 | |||||
| HOLMES, Steven John | Director | 3 The Maltings Wetmore Road DE14 1SE Burton On Trent Staffordshire | England | British | 196165310001 | |||||
| HOYLE, Russell Blackburn | Director | 5 Orchard Rise TW10 5BX Richmond Surrey | England | British | 52822380002 | |||||
| KOSS, Gerald | Director | 62 Montagu Road Datchet SL3 9DY Slough Berkshire | United Kingdom | British | 17198710001 | |||||
| LANGLEY, Paul | Director | 9 Besbury Close Dorridge B93 8NT Solihull | England | British | 99802010001 | |||||
| MASSEY, Timothy John | Director | Chestnut Cottage Silver Lane Marchington ST14 8LL Uttoxeter Staffordshire | United Kingdom | British | 100259370001 | |||||
| O'HALLERAN, James William | Director | 3 The Maltings Wetmore Road DE14 1SE Burton On Trent Staffordshire | England | British | 103876820003 | |||||
| PAGE, David | Director | Rye Croft House 11 Outwoods Lane Anslow DE13 9UB Burton On Trent Staffordshire | England | British | 31059170002 | |||||
| SIMON, Christopher Neil | Director | 89 Ella Road West Bridgford NG2 5GZ Nottingham | England | British | 95528490001 | |||||
| SMITH, Keith Ian | Director | Wythtree Manor Park DE13 7JA Kings Bromley Staffordshire | United Kingdom | British | 40284060002 | |||||
| WITHERS, Roger Dean | Director | Ivy Cottage The Green Dinton HP17 8UP Aylesbury Buckinghamshire | England | British | 29586130001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de KOSSWAY AUTOMATICS WESTERN?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inspired Gaming (Uk) Limited | 06 abr 2016 | The Maltings Wetmore Road DE14 1SE Burton-On-Trent 3 Staffordshire England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
¿Tiene KOSSWAY AUTOMATICS WESTERN alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| Deed of amendment and restatement to a composite guarantee and debenture dated 3RD august 1998 (the "deed") | Creado el 26 mar 1999 Entregado el 10 abr 1999 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All indebtedness and liabilities and obligations due owing or incurred pursuant to the revolving credit facility, the mezzanine loan facility and that part of the term loan facility not used to repay indebtedness due under the facilities agreement to the chargee by any group company whether actually or contingently, whether pursuant to the guarantee or otherwise | |
Breve descripción L/H unit 6B freshfields industrial estate stevenson road kemp town brighton t/n ESX56825 l/h unit 1 spring meadow trading estate lamby way cardiff t/n WA567171 39 woodall road redburn industrial estate enfield t/n NGL500091 (for further details see form 395). fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Composite guarantee and debenture | Creado el 03 ago 1998 Entregado el 20 ago 1998 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due pursuant to the revolving credit facility to the security beneficiaries by any group company on any account whatsoever | |
Breve descripción L/H unit 6B freshfields industrial estate stevenson road kemp town brighton t/n ESX56825 l/h unit 1 spring meadow trading estate lamby way cardiff t/n WA567171 39 woodall road redburn industrial estate enfield t/n NGL500091 for further details of property charged refer to form 395. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Debenture | Creado el 04 dic 1979 Entregado el 14 dic 1979 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Fixed & floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill, bookdebts uncalled capital. Together with all buildings fixtures (including trade fixtures) together with fixed plant from time to time thereof. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0