BANNERMAN GROUP LIMITED

BANNERMAN GROUP LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Cuentas
  • Declaración anual
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaBANNERMAN GROUP LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 01071767
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de BANNERMAN GROUP LIMITED?

    • Empresa inactiva (99999) / Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales

    ¿Dónde se encuentra BANNERMAN GROUP LIMITED?

    Dirección de la sede social
    c/o MSQ PARTNERS LTD
    6 York Street
    York Street
    W1U 6PL London
    England
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de BANNERMAN GROUP LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta28 feb 2013

    ¿Cuál es el estado de la última declaración anual para BANNERMAN GROUP LIMITED?

    Declaración anual
    Última declaración anual

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para BANNERMAN GROUP LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    4 páginasDS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 28 feb 2013

    6 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 14 sept 2013 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital25 sept 2013

    Estado de capital el 25 sept 2013

    • Capital: GBP 50,000
    SH01

    Domicilio social registrado cambiado de * C/O Media Square Plc 6 York Street London W1U 6PL United Kingdom* el 25 sept 2013

    1 páginasAD01

    Nombramiento de Mr Daniel Yardley como director

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Mr Peter David Reid como director

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Dean Wright como director

    1 páginasTM01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 29 feb 2012

    6 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 14 sept 2012 avec liste complète des actionnaires

    3 páginasAR01

    legacy

    3 páginasMG02

    Cambio de datos del secretario Ashish Shah el 21 nov 2011

    1 páginasCH03

    Cambio de datos del secretario Ash Shah el 21 nov 2011

    1 páginasCH03

    Nombramiento de Ash Shah como secretario

    1 páginasAP03

    Cese del nombramiento de Colin Brigden como secretario

    1 páginasTM02

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 28 feb 2011

    6 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 14 sept 2011 avec liste complète des actionnaires

    3 páginasAR01

    Cese del nombramiento de Bruce Winfield como secretario

    1 páginasTM02

    Cese del nombramiento de Bruce Winfield como director

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mr Dean Anthony Wright como director

    2 páginasAP01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 28 feb 2010

    6 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 14 sept 2010 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01

    legacy

    3 páginasMG02

    Domicilio social registrado cambiado de * C/O Media Square Plc, Clarence Mill, Clarence Road Bollington Cheshire SK10 5JZ* el 01 dic 2009

    1 páginasAD01

    ¿Quiénes son los directivos de BANNERMAN GROUP LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    SHAH, Ashish
    c/o Media Square Plc
    York Street
    W1U 6PL London
    6
    United Kingdom
    Secretario
    c/o Media Square Plc
    York Street
    W1U 6PL London
    6
    United Kingdom
    164763820002
    REID, Peter David
    c/o Msq Partners Ltd
    York Street
    York Street
    W1U 6PL London
    6
    England
    Director
    c/o Msq Partners Ltd
    York Street
    York Street
    W1U 6PL London
    6
    England
    EnglandBritishGroup Ceo147274580002
    YARDLEY, Daniel John
    c/o Msq Partners Ltd
    York Street
    York Street
    W1U 6PL London
    6
    England
    Director
    c/o Msq Partners Ltd
    York Street
    York Street
    W1U 6PL London
    6
    England
    EnglandBritishChief Financial Officer180507300001
    ALEXANDER, Charles Stuart
    24 Waveney Close
    E1W 2JL London
    Secretario
    24 Waveney Close
    E1W 2JL London
    BritishChartered Accountant7666350001
    BRIGDEN, Colin John
    c/o Media Square Plc
    York Street
    W1U 6PL London
    6
    United Kingdom
    Secretario
    c/o Media Square Plc
    York Street
    W1U 6PL London
    6
    United Kingdom
    147336360001
    CLARKE, Martin John
    105 Congleton Road
    SK11 7XD Macclesfield
    Cheshire
    Secretario
    105 Congleton Road
    SK11 7XD Macclesfield
    Cheshire
    BritishAccountant53461320002
    CLAXTON, Caryl Barbara
    Westfield
    The Meades
    KT13 0LS Weybridge
    Surrey
    Secretario
    Westfield
    The Meades
    KT13 0LS Weybridge
    Surrey
    British30060920001
    WINFIELD, Bruce Malcolm
    22 Hillhouse Close
    RH10 4YY Turners Hill
    West Sussex
    Secretario
    22 Hillhouse Close
    RH10 4YY Turners Hill
    West Sussex
    British147948820001
    ALEXANDER, Charles Stuart
    24 Waveney Close
    E1W 2JL London
    Director
    24 Waveney Close
    E1W 2JL London
    BritishDirector7666350001
    ALEXANDER, Charles Stuart
    24 Waveney Close
    E1W 2JL London
    Director
    24 Waveney Close
    E1W 2JL London
    BritishChartered Accountant7666350001
    BELL, Patrick Charles
    Coles Barn
    Belchamp Otten
    CO10 7BG Sudbury
    Suffolk
    Director
    Coles Barn
    Belchamp Otten
    CO10 7BG Sudbury
    Suffolk
    United KingdomBritishDirector71758630001
    BOOKER, Gary Anthony
    23 Lindsay Drive
    TW17 8JU Shepperton
    Middlesex
    Director
    23 Lindsay Drive
    TW17 8JU Shepperton
    Middlesex
    BritishAccountant29708770002
    BURNS, Dominic John
    Flat 2 St James Court
    Claredon Road
    AL5 4UW Harpenden
    Hertfordshire
    Director
    Flat 2 St James Court
    Claredon Road
    AL5 4UW Harpenden
    Hertfordshire
    BritishProduction Director67260810001
    BURNS, Graeme Ian, Mr.
    29 Moody Street
    CW12 4AN Congleton
    Cheshire
    Director
    29 Moody Street
    CW12 4AN Congleton
    Cheshire
    United KingdomBritishAccountant75720570001
    CLAXTON, Caryl Barbara
    Westfield
    The Meades
    KT13 0LS Weybridge
    Surrey
    Director
    Westfield
    The Meades
    KT13 0LS Weybridge
    Surrey
    BritishSecretary30060920001
    CLAXTON, Harry Kendrick
    Westfield
    The Meades
    KT13 0LS Weybridge
    Surrey
    Director
    Westfield
    The Meades
    KT13 0LS Weybridge
    Surrey
    BritishCompany Director31938810001
    ESSEX, Norman Arthur
    Elm Green Farm
    Danbury
    CM3 4DW Chelmsford
    Essex
    Director
    Elm Green Farm
    Danbury
    CM3 4DW Chelmsford
    Essex
    BritishCompany Director7666380001
    ESSEX, Robert Thomas Tickler
    21 Rylett Road
    W12 9SS London
    Director
    21 Rylett Road
    W12 9SS London
    EnglandBritishDirector7666390002
    KAPP, Nicholas Ian
    1 Staddlestone Close
    RG31 6SP Reading
    Berkshire
    Director
    1 Staddlestone Close
    RG31 6SP Reading
    Berkshire
    BritishDirector60391720001
    MIDDLETON, Arthur Jeremy Barritt
    Corbar Hall
    Corbar Road
    SK17 6TF Buxton
    Director
    Corbar Hall
    Corbar Road
    SK17 6TF Buxton
    EnglandBritishCompany Director72455560001
    SAYSELL, Richard Geoffrey
    33 Lizban Street
    SE3 8SS London
    Director
    33 Lizban Street
    SE3 8SS London
    BritishDirector50920320001
    WELLS, Bruce William
    74 Harrow Road
    LU7 8UQ Leighton Buzzard
    Bedfordshire
    Director
    74 Harrow Road
    LU7 8UQ Leighton Buzzard
    Bedfordshire
    BritishOperations Director56341870001
    WINFIELD, Bruce Malcolm
    22 Hillhouse Close
    RH10 4YY Turners Hill
    West Sussex
    Director
    22 Hillhouse Close
    RH10 4YY Turners Hill
    West Sussex
    United KingdomBritishAccountant147948820001
    WRIGHT, Dean Anthony
    c/o Media Square Plc
    York Street
    W1U 6PL London
    6
    United Kingdom
    Director
    c/o Media Square Plc
    York Street
    W1U 6PL London
    6
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector159138180001

    ¿Tiene BANNERMAN GROUP LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Debenture
    Creado el 04 nov 2005
    Entregado el 17 nov 2005
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the obligors to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (The Security Trustee)
    Transacciones
    • 17 nov 2005Registro de un cargo (395)
    • 22 dic 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Debenture
    Creado el 15 oct 2004
    Entregado el 22 oct 2004
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 22 oct 2004Registro de un cargo (395)
    • 02 jul 2010Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Guarantee & debenture
    Creado el 28 jul 1981
    Entregado el 04 ago 1981
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the the company and/or hegerty and merry limited to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed & floating charge on the undertaking and all property and and assets present and future including goodwill & book debts uncalled capital. Together with fixed and moveable plant machinery fixtures implements and utensils.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 04 ago 1981Registro de una carga
    • 19 mar 1997Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 03 ene 1980
    Entregado el 10 ene 1980
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed & floating charge on the undertaking and all property and assets present and future including goodwill & book debts uncalled capital.. Together with fixed and moveable plant machinery fixtures implements and utensils.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 10 ene 1980Registro de una carga
    • 15 abr 1997Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0