BANNERMAN GROUP LIMITED
Visión general
Nombre de la empresa | BANNERMAN GROUP LIMITED |
---|---|
Estado de la empresa | Disuelta |
Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
Número de empresa | 01071767 |
Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
Fecha de constitución | |
Fecha de cese |
Resumen
Tiene PSCs súper seguros | No |
---|---|
Tiene gravámenes | Sí |
Tiene historial de insolvencia | No |
La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de BANNERMAN GROUP LIMITED?
- Empresa inactiva (99999) / Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales
¿Dónde se encuentra BANNERMAN GROUP LIMITED?
Dirección de la sede social | c/o MSQ PARTNERS LTD 6 York Street York Street W1U 6PL London England |
---|---|
Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles son las últimas cuentas de BANNERMAN GROUP LIMITED?
Últimas cuentas | |
---|---|
Últimas cuentas cerradas hasta | 28 feb 2013 |
¿Cuál es el estado de la última declaración anual para BANNERMAN GROUP LIMITED?
Declaración anual |
|
---|
¿Cuáles son las últimas presentaciones para BANNERMAN GROUP LIMITED?
Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 4 páginas | DS01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 28 feb 2013 | 6 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 14 sept 2013 avec liste complète des actionnaires | 4 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de * C/O Media Square Plc 6 York Street London W1U 6PL United Kingdom* el 25 sept 2013 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Daniel Yardley como director | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Peter David Reid como director | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Dean Wright como director | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 29 feb 2012 | 6 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 14 sept 2012 avec liste complète des actionnaires | 3 páginas | AR01 | ||||||||||
legacy | 3 páginas | MG02 | ||||||||||
Cambio de datos del secretario Ashish Shah el 21 nov 2011 | 1 páginas | CH03 | ||||||||||
Cambio de datos del secretario Ash Shah el 21 nov 2011 | 1 páginas | CH03 | ||||||||||
Nombramiento de Ash Shah como secretario | 1 páginas | AP03 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Colin Brigden como secretario | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 28 feb 2011 | 6 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 14 sept 2011 avec liste complète des actionnaires | 3 páginas | AR01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Bruce Winfield como secretario | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Bruce Winfield como director | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Dean Anthony Wright como director | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 28 feb 2010 | 6 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 14 sept 2010 avec liste complète des actionnaires | 4 páginas | AR01 | ||||||||||
legacy | 3 páginas | MG02 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de * C/O Media Square Plc, Clarence Mill, Clarence Road Bollington Cheshire SK10 5JZ* el 01 dic 2009 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de BANNERMAN GROUP LIMITED?
Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHAH, Ashish | Secretario | c/o Media Square Plc York Street W1U 6PL London 6 United Kingdom | 164763820002 | |||||||
REID, Peter David | Director | c/o Msq Partners Ltd York Street York Street W1U 6PL London 6 England | England | British | Group Ceo | 147274580002 | ||||
YARDLEY, Daniel John | Director | c/o Msq Partners Ltd York Street York Street W1U 6PL London 6 England | England | British | Chief Financial Officer | 180507300001 | ||||
ALEXANDER, Charles Stuart | Secretario | 24 Waveney Close E1W 2JL London | British | Chartered Accountant | 7666350001 | |||||
BRIGDEN, Colin John | Secretario | c/o Media Square Plc York Street W1U 6PL London 6 United Kingdom | 147336360001 | |||||||
CLARKE, Martin John | Secretario | 105 Congleton Road SK11 7XD Macclesfield Cheshire | British | Accountant | 53461320002 | |||||
CLAXTON, Caryl Barbara | Secretario | Westfield The Meades KT13 0LS Weybridge Surrey | British | 30060920001 | ||||||
WINFIELD, Bruce Malcolm | Secretario | 22 Hillhouse Close RH10 4YY Turners Hill West Sussex | British | 147948820001 | ||||||
ALEXANDER, Charles Stuart | Director | 24 Waveney Close E1W 2JL London | British | Director | 7666350001 | |||||
ALEXANDER, Charles Stuart | Director | 24 Waveney Close E1W 2JL London | British | Chartered Accountant | 7666350001 | |||||
BELL, Patrick Charles | Director | Coles Barn Belchamp Otten CO10 7BG Sudbury Suffolk | United Kingdom | British | Director | 71758630001 | ||||
BOOKER, Gary Anthony | Director | 23 Lindsay Drive TW17 8JU Shepperton Middlesex | British | Accountant | 29708770002 | |||||
BURNS, Dominic John | Director | Flat 2 St James Court Claredon Road AL5 4UW Harpenden Hertfordshire | British | Production Director | 67260810001 | |||||
BURNS, Graeme Ian, Mr. | Director | 29 Moody Street CW12 4AN Congleton Cheshire | United Kingdom | British | Accountant | 75720570001 | ||||
CLAXTON, Caryl Barbara | Director | Westfield The Meades KT13 0LS Weybridge Surrey | British | Secretary | 30060920001 | |||||
CLAXTON, Harry Kendrick | Director | Westfield The Meades KT13 0LS Weybridge Surrey | British | Company Director | 31938810001 | |||||
ESSEX, Norman Arthur | Director | Elm Green Farm Danbury CM3 4DW Chelmsford Essex | British | Company Director | 7666380001 | |||||
ESSEX, Robert Thomas Tickler | Director | 21 Rylett Road W12 9SS London | England | British | Director | 7666390002 | ||||
KAPP, Nicholas Ian | Director | 1 Staddlestone Close RG31 6SP Reading Berkshire | British | Director | 60391720001 | |||||
MIDDLETON, Arthur Jeremy Barritt | Director | Corbar Hall Corbar Road SK17 6TF Buxton | England | British | Company Director | 72455560001 | ||||
SAYSELL, Richard Geoffrey | Director | 33 Lizban Street SE3 8SS London | British | Director | 50920320001 | |||||
WELLS, Bruce William | Director | 74 Harrow Road LU7 8UQ Leighton Buzzard Bedfordshire | British | Operations Director | 56341870001 | |||||
WINFIELD, Bruce Malcolm | Director | 22 Hillhouse Close RH10 4YY Turners Hill West Sussex | United Kingdom | British | Accountant | 147948820001 | ||||
WRIGHT, Dean Anthony | Director | c/o Media Square Plc York Street W1U 6PL London 6 United Kingdom | England | British | Director | 159138180001 |
¿Tiene BANNERMAN GROUP LIMITED alguna carga?
Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
---|---|---|---|---|
Debenture | Creado el 04 nov 2005 Entregado el 17 nov 2005 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the obligors to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Debenture | Creado el 15 oct 2004 Entregado el 22 oct 2004 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Guarantee & debenture | Creado el 28 jul 1981 Entregado el 04 ago 1981 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the the company and/or hegerty and merry limited to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Fixed & floating charge on the undertaking and all property and and assets present and future including goodwill & book debts uncalled capital. Together with fixed and moveable plant machinery fixtures implements and utensils. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Debenture | Creado el 03 ene 1980 Entregado el 10 ene 1980 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Fixed & floating charge on the undertaking and all property and assets present and future including goodwill & book debts uncalled capital.. Together with fixed and moveable plant machinery fixtures implements and utensils. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0