BRITAX INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

BRITAX INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaBRITAX INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 01082250
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de BRITAX INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED?

    • Actividades de oficinas centrales (70100) / Actividades profesionales, científicas y técnicas

    ¿Dónde se encuentra BRITAX INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Building A Riverside Way
    Watchmoor Park
    GU15 3YL Camberley
    Surrey
    United Kingdom
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de BRITAX INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    B.S.G. INTERNATIONAL LIMITED29 may 199729 may 1997
    BRITAX INTERNATIONAL LIMITED11 jul 199411 jul 1994
    B.S.G. OVERSEAS LIMITED31 dic 197931 dic 1979
    B.S.G. EUROPE LIMITED16 nov 197216 nov 1972

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de BRITAX INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2022

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para BRITAX INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    1 páginasDS01

    Declaración de confirmación presentada el 10 dic 2023 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Nombramiento de Antoine Chulia como director el 01 nov 2023

    2 páginasAP01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2022

    21 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 10 dic 2022 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cese del nombramiento de Nathan Fenwick como director el 23 sept 2022

    1 páginasTM01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2021

    21 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 10 dic 2021 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2020

    21 páginasAA

    Cese del nombramiento de Matthew Frank Hinds como director el 26 ago 2021

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mr Michael John Pacharis como director el 31 ago 2021

    2 páginasAP01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2019

    19 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 10 dic 2020 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Nombramiento de Nathan Fenwick como director el 20 may 2020

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Joseph Copeland como director el 31 mar 2020

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Joseph Copeland como director el 27 ene 2020

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Michael Weccardt como director el 27 ene 2020

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mr Matthew Frank Hinds como director el 27 ene 2020

    2 páginasAP01

    Registro de la carga 010822500008, creada el 09 ene 2020

    57 páginasMR01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2018

    20 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 10 dic 2019 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cese del nombramiento de Markus Nagel como director el 11 nov 2019

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mr Michael Weccardt como director el 11 nov 2019

    2 páginasAP01

    ¿Quiénes son los directivos de BRITAX INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    CHULIA, Antoine
    Pleasant Rd.
    29708 Fort Mill
    4140
    South Carolina
    United States
    Director
    Pleasant Rd.
    29708 Fort Mill
    4140
    South Carolina
    United States
    United StatesAmericanBusiness Executive315384560001
    PACHARIS, Michael John
    Riverside Way
    Watchmoor Park
    GU15 3YL Camberley
    Building A
    Surrey
    United Kingdom
    Director
    Riverside Way
    Watchmoor Park
    GU15 3YL Camberley
    Building A
    Surrey
    United Kingdom
    United StatesAmericanCeo287152120001
    BONEHILL, Neville Keith
    22 Walton Croft
    B91 3GW Solihull
    West Midlands
    Secretario
    22 Walton Croft
    B91 3GW Solihull
    West Midlands
    BritishCompany Director31109110002
    MCCASLIN, Stuart David
    Victoria House 27 Victoria Road
    B50 4AS Bidford On Avon
    Warwickshire
    Secretario
    Victoria House 27 Victoria Road
    B50 4AS Bidford On Avon
    Warwickshire
    BritishCompany Secretary1824650002
    SKERTCHLY, Paul Clifford
    Hillswood Drive
    Hillswood Business Park
    KT16 0RS Chertsey
    3000
    England
    Secretario
    Hillswood Drive
    Hillswood Business Park
    KT16 0RS Chertsey
    3000
    England
    British82622600002
    THORNE, Raymond
    60 Silhill Hall Road
    B91 1JS Solihull
    West Midlands
    Secretario
    60 Silhill Hall Road
    B91 1JS Solihull
    West Midlands
    British2756010001
    BRITAX INTERNATIONAL SERVICES LIMITED
    Seton House
    Warwick Technology Park Gallows Hill
    CV34 6DE Warwick
    Secretario corporativo
    Seton House
    Warwick Technology Park Gallows Hill
    CV34 6DE Warwick
    109290004
    AMEY, Brian Leslie
    Edgemoor Howard Drive
    Hale
    WA15 0LT Altrincham
    Cheshire
    Director
    Edgemoor Howard Drive
    Hale
    WA15 0LT Altrincham
    Cheshire
    BritishDirector69888230001
    BAIN, Zeina Jalal
    Flat 5 Clifton Gardens
    Little Venice
    W9 1TD London
    Director
    Flat 5 Clifton Gardens
    Little Venice
    W9 1TD London
    United KingdomBritishInvestment Analyst126727040002
    BONEHILL, Neville Keith
    22 Walton Croft
    B91 3GW Solihull
    West Midlands
    Director
    22 Walton Croft
    B91 3GW Solihull
    West Midlands
    BritishCompany Director31109110002
    BROGAN, Bernard Desmond
    Blakeley Lodge
    Egginton Road Etwall
    DE65 6NQ Derby
    Derbyshire
    Director
    Blakeley Lodge
    Egginton Road Etwall
    DE65 6NQ Derby
    Derbyshire
    EnglandBritishChartered Engineer70252730001
    CANNON, Thomas Charles
    90 Knowle Wood Road
    Dorridge
    B93 8JP Solihull
    West Midlands
    Director
    90 Knowle Wood Road
    Dorridge
    B93 8JP Solihull
    West Midlands
    BritishChartered Secretary2756000001
    COPELAND, Joseph
    Pleasant Rd.
    29708 Fort Mill
    4140
    South Carolina
    United States
    Director
    Pleasant Rd.
    29708 Fort Mill
    4140
    South Carolina
    United States
    United StatesAmericanChief Executive Officer267291300001
    DAWSON, Anthony David
    Flat 21 Hillbrow
    Richmond Hill
    TW10 6BH Richmond
    Surrey
    Director
    Flat 21 Hillbrow
    Richmond Hill
    TW10 6BH Richmond
    Surrey
    United KingdomBritishChartered Accountant89317200001
    DUFFIELD, Stephen Leslie
    Jacknett Barn
    1820 Warwick Road Knowle
    B93 0DX Solihull
    West Midlands
    Director
    Jacknett Barn
    1820 Warwick Road Knowle
    B93 0DX Solihull
    West Midlands
    EnglandBritishCompany Director24487000002
    ELLSMORE, Mark Anthony
    Moor Cottage
    Eversley Centre
    RG27 0NB Hook
    Director
    Moor Cottage
    Eversley Centre
    RG27 0NB Hook
    BritishFinance Director58979090001
    FENWICK, Nathan
    Pleasant Rd.
    29708 Fort Mill
    4140
    South Carolina
    United States
    Director
    Pleasant Rd.
    29708 Fort Mill
    4140
    South Carolina
    United States
    United StatesAmericanCfo269881800001
    GUSTAVSSON, Paul
    Riverside Way
    Watchmoor Park
    GU15 3YL Camberley
    Building A
    Surrey
    United Kingdom
    Director
    Riverside Way
    Watchmoor Park
    GU15 3YL Camberley
    Building A
    Surrey
    United Kingdom
    SwedenSwedishDirector196421570001
    HINDS, Matthew Frank
    Riverside Way
    Watchmoor Park
    GU15 3YL Camberley
    Building A
    Surrey
    United Kingdom
    Director
    Riverside Way
    Watchmoor Park
    GU15 3YL Camberley
    Building A
    Surrey
    United Kingdom
    United KingdomBritishChief Financial Officer142613150005
    JONES, Evan Taylor
    Ash Lea
    Barbon
    LA6 2LW Kirby Lonsdale
    Cumbria
    Director
    Ash Lea
    Barbon
    LA6 2LW Kirby Lonsdale
    Cumbria
    BritishDirector40267750001
    KAHOFER, Karl
    Hillswood Drive
    Hillswood Business Park
    KT16 0RS Chertsey
    3000
    England
    Director
    Hillswood Drive
    Hillswood Business Park
    KT16 0RS Chertsey
    3000
    England
    United KingdomAustrianDirector121222160002
    LACIK, Alexander
    Riverside Way
    Watchmoor Park
    GU15 3YL Camberley
    Building A
    Surrey
    United Kingdom
    Director
    Riverside Way
    Watchmoor Park
    GU15 3YL Camberley
    Building A
    Surrey
    United Kingdom
    SwedenSwedishNone251669920001
    MARTON, Richard Egerton Christopher
    Capernwray
    6 Kier Park
    SL5 7DS Ascot
    Berkshire
    Director
    Capernwray
    6 Kier Park
    SL5 7DS Ascot
    Berkshire
    BritishDirector34653220001
    MCCASLIN, Stuart David
    Victoria House 27 Victoria Road
    B50 4AS Bidford On Avon
    Warwickshire
    Director
    Victoria House 27 Victoria Road
    B50 4AS Bidford On Avon
    Warwickshire
    EnglandBritishChartered Secretary1824650002
    NAGEL, Colin Michael
    47 The Boulevard
    Belle Vue Heights
    5050
    South Australia
    Director
    47 The Boulevard
    Belle Vue Heights
    5050
    South Australia
    AustralianDirector74475110001
    NAGEL, Markus
    Riverside Way
    Watchmoor Park
    GU15 3YL Camberley
    Building A
    Surrey
    United Kingdom
    Director
    Riverside Way
    Watchmoor Park
    GU15 3YL Camberley
    Building A
    Surrey
    United Kingdom
    United KingdomGermanDirector153942140004
    NOON, Rodney Ernest
    191 Martongate
    YO15 1DP Bridlington
    East Yorkshire
    Director
    191 Martongate
    YO15 1DP Bridlington
    East Yorkshire
    EnglandBritishManaging Director15300520002
    ROBERTSON, Douglas Grant
    Blackmore Grange
    Blackmore End
    WR8 0EE Hanley Swan
    Worcestershire
    Director
    Blackmore Grange
    Blackmore End
    WR8 0EE Hanley Swan
    Worcestershire
    EnglandBritishChartered Accountant123487130001
    SELWAY, Mark Wayne
    Flat 5-4
    5 South Frederick Street
    G1 1JG Glasgow
    Lanarkshire
    Director
    Flat 5-4
    5 South Frederick Street
    G1 1JG Glasgow
    Lanarkshire
    United KingdomAustralianDirector105098120001
    SKERTCHLY, Paul Clifford
    Hillswood Drive
    Hillswood Business Park
    KT16 0RS Chertsey
    3000
    England
    Director
    Hillswood Drive
    Hillswood Business Park
    KT16 0RS Chertsey
    3000
    England
    EnglandBritishCompany Director82622600002
    SMILEY, Patrick Joseph
    6 Knightlow Road
    Harborne
    B17 8QB Birmingham
    West Midlands
    Director
    6 Knightlow Road
    Harborne
    B17 8QB Birmingham
    West Midlands
    BritishChartered Accountant31109120001
    STAFFORD, Andrew John
    The Close
    The Village Green
    SN14 7DG Biddestone
    Wiltshire
    Director
    The Close
    The Village Green
    SN14 7DG Biddestone
    Wiltshire
    United KingdomBritishCompany Director125332580001
    STARKEY, Alan Rudolph
    Shoe Cottage
    Exton
    SO32 3NT Southampton
    Hampshire
    Director
    Shoe Cottage
    Exton
    SO32 3NT Southampton
    Hampshire
    BritishDirector14214170001
    STARKEY, Alan Rudolph
    Shoe Cottage
    Exton
    SO32 3NT Southampton
    Hampshire
    Director
    Shoe Cottage
    Exton
    SO32 3NT Southampton
    Hampshire
    BritishDirector14214170001
    THORNE, Raymond
    60 Silhill Hall Road
    B91 1JS Solihull
    West Midlands
    Director
    60 Silhill Hall Road
    B91 1JS Solihull
    West Midlands
    BritishChartered Accountant2756010001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de BRITAX INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Riverside Way
    Watchmoor Park
    GU15 3YL Camberley
    Building A
    Surrey
    United Kingdom
    06 abr 2016
    Riverside Way
    Watchmoor Park
    GU15 3YL Camberley
    Building A
    Surrey
    United Kingdom
    No
    Forma jurídicaLimited By Shares
    País de registroEngland And Wales
    Autoridad legalUnited Kingdom (England And Wales)
    Lugar de registroCompanies House
    Número de registro07435743
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.
    • La persona tiene el derecho, directa o indirectamente, de nombrar o destituir a la mayoría de la junta directiva de la empresa.

    ¿Tiene BRITAX INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    A registered charge
    Creado el 09 ene 2020
    Entregado el 17 ene 2020
    Pendiente
    Breve descripción
    Not applicable.
    La garantía flotante cubre todo:
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía flotante:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Cortland Capital Market Services Llc (As Security Agent)
    Transacciones
    • 17 ene 2020Registro de una carga (MR01)
    Debenture accession deed
    Creado el 24 feb 2011
    Entregado el 07 mar 2011
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee or any of the other secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personas con derecho
    • Commerzbank Ag, Luxembourg Branch (As Security Agent)
    Transacciones
    • 07 mar 2011Registro de un cargo (MG01)
    • 22 oct 2013Satisfacción de una carga (MR04)
    Security accession deed
    Creado el 20 oct 2005
    Entregado el 27 oct 2005
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from any charging company or any other obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC as Security Trustee for Itself and the Other Secured Parties
    Transacciones
    • 27 oct 2005Registro de un cargo (395)
    • 12 feb 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Share mortgage
    Creado el 20 oct 2005
    Entregado el 27 oct 2005
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company or any other obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    The mortgaged property. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC as Security Trustee for Itself and the Other Secured Parties (The Securityagent)
    Transacciones
    • 27 oct 2005Registro de un cargo (395)
    • 12 feb 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Equitable mortgage of shares
    Creado el 23 ago 2001
    Entregado el 10 sept 2001
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies then due for payment or which will or may become due for payment by the company to any of the security beneficiaries in connection with the guaranteed obligations and by the borrower to any of the security beneficiaries in connection with the finance documents
    Breve descripción
    The present security by way of equitable mortgage, the new rights existing at the date of the mortgage, all of the future security, the rights which arise after the date of the mortgage.
    Personas con derecho
    • Lehman Commercial Paper Inc.
    Transacciones
    • 10 sept 2001Registro de un cargo (395)
    • 26 oct 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Equitable mortgage of shares
    Creado el 23 ago 2001
    Entregado el 10 sept 2001
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies then due for payment or which will or may become due for payment by the company to any of the security beneficiaries in connection with the guaranteed obligations and by the borrower to any of the security beneficiaries in connection with the finance documents
    Breve descripción
    The present security by way of equitable mortgage, the new rights existing at the date of the mortgage, all of the future security, the rights which arise after the date of the mortgage. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Lehman Commercial Paper Inc
    Transacciones
    • 10 sept 2001Registro de un cargo (395)
    • 06 may 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Security accession deed between the company,seton house group limited (the "parent") and lehman commercial paper inc (the "security agent") supplemental to a debenture dated 4 july 2001
    Creado el 23 ago 2001
    Entregado el 31 ago 2001
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All money or liabilities due or to become due from any charging company (as defined) or any other obligor (as defined) to any secured party (as defined) under any finance document (as defined) on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Lehman Commercial Paper Inc.
    Transacciones
    • 31 ago 2001Registro de un cargo (395)
    • 26 oct 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Deed of charge
    Creado el 21 dic 1984
    Entregado el 10 ene 1985
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    First fixed charge all book debts and other debts now and from time to time due or owing to the company.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 10 ene 1985Registro de una carga

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0