REDSKY IT (593) LIMITED

REDSKY IT (593) LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Declaración anual
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaREDSKY IT (593) LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 01082593
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de REDSKY IT (593) LIMITED?

    • (7499) /

    ¿Dónde se encuentra REDSKY IT (593) LIMITED?

    Dirección de la sede social
    55 Colmore Row
    Birmingham
    B3 2AS West Midlands
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de REDSKY IT (593) LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    RAMESYS (AEC) LIMITED06 jun 200006 jun 2000
    SYNTECH (UK) LIMITED06 feb 199706 feb 1997
    SYNTECH COMPUTER SYSTEMS LIMITED02 jun 198702 jun 1987
    SOKENWICK LIMITED20 nov 197220 nov 1972

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de REDSKY IT (593) LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 jul 2007

    ¿Cuál es el estado de la última declaración anual para REDSKY IT (593) LIMITED?

    Declaración anual
    Última declaración anual

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para REDSKY IT (593) LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    GAZ2

    Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros

    3 páginas4.71

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 20 feb 2014

    5 páginas4.68

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 20 ago 2013

    5 páginas4.68

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 20 feb 2013

    5 páginas4.68

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 20 ago 2012

    5 páginas4.68

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 20 feb 2012

    5 páginas4.68

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 20 ago 2011

    5 páginas4.68

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 20 feb 2011

    5 páginas4.68

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 20 ago 2010

    5 páginas4.68

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 20 feb 2010

    5 páginas4.68

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 20 ago 2009

    5 páginas4.68

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 20 feb 2009

    5 páginas4.68

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 jul 2007

    5 páginasAA

    Declaración de solvencia

    3 páginas4.70

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    liquidation

    Acuerdo especial para la liquidación

    LRESSP

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    2 páginas600

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resoluciones

    Cash dividend appr 21/02/2008
    RES13

    legacy

    6 páginas363s
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    annual-return06 ago 2007

    legacy

    363(353)

    legacy

    2 páginas288a

    legacy

    2 páginas288a

    legacy

    1 páginas288b

    legacy

    1 páginas288b

    legacy

    1 páginas288b

    legacy

    1 páginas288b

    ¿Quiénes son los directivos de REDSKY IT (593) LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    HENWOOD, Julian Richard
    8 Brickyard Close
    CV7 7EN Balsall Common
    Warwickshire
    Secretario
    8 Brickyard Close
    CV7 7EN Balsall Common
    Warwickshire
    British65188860002
    MCFARLANE, James Douglas
    730 Eyremount Drive
    West Vancouver
    Bc V76 2a4
    Canada
    Director
    730 Eyremount Drive
    West Vancouver
    Bc V76 2a4
    Canada
    CanadaCanadianDirector118810110001
    COAKLEY, Calvin Lloyd
    44 Pentwyn
    Radyr
    CF15 8RE Cardiff
    Secretario
    44 Pentwyn
    Radyr
    CF15 8RE Cardiff
    British19312940002
    COSTER, Malcolm David
    Rivendell 46 Golfside
    South Cheam
    SM2 7EZ Sutton
    Surrey
    Secretario
    Rivendell 46 Golfside
    South Cheam
    SM2 7EZ Sutton
    Surrey
    BritishManager39034110001
    COTTRELL, Paul Alan
    16 Goldcrest Drive
    TN22 5QG Uckfield
    East Sussex
    Secretario
    16 Goldcrest Drive
    TN22 5QG Uckfield
    East Sussex
    BritishGroup Financial Controller13754300002
    DURRANT, Zoe Vivienne
    Beehive Cottage
    Radford Road, Rous Lench
    WR11 4UL Evesham
    Worcestershire
    Secretario
    Beehive Cottage
    Radford Road, Rous Lench
    WR11 4UL Evesham
    Worcestershire
    BritishCompany Secretary68141090001
    ELMS, Leighton William
    42 Porset Drive
    CF8 1PP Caerphilly
    Mid Glamorgan
    Secretario
    42 Porset Drive
    CF8 1PP Caerphilly
    Mid Glamorgan
    British13309540001
    BARNHOUSE, Terence
    2 St Medard Road
    BS28 4AY Wedmore
    Somerset
    Director
    2 St Medard Road
    BS28 4AY Wedmore
    Somerset
    BritishSales & Marketing Director48228710001
    BASHFORD, Howard
    Grovelands 22 Station Road
    Cholsey
    OX10 9PT Wallingford
    Oxfordshire
    Director
    Grovelands 22 Station Road
    Cholsey
    OX10 9PT Wallingford
    Oxfordshire
    BritishDirector68140690003
    BRADLEY, Michael John
    Vantage Point
    208 Henwick Road
    WR2 5PF Worcester
    Director
    Vantage Point
    208 Henwick Road
    WR2 5PF Worcester
    BritishCompany Director40818740003
    BRIDDON, Kenneth Carl
    Rose Farmhouse
    Village Road Waverton
    CH3 7QN Chester
    Cheshire
    Director
    Rose Farmhouse
    Village Road Waverton
    CH3 7QN Chester
    Cheshire
    BritishCompany Director76868400001
    CHAMBERS, Mark
    428 Goldington Road
    MK41 9NU Bedford
    Bedfordshire
    Director
    428 Goldington Road
    MK41 9NU Bedford
    Bedfordshire
    BritishDeputy Managing Director78433770004
    COSTER, Malcolm David
    Rivendell 46 Golfside
    South Cheam
    SM2 7EZ Sutton
    Surrey
    Director
    Rivendell 46 Golfside
    South Cheam
    SM2 7EZ Sutton
    Surrey
    EnglandBritishManager39034110001
    EARLEY, Martin John Raymond
    36 Briarmeadow Drive
    Thornhill
    CF4 9FB Cardiff
    South Glamorgan
    Director
    36 Briarmeadow Drive
    Thornhill
    CF4 9FB Cardiff
    South Glamorgan
    BritishCompany Director19312960001
    FULLER, Andrew Jonathan
    Woodland Park
    Whalley
    BB7 9UG Lancashire
    28
    Director
    Woodland Park
    Whalley
    BB7 9UG Lancashire
    28
    BritishDirector132077340001
    GRAHAM, Ross King
    Stourton Farm House
    Stourton
    CV36 5HG Shipston On Stour
    Warwickshire
    Director
    Stourton Farm House
    Stourton
    CV36 5HG Shipston On Stour
    Warwickshire
    United KingdomBritishCompany Director61733920001
    HOTSON, Crispian John
    1b King Street
    SW1Y 6QG London
    Director
    1b King Street
    SW1Y 6QG London
    BritishCompany Director97996100001
    JONES, Warren
    8 Bishops Close
    Whitchurch
    CF4 1NH Cardiff
    Director
    8 Bishops Close
    Whitchurch
    CF4 1NH Cardiff
    BritishOperations Manager59711890002
    LOCKYER, Stephen Charles
    13 Summerwood Close
    CF5 3QS Cardiff
    South Glamorgan
    Director
    13 Summerwood Close
    CF5 3QS Cardiff
    South Glamorgan
    BritishFinance Director67414890001
    LOMAX, John Kevin
    Hawling Manor
    Hawling
    GL54 5TA Cheltenham
    Gloucestershire
    Director
    Hawling Manor
    Hawling
    GL54 5TA Cheltenham
    Gloucestershire
    BritishCompany Director22190280002
    MATTHEW, Gordon John
    Rogers Lane
    Ettrington
    CV37 3TA Stratford Upon Avon
    Saracens Yard
    Warwickshire
    Director
    Rogers Lane
    Ettrington
    CV37 3TA Stratford Upon Avon
    Saracens Yard
    Warwickshire
    EnglandBritishDirector151547160001
    MCPHERSON, Ian
    Whitebrook
    NP6 3BA Llanvaches
    Chepstow
    Director
    Whitebrook
    NP6 3BA Llanvaches
    Chepstow
    BritishCompany Director47733900001
    MORGAN, Patrick Francis
    4 Church Bank
    Whaley Lane Whaley Bridge High Peak
    SK23 7RZ Stockport
    Cheshire
    Director
    4 Church Bank
    Whaley Lane Whaley Bridge High Peak
    SK23 7RZ Stockport
    Cheshire
    BritishDirector37486070003
    NORFORD, Craig
    167 Paddick Drive
    Earley
    RG6 4HG Reading
    Berkshire
    Director
    167 Paddick Drive
    Earley
    RG6 4HG Reading
    Berkshire
    BritishFinance Director78433720002
    O'LEARY, Michael Kevin
    Greenwood
    Wichenford
    WR6 6YB Worcester
    Worcestershire
    Director
    Greenwood
    Wichenford
    WR6 6YB Worcester
    Worcestershire
    EnglandBritishCompany Director129193560001
    PEEK, David Richard
    Nant Y Deri Began Road
    Michaelston Y Fedw
    CF3 6XL Cardiff
    Director
    Nant Y Deri Began Road
    Michaelston Y Fedw
    CF3 6XL Cardiff
    BritishCompany Director32453010001
    ROGERS, Christine Margaret
    Ty Cudyll
    Pen Y Waun, Pentyrch
    CF15 9SJ Cardiff
    South Glamorgan
    Director
    Ty Cudyll
    Pen Y Waun, Pentyrch
    CF15 9SJ Cardiff
    South Glamorgan
    BritishCompany Director66374680001
    SMITH, David Anthony Bradford
    7 Langland Villas
    Mumbles
    SA3 4NA Swansea
    West Glamorgan
    Director
    7 Langland Villas
    Mumbles
    SA3 4NA Swansea
    West Glamorgan
    BritishCompany Director13309590001
    SMITH, Dennis George, Dr
    10 St Quentins Close
    Llanblethian
    CF7 7EZ Cowbridge
    South Glamorgan
    Director
    10 St Quentins Close
    Llanblethian
    CF7 7EZ Cowbridge
    South Glamorgan
    BritishManagement Consultant37732060001
    SPRING, Simon Christopher
    1 Chestnut Close
    Middle Assendon
    RG9 6AY Henley On Thames
    Oxfordshire
    Director
    1 Chestnut Close
    Middle Assendon
    RG9 6AY Henley On Thames
    Oxfordshire
    BritishDirector2039620001
    SUSSENS, John Gilbert
    Blythe House 10 Grange Road
    Bidford On Avon
    B50 4BY Alcester
    Warwickshire
    Director
    Blythe House 10 Grange Road
    Bidford On Avon
    B50 4BY Alcester
    Warwickshire
    EnglandBritishCompany Director1442450002
    TAYLOR, David
    Honeywood Atch Lench Road
    Church Lench
    WR11 4UG Evesham
    Worcestershire
    Director
    Honeywood Atch Lench Road
    Church Lench
    WR11 4UG Evesham
    Worcestershire
    BritishChartered Accountant1439590001
    THOMAS, Clive Jeremy
    1 Hawkridge Cottage
    Hawkridge Hill
    RG18 9XA Frilsham Thatcham
    Berkshire
    Director
    1 Hawkridge Cottage
    Hawkridge Hill
    RG18 9XA Frilsham Thatcham
    Berkshire
    United KingdomBritishSales Director157829380001
    TOSH, Stephen Leonard
    3 Doddington Place
    Trallwn
    CF37 4LN Pontypridd
    Mid Glamorgan
    Director
    3 Doddington Place
    Trallwn
    CF37 4LN Pontypridd
    Mid Glamorgan
    BritishResearch & Development Directo74102060001
    WEIR, Robert James
    35 Blackhorse Lane
    SG4 9EG Hitchin
    Hertfordshire
    Director
    35 Blackhorse Lane
    SG4 9EG Hitchin
    Hertfordshire
    BritishSales And Marketing Director59711990001

    ¿Tiene REDSKY IT (593) LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Guarantee & debenture
    Creado el 21 dic 2000
    Entregado el 09 ene 2001
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 09 ene 2001Registro de un cargo (395)
    • 13 ago 2003Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Guarantee & debenture
    Creado el 27 ene 1999
    Entregado el 04 feb 1999
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee acting as security trustee for the beneficiaries (as therein defined) under or pursuant to the senior finance documents (as therein defined) and all monies due or owing to each beneficiary by each other company (except as a guarantor for the chargor giving this covenant) under or pursuant to the senior finance documents and on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Skandinaviska Enskilda Banken Ab (Publ)
    Transacciones
    • 04 feb 1999Registro de un cargo (395)
    • 06 feb 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Collateral debenture
    Creado el 17 ene 1994
    Entregado el 26 ene 1994
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from palm technology PLC to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • 3I Group PLC
    Transacciones
    • 26 ene 1994Registro de un cargo (395)
    • 11 mar 1997Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creado el 20 dic 1991
    Entregado el 24 dic 1991
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to a facility letter of even date not exceeding £150,000
    Breve descripción
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personas con derecho
    • Ryan International Limited
    Transacciones
    • 24 dic 1991Registro de un cargo (395)
    • 31 mar 1994Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 20 dic 1991
    Entregado el 24 dic 1991
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Bank of Wales PLC
    Transacciones
    • 24 dic 1991Registro de un cargo (395)
    • 11 mar 1997Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Guarantee & debenture
    Creado el 20 dic 1989
    Entregado el 05 ene 1989
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 05 ene 1989Registro de una carga
    Further guarantee & debenture
    Creado el 24 jun 1980
    Entregado el 01 jul 1980
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever.
    Breve descripción
    All that property, undertaking & assets charged by the principal deed.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 01 jul 1980Registro de una carga

    ¿Tiene REDSKY IT (593) LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    21 feb 2008Inicio de la liquidación
    16 ago 2014Fecha de disolución
    Liquidación voluntaria de socios
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Timothy Gerard Walsh
    Plumtree Court
    EC4A 4HT London
    Profesional
    Plumtree Court
    EC4A 4HT London
    Richard Victor Yerburgh Setchim
    Pricewaterhousecoopers Llp
    Plumtree Court
    EC4A 4HT London
    Profesional
    Pricewaterhousecoopers Llp
    Plumtree Court
    EC4A 4HT London

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0