MEPC INVESTMENTS LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | MEPC INVESTMENTS LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 01087866 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | Sí |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de MEPC INVESTMENTS LIMITED?
- Otro alquiler y explotación de bienes inmobiliarios propios o arrendados (68209) / Actividades inmobiliarias
¿Dónde se encuentra MEPC INVESTMENTS LIMITED?
| Dirección de la sede social | No. 1 Dorset Street SO18 2DP Southampton Hampshire |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de MEPC INVESTMENTS LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| METESTATES LIMITED | 10 ene 1986 | 10 ene 1986 |
| MEPC HOLBORN PROPERTIES LIMITED | 31 dic 1979 | 31 dic 1979 |
| MEPC-REED PROPERTIES LIMITED | 20 dic 1972 | 20 dic 1972 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de MEPC INVESTMENTS LIMITED?
| Vencido | Sí |
|---|---|
| Próximas cuentas | |
| Próximo período contable finaliza el | 31 dic 2015 |
| Próximas cuentas vencen el | 30 sept 2016 |
| Últimas cuentas | |
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2014 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para MEPC INVESTMENTS LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gaceta final disuelta tras la liquidación | 1 páginas | GAZ2 | ||||||||||
Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros | 6 páginas | 4.71 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de Lloyds Chambers 1 Portsoken Street London E1 8HZ a No. 1 Dorset Street Southampton Hampshire SO18 2DP el 03 jun 2016 | 2 páginas | AD01 | ||||||||||
Nombramiento de un liquidador voluntario | 2 páginas | 600 | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Declaración de solvencia | 3 páginas | 4.70 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 19 dic 2015 avec liste complète des actionnaires | 5 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2014 | 4 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 19 dic 2014 avec liste complète des actionnaires | 5 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2013 | 4 páginas | AA | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr David Leonard Grose el 29 ene 2014 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 19 dic 2013 avec liste complète des actionnaires | 5 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cambio de datos del director Ms Emily Ann Mousley el 11 ene 2013 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2012 | 4 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 19 dic 2012 avec liste complète des actionnaires | 5 páginas | AR01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2011 | 4 páginas | AA | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de * 4Th Floor Lloyds Chambers 1 Portsoken Street London E1 8LW* el 22 dic 2011 | 2 páginas | AD01 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 19 dic 2011 avec liste complète des actionnaires | 5 páginas | AR01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2010 | 4 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 19 dic 2010 avec liste complète des actionnaires | 5 páginas | AR01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr David Leonard Grose el 20 dic 2010 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Alasdair Evans como director | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2009 | 8 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 19 dic 2009 avec liste complète des actionnaires | 6 páginas | AR01 | ||||||||||
Cambio de datos del secretario Mepc Secretaries Limited el 21 dic 2009 | 2 páginas | CH04 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de MEPC INVESTMENTS LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEPC SECRETARIES LIMITED | Secretario corporativo | Floor Lloyds Chambers 1 Portsoken Street E1 8LW London 4th United Kingdom |
| 79708020003 | ||||||||||
| GROSE, David Leonard | Director | Dorset Street SO18 2DP Southampton No. 1 Hampshire | United Kingdom | British | 120479020004 | |||||||||
| MOUSLEY, Emily Ann | Director | Dorset Street SO18 2DP Southampton No. 1 Hampshire | England | British | 155262770003 | |||||||||
| LEE, John Philip Macarthur | Secretario | Flat 9 14 Marylebone Street W1M 7PR London | British | 32509900003 | ||||||||||
| PRICE, John Dewi Brychan | Secretario | 12 The Rise RH16 2TA Lindfield West Sussex | British | 3041640002 | ||||||||||
| ADDELSEE, John | Director | 15 Tower Rise TW9 2TS Richmond Surrey | British | 3831640001 | ||||||||||
| BATCHELOR, Peter Andrew | Director | Flat 269 North County Hall 1c Belvedere Road SE1 7GF London | British | 68594020002 | ||||||||||
| BRADY, James Michael | Director | 1 Cromwell Close AL4 9YE St Albans Hertfordshire | England | British | 3769730001 | |||||||||
| BURROWES, David William | Director | 60 Westwater Way OX11 7TY Didcot Oxfordshire | United Kingdom | British | 100504300001 | |||||||||
| CLARKE, Christopher John | Director | 8 Cranmer Close CM12 0YQ Billericay Essex | English | British | 22793920001 | |||||||||
| COURTAULD, Toby Augustine | Director | 45a Moreton Street SW1V 2NY London | British | 46882260003 | ||||||||||
| DAVIDSON, Gavin Arthur | Director | 3 Westfield Road SL6 7AU Maidenhead Berkshire | British | 59873500003 | ||||||||||
| DOHERTY, Bernard Alfred Peter | Director | 1 Gordon Cottages Dukes Lane W8 4JJ London | England | British | 3831400001 | |||||||||
| EAST, Stephen John | Director | White Ladies Birch Hill Shirley Hills CR0 5HT Surrey | England | British | 108586450001 | |||||||||
| ELLISON, Charles John | Director | Spinney End Chelford Road WA16 8LY Knutsford Cheshire | United Kingdom | British | 20524930001 | |||||||||
| EVANS, Alasdair David | Director | 8 Copsem Lane KT10 9EU Esher Treaton Mill Surrey | United Kingdom | British | 130019430001 | |||||||||
| GABBANI, Gordon James | Director | 16 Townfield Lane WA6 7RD Frodsham Cheshire | British | 32362140003 | ||||||||||
| HARROLD, Richard Anthony | Director | Hill House Farm Brandon Parva NR9 4DL Norwich Norfolk | British | 33048780001 | ||||||||||
| JOHNSON, Edward John | Director | 57 Park Road Chiswick W4 3EY London | British | 76145820001 | ||||||||||
| LEWIS, Gavin Andrew | Director | 38 Victoria Avenue KT6 5DW Surbiton Surrey | United Kingdom | British | 93017010003 | |||||||||
| MCGARRITY, Stewart | Director | Clearwell Cottage Boulters Lane SL6 8TJ Maidenhead Berkshire | British | 65801380001 | ||||||||||
| MONAGHAN, Kevin Peter | Director | Pendennis High Street, Long Wittenham OX14 4QJ Abingdon Oxon | England | British | 116273610001 | |||||||||
| MONIZ, Christopher Mario | Director | 26 The Avenue CR5 2BN Coulsdon Surrey | England | British | 3831690001 | |||||||||
| SHEPPARD, Colin George | Director | Moffatt Cottage Berry Lane WD3 5EU Chorleywood Hertfordshire | England | British | 213673820001 | |||||||||
| STRATTON, Carol Ann | Director | 127 Maidstone Road Ruxley Corner Foots Cray DA14 5HX Sidcup Kent | England | British | 79680570001 | |||||||||
| THOMPSON, Nathan James | Director | No 1 Elsynge Road Wandsworth SW18 2HW London | British | 43320980004 | ||||||||||
| TUCKEY, James Lane | Director | 95 Elgin Crescent W11 2JF London | United Kingdom | British | 35019240001 | |||||||||
| WARE, Robert Thomas Ernest | Director | Woodley Lodge Duffield Road RG5 4RL Woodley Berkshire | United Kingdom | British | 4779170003 | |||||||||
| WATTERS, Iain Russell | Director | Laurel Bank Poyle Lane SL1 8LA Burnham Slough Buckinghamshire | United Kingdom | British | 3717820002 | |||||||||
| WOOLLARD, Anthony Buckley | Director | 12 Catsey Woods WD2 3HS Bushey Hertfordshire | British | 30863740001 |
¿Tiene MEPC INVESTMENTS LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| Second supplemental trust deed | Creado el 13 oct 2000 Entregado el 16 oct 2000 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada In favour of the chargee £30, 000, 000 interest and all other monies intended to be secured by a trust deed dated 14 september 1982 and £70, 000, 000 interest and all other monies intended to be secured by a supplemental trust deed dated 12 january 1984 | |
Breve descripción F/H property at chineham business park chineham basingstoke hampshire t/n HP316566 HP397816 HP317682 HP173001 HP498388 HP423354 HP317683 with all buildings benefit of all agreements under the trust deed. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Supplemental trust deed | Creado el 13 abr 1989 Entregado el 19 abr 1989 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada £2,500,000 7% 1ST mortgage debenture stock 1985/90 & £500, 000 7 3/4% 1ST debenture stock due from the company to the chargee under the terms of the principal deed dated 21.6.1960 and the deeds supplemental thereto. | |
Breve descripción F/H property 8 storeup gate, london. Title no ngl 366573 with all buildings, fixtures, plant & machinery. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Deed of covenant | Creado el 17 nov 1988 Adquirido el 17 nov 1988 Entregado el 21 nov 1988 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada £5,000,000 5 3/4% first mortgage debenture stock | |
Breve descripción 6/22 (even numbers) eccleston street and 77/79 ebury street london SW1 (title no: ngl 393550). | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Supplemental trust deed | Creado el 12 ene 1984 Adquirido el 30 mar 1988 Entregado el 13 abr 1988 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada £70,000 | |
Breve descripción F/H land & buildings k/a - 41/65A alderley rd, wilmslow, cheshire... See doc for other details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Supplemental trust deed | Creado el 12 ene 1984 Entregado el 13 ene 1984 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada £30,000,000 12% first mortgage debenture stock 2017 of mepc PLC and £70,000,000 10 3/4% first mortgage debenture stock 2024 of mepc PLC | |
Breve descripción Hulton house, 161 to 166 fleet street and builder house, 1 to 3 pemberton row, london EC4 title no. Ngl 326349 blackfriars house, 19 new bridge street, ldon EC4TITLE no 233927 together with plant machinery fixtures implements and utensils. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Trust deed | Creado el 14 sept 1982 Adquirido el 30 mar 1988 Entregado el 13 abr 1988 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada £30,000 | |
Breve descripción F/H land & buildings k/a - 41/65 a alderley rd, wilmslow, cheshire. See doc for other details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
¿Tiene MEPC INVESTMENTS LIMITED algún caso de insolvencia?
| Número de expediente | Fechas | Tipo | Profesionales | Otro | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Liquidación voluntaria de socios |
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0