LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE PLC

LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE PLC

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaLIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE PLC
    Estado de la empresaConvertida/Cerrada
    Forma jurídicaSociedad anónima cotizada
    Número de empresa 01088268
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE PLC?

    • Seguros no de vida (65120) / Actividades financieras y de seguros

    ¿Dónde se encuentra LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE PLC?

    Dirección de la sede social
    20 Fenchurch Street
    EC3M 3AW London
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE PLC?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE LIMITED30 sept 200330 sept 2003
    LIBERTY MUTUAL INSURANCE COMPANY (U.K.) LIMITED20 dic 199120 dic 1991
    LIBERTY MUTUAL INSURANCE COMPANY(MASSACHUSETS)LIMITED21 dic 197221 dic 1972

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE PLC?

    Vencido
    Próximas cuentas
    Próximo período contable finaliza el31 dic 2018
    Próximas cuentas vencen el30 jun 2019
    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2017

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE PLC?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Diversos hipotecarios para la garantía

    This is not a charge document. On 18TH July 2018 the company converted to a societas euroapea. Previous filings for this is company including charges were filed when the company was a PLC 1088268. The PLC record includes charges registered before 18/07/2018 which can be viewed on the mortgage register.
    1 páginasMORT MISC

    Estado de capital tras una asignación de acciones el 05 jul 2018

    • Capital: USD 290,090,782
    • Capital: EUR 120,139.20
    4 páginasSH01

    legacy

    1 páginasCLOMERGE

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resolución de eliminación de derechos de suscripción preferente

    RES11
    capital

    Resolución de asignación de valores

    RES10

    Declaración de confirmación presentada el 03 jun 2018 con actualizaciones

    4 páginasCS01

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resoluciones

    Draft terms of merger 23/04/2018
    RES13

    legacy

    59 páginasDTOM

    Bilan

    69 páginasBS

    Informe del auditor

    1 páginasAUDR

    Declaración del auditor

    1 páginasAUDS

    Certificado de re-registro de Privado a Compañía Pública Limitada

    1 páginasCERT5

    Re-registro del Memorándum y Estatutos

    39 páginasMAR

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    incorporation

    Resolución de re-registro

    RES02

    Re-registro de una sociedad privada a una sociedad anónima

    5 páginasRR01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2017

    69 páginasAA

    Cese del nombramiento de Gordon James Mcburney como director el 26 feb 2018

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Francis William Robinson como director el 22 feb 2018

    1 páginasTM01

    Redenominación de acciones. Estado de capital 07 feb 2018

    • Capital: USD 290,090,781
    • Capital: EUR 120,139.20
    4 páginasSH14

    Detalles de la variación de los derechos vinculados a las acciones

    2 páginasSH10

    Cambio de nombre o denominación de la clase de acciones

    2 páginasSH08

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resolución para redenominar acciones

    RES 17

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resolución de variación de los derechos o del nombre de las acciones

    RES12

    Cese del nombramiento de Christopher Locke Peirce como director el 24 ene 2018

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mr Philip Hobbs como director el 11 dic 2017

    2 páginasAP01

    Estado de capital tras una asignación de acciones el 31 oct 2017

    • Capital: USD 290,239,101
    3 páginasSH01

    ¿Quiénes son los directivos de LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE PLC?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    CASSIDY, Joseph Marcus
    Fenchurch Street
    EC3M 3AW London
    20
    Secretario
    Fenchurch Street
    EC3M 3AW London
    20
    205970820001
    DUNN, John Anthony Roberts
    Fenchurch Street
    EC3M 3AW London
    20
    United Kingdom
    Director
    Fenchurch Street
    EC3M 3AW London
    20
    United Kingdom
    EnglandBritish76557950005
    HANKS, Christopher Douglas
    Fenchurch Street
    EC3M 3AW London
    20
    United Kingdom
    Director
    Fenchurch Street
    EC3M 3AW London
    20
    United Kingdom
    EnglandBritish57313200001
    HOBBS, Philip Anthony
    Fenchurch Street
    EC3M 3AW London
    20
    Director
    Fenchurch Street
    EC3M 3AW London
    20
    United KingdomBritish241435220001
    MOORE, Matthew
    Fenchurch Street
    EC3M 3AW London
    20
    United Kingdom
    Director
    Fenchurch Street
    EC3M 3AW London
    20
    United Kingdom
    EnglandBritish137575280003
    NICHOLSON, Keith
    Fenchurch Street
    EC3M 3AW London
    20
    United Kingdom
    Director
    Fenchurch Street
    EC3M 3AW London
    20
    United Kingdom
    EnglandBritish187289780001
    REID, Richard David George, Dr
    Fenchurch Street
    EC3M 3AW London
    20
    United Kingdom
    Director
    Fenchurch Street
    EC3M 3AW London
    20
    United Kingdom
    EnglandBritish179271740001
    DAVENPORT, Nigel James
    3rd Floor
    2 Minster Court
    EC3R 7YE Mincing Lane
    London
    Secretario
    3rd Floor
    2 Minster Court
    EC3R 7YE Mincing Lane
    London
    British154931920001
    OBRIEN, Patrick Joseph
    3rd Floor
    2 Minster Court
    EC3R 7YE Mincing Lane
    London
    Secretario
    3rd Floor
    2 Minster Court
    EC3R 7YE Mincing Lane
    London
    Irish82463340002
    RYAN, Kevin Keith
    44 Seaton Road
    DA16 1DU Welling
    Kent
    Secretario
    44 Seaton Road
    DA16 1DU Welling
    Kent
    British12487220001
    TURNER, David Charles
    Fenchurch Street
    EC3M 3AW London
    20
    United Kingdom
    Secretario
    Fenchurch Street
    EC3M 3AW London
    20
    United Kingdom
    185252340001
    BODKIN, Mark Thomas
    24 Barham Road
    SW20 0ET London
    Director
    24 Barham Road
    SW20 0ET London
    British43143740001
    COMERFORD, Jane Mary
    53 Bishopsthorpe Road
    Sydenham
    SE26 4PA London
    Director
    53 Bishopsthorpe Road
    Sydenham
    SE26 4PA London
    British61252820001
    CONDRIN, James Paul 111
    8 Pettee's Lane
    Walpole
    Massachusetts 02081
    Usa
    Director
    8 Pettee's Lane
    Walpole
    Massachusetts 02081
    Usa
    Usa59754510001
    COUNTRYMAN, Gary Lee
    111 Hager Street
    Marlboro
    FOREIGN Massachusetts
    Usa
    Director
    111 Hager Street
    Marlboro
    FOREIGN Massachusetts
    Usa
    American12487230001
    FORSYTHE, Daniel Terence Niall
    3rd Floor
    2 Minster Court
    EC3R 7YE Mincing Lane
    London
    Director
    3rd Floor
    2 Minster Court
    EC3R 7YE Mincing Lane
    London
    UsaBritish72930680001
    GALSWORTHY, John Ronald
    118 Andrewes House
    Barbican
    EC2Y 8AY London
    Director
    118 Andrewes House
    Barbican
    EC2Y 8AY London
    British39248830001
    GIBBONS, Christopher Adney Walter
    48 Ravenscourt Gardens
    W6 0TU London
    Director
    48 Ravenscourt Gardens
    W6 0TU London
    British18129450002
    GRUHL, Robert Herbert
    22 Pinecliff Drive
    01945 Marblehead
    Massachusetts
    Usa
    Director
    22 Pinecliff Drive
    01945 Marblehead
    Massachusetts
    Usa
    American53338530001
    HAZELL, Richard Dennis
    Hunters Lake Street
    TN20 6PS Mayfield
    East Sussex
    Director
    Hunters Lake Street
    TN20 6PS Mayfield
    East Sussex
    United KingdomBritish3162840001
    HAZELL, Simon Richard
    47a Birling Road
    TN2 5LY Tunbridge Wells
    Kent
    Director
    47a Birling Road
    TN2 5LY Tunbridge Wells
    Kent
    British61252880001
    KELLY, Edmund
    8 Carlyn Lane
    FOREIGN Simsbury
    Connecticut 06089
    Usa
    Director
    8 Carlyn Lane
    FOREIGN Simsbury
    Connecticut 06089
    Usa
    Us28920220001
    MALONEY, Therese Adele
    770 Boylston Street
    Apartment 5f
    Boston
    Massachusetts 01945
    Director
    770 Boylston Street
    Apartment 5f
    Boston
    Massachusetts 01945
    Us Citizen37830530001
    MCBURNEY, Gordon James
    Fenchurch Street
    EC3M 3AW London
    20
    United Kingdom
    Director
    Fenchurch Street
    EC3M 3AW London
    20
    United Kingdom
    United StatesBritish53311520002
    MCCAMMON, John Frank
    3rd Floor
    2 Minster Court
    EC3R 7YE Mincing Lane
    London
    Director
    3rd Floor
    2 Minster Court
    EC3R 7YE Mincing Lane
    London
    EnglandBritish174798240001
    MCKENZIE, Malcolm Gordon
    3rd Floor
    2 Minster Court
    EC3R 7YE Mincing Lane
    London
    Director
    3rd Floor
    2 Minster Court
    EC3R 7YE Mincing Lane
    London
    EnglandBritish6817630004
    METCALF, Nicholas John
    Fenchurch Street
    EC3M 3AW London
    20
    United Kingdom
    Director
    Fenchurch Street
    EC3M 3AW London
    20
    United Kingdom
    EnglandBritish125738050001
    OATES, David Richard
    3rd Floor
    2 Minster Court
    EC3R 7YE Mincing Lane
    London
    Director
    3rd Floor
    2 Minster Court
    EC3R 7YE Mincing Lane
    London
    United KingdomBritish61252830002
    OBRIEN, Patrick Joseph
    3rd Floor
    2 Minster Court
    EC3R 7YE Mincing Lane
    London
    Director
    3rd Floor
    2 Minster Court
    EC3R 7YE Mincing Lane
    London
    IrelandIrish82463340002
    PEIRCE, Christopher Locke
    Fenchurch Street
    EC3M 3AW London
    20
    United Kingdom
    Director
    Fenchurch Street
    EC3M 3AW London
    20
    United Kingdom
    UsaAmerican146597340001
    PRINCE, David John
    3rd Floor
    2 Minster Court
    EC3R 7YE Mincing Lane
    London
    Director
    3rd Floor
    2 Minster Court
    EC3R 7YE Mincing Lane
    London
    United KingdomBritish76301790001
    PRYKE, John William
    Ridgetop 188 Hanging Hill Lane
    Hutton
    CM13 2QH Brentwood
    Essex
    Director
    Ridgetop 188 Hanging Hill Lane
    Hutton
    CM13 2QH Brentwood
    Essex
    UkBritish10567650001
    RAMEY, Thomas Crawford
    140 Brattle Street
    Cambridge
    Massachusetts 02138
    Usa
    Director
    140 Brattle Street
    Cambridge
    Massachusetts 02138
    Usa
    American77428690001
    ROBINSON, Francis William
    Fenchurch Street
    EC3M 3AW London
    20
    United Kingdom
    Director
    Fenchurch Street
    EC3M 3AW London
    20
    United Kingdom
    UsaAmerican175225240002
    ROCKS, Sean Patrick
    Fenchurch Street
    EC3M 3AW London
    20
    United Kingdom
    Director
    Fenchurch Street
    EC3M 3AW London
    20
    United Kingdom
    EnglandBritish127657900001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE PLC?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Liberty Uk And Europe Holdings Limited
    Fenchurch Street
    EC3M 3AW London
    20
    England
    06 abr 2016
    Fenchurch Street
    EC3M 3AW London
    20
    England
    No
    Forma jurídicaCompany Limited By Shares
    País de registroEngland
    Autoridad legalCompanies Act 2006
    Lugar de registroCompanies House England & Wales
    Número de registro07062171
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.
    • La persona tiene el derecho, directa o indirectamente, de nombrar o destituir a la mayoría de la junta directiva de la empresa.

    ¿Tiene LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE PLC alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    A registered charge
    Creado el 31 dic 2014
    Entregado el 15 ene 2015
    Pendiente
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Citibank, N.A. London Branch
    Transacciones
    • 15 ene 2015Registro de una carga (MR01)
    A registered charge
    Creado el 09 abr 2014
    Entregado el 23 abr 2014
    Pendiente
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Arch Insurance Company (Europe) Limited
    Transacciones
    • 23 abr 2014Registro de una carga (MR01)
    Pledge agreement
    Creado el 06 sept 2010
    Entregado el 11 sept 2010
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    All right title and interest in the collateral being the account the securities and any instruments or other financial assets all additional investment property see image for full details.
    Personas con derecho
    • Citibank N.A. London Branch
    Transacciones
    • 11 sept 2010Registro de un cargo (MG01)
    Deposit agreement to secure own liabilities
    Creado el 15 oct 2004
    Entregado el 22 oct 2004
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    The deposit and all such rights to the repayment thereof. The deposit means the debt or debts which were then or thereafter owing to the company on all deposits with the bank's treasury division from time to time in the name of the bank re the depositor (in whatever currency denominated). All interest (if any) then owing or thereafter to become owing in respect of any such account(s) or deposit(s) including the interest.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transacciones
    • 22 oct 2004Registro de un cargo (395)
    Securities pledge agreement
    Creado el 18 dic 2002
    Entregado el 07 ene 2003
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    All of the company's rights, title and interest in the pledged collateral. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Fleet National Bank
    Transacciones
    • 07 ene 2003Registro de un cargo (395)
    Deposit agreement to secure own liabilities
    Creado el 17 jun 2002
    Entregado el 19 jun 2002
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    All deposits with the bank's treasury division in the name of the bank re the company in whatever currency denominated.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transacciones
    • 19 jun 2002Registro de un cargo (395)
    Deposit agreement to secure own liabilities
    Creado el 29 jun 2001
    Entregado el 20 jul 2001
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from creechurch dedicated limited to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    All such rights to the repayment of the deposit as the company then had under the terms upon which the deposit was made and the provisions contained in the agreement. The account with the bank denominated in sterling designated creechurch. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transacciones
    • 20 jul 2001Registro de un cargo (395)
    • 18 mar 2003Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Deposit agreement to secure own liabilities
    Creado el 23 dic 1998
    Entregado el 29 dic 1998
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    All such rights to the repayment of the deposit as the company then had under the terms upon which the deposit was made and the provisions contained in the agreement. Account number lbrelibuut. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Lloyds Bank PLC
    Transacciones
    • 29 dic 1998Registro de un cargo (395)
    A reinsurance deposit agreement
    Creado el 30 ene 1989
    Entregado el 02 feb 1989
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    All monies at the date of the reinsurance deposit agreement or at any time thereafter during the subsistence of the security standing to the credit of. 1) each reinsurance deposit or other account with the bank. 2) any account opened by the bank any other account referred to in clause 13 of the reinsurance deposit agreement and in each case all entitlements to interest and other rights and benefits accruing to or arising in connection with such monies.
    Personas con derecho
    • Citibank N.A.
    Transacciones
    • 02 feb 1989Registro de un cargo (395)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0