BROUGHTON CONTROLS LIMITED
Visión general
Nombre de la empresa | BROUGHTON CONTROLS LIMITED |
---|---|
Estado de la empresa | Disuelta |
Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
Número de empresa | 01089363 |
Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
Fecha de constitución | |
Fecha de cese |
Resumen
Tiene PSCs súper seguros | No |
---|---|
Tiene gravámenes | Sí |
Tiene historial de insolvencia | No |
La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de BROUGHTON CONTROLS LIMITED?
- Empresa inactiva (99999) / Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales
¿Dónde se encuentra BROUGHTON CONTROLS LIMITED?
Dirección de la sede social | Apex Building 1 Water Vole Way DN4 5JP Doncaster England |
---|---|
Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de BROUGHTON CONTROLS LIMITED?
Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
---|---|---|
STEVMORE LIMITED | 02 ene 1973 | 02 ene 1973 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de BROUGHTON CONTROLS LIMITED?
Últimas cuentas | |
---|---|
Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2021 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para BROUGHTON CONTROLS LIMITED?
Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 1 páginas | DS01 | ||||||||||||||
Cese del nombramiento de Jonathan Hamer Broughton como director el 17 jun 2022 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de Carr Hill Herons Way Balby Doncaster DN4 8WA England a Apex Building 1 Water Vole Way Doncaster DN4 5JP el 21 jun 2022 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2021 | 10 páginas | AA | ||||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 18 ene 2022 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2020 | 10 páginas | AA | ||||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 18 ene 2021 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||||||||||||||
Modification des détails de Crh Fencing & Security Group (Uk) Ltd en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 07 oct 2019 | 2 páginas | PSC05 | ||||||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2019 | 10 páginas | AA | ||||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 18 ene 2020 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||||||
Resoluciones Resolutions | 3 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Cese del nombramiento de Michael Wightman como director el 26 sept 2019 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2018 | 16 páginas | AA | ||||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 18 ene 2019 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2017 | 16 páginas | AA | ||||||||||||||
Cese del nombramiento de Cameron David William Burnett como director el 25 may 2018 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 18 ene 2018 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de 33 Stakehill Industrial Estate Middleton Manchester M24 2RW a Carr Hill Herons Way Balby Doncaster DN4 8WA el 27 feb 2018 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||||||
Nombramiento de Mr Cameron David William Burnett como director el 04 dic 2017 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||||||
Cese del nombramiento de Andrew Kenneth Peach como director el 15 sept 2017 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||
Cese del nombramiento de Andrew Kenneth Peach como secretario el 15 sept 2017 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||||||
Cese del nombramiento de Andrew Kenneth Peach como secretario el 15 sept 2017 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2016 | 15 páginas | AA | ||||||||||||||
¿Quiénes son los directivos de BROUGHTON CONTROLS LIMITED?
Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RABOT, Gilles | Director | 1 Water Vole Way DN4 5JP Doncaster Apex Building England | Netherlands | French | Director | 201716350001 | ||||
BROUGHTON, Dorothy Anne | Secretario | Tame Vale House Range Lane OL3 5SA Denshaw, Oldham Lancashire | English | 14265450002 | ||||||
CHADWICK, Philip | Secretario | Stakehill Industrial Estate Middleton M24 2RW Manchester 33 England | British | Chartered Accountant | 66886670002 | |||||
DINSLEY, George Paul | Secretario | The Beeches 170 Dickens Lane Poynton SK12 1NU Stockport Cheshire | British | Accountant | 45881950002 | |||||
PEACH, Andrew Kenneth | Secretario | Stakehill Industrial Estate Middleton M24 2RW Manchester 33 | 218998790001 | |||||||
BROUGHTON, Dorothy Anne | Director | Tame Vale House Range Lane OL3 5SA Denshaw, Oldham Lancashire | English | Company Secretary | 14265450002 | |||||
BROUGHTON, Eric | Director | Tamevale House Range Lane Denshaw OL3 5SA Oldham Lancashire | English | Managing Director | 12263850002 | |||||
BROUGHTON, Jonathan Hamer | Director | 1 Water Vole Way DN4 5JP Doncaster Apex Building England | United Kingdom | British | Company Director | 109768740001 | ||||
BURNETT, Cameron David William | Director | Herons Way Balby DN4 8WA Doncaster Carr Hill South Yorkshire England | England | British | Country Manager Uk | 190998110001 | ||||
CHADWICK, Philip | Director | Stakehill Industrial Estate Middleton M24 2RW Manchester 33 England | England | British | Financial Director | 66886670002 | ||||
DICKMAN, Barry Scot | Director | Stakehill Industrial Estate Middleton M24 2RW Manchester 33 England | United Kingdom | British | Sales Director | 75250520001 | ||||
GOODE, Laurence Piers | Director | Stakehill Industrial Estate Middleton M24 2RW Manchester 33 England | United Kingdom | British | Managing Director | 66109460001 | ||||
KELLY, Roger Grant | Director | Stakehill Industrial Estate Middleton M24 2RW Manchester 33 England | United Kingdom | British | Company Director | 67569120001 | ||||
KEYWORTH, Stanley John | Director | 18 Landsdowne Crescent WR14 2AW Malvern Worcestershire | England | British | Director | 75121880002 | ||||
PEACH, Andrew Kenneth | Director | Stakehill Industrial Estate Middleton M24 2RW Manchester 33 | United Kingdom | British | Managing Director | 42769440002 | ||||
THOMAS, Philip Kenyon | Director | The Rydings 4 Hill Grove HD3 3TL Huddersfield West Yorkshire | British | Director | 14692390001 | |||||
TOWERS, Simon Andrew | Director | Stakehill Industrial Estate Middleton M24 2RW Manchester 33 England | England | British | Company Director | 41657420002 | ||||
VALLELY, Anthony William | Director | Hulme Hall Avenue SK8 6LN Cheadle Hulme 30 Cheshire | England | British | Financial Director | 138990030001 | ||||
VAN SCHIJNDEL, Gerardus Johannes Cornelius Theresia | Director | Delmerweg 33 5037 Gj Tilburg Netherlands | Netherlands | Dutch | Director | 85810500001 | ||||
WIGHTMAN, Michael | Director | Herons Way Balby DN4 8WA Doncaster Carr Hill England | Northern Ireland | British | Director | 144988980001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de BROUGHTON CONTROLS LIMITED?
Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heras Perimeter Protection Limited | 06 abr 2016 | Herons Way Balby DN4 8WA Doncaster Herons Way England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
|
¿Tiene BROUGHTON CONTROLS LIMITED alguna carga?
Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
---|---|---|---|---|
Debenture | Creado el 17 ago 1999 Entregado el 26 ago 1999 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Legal charge | Creado el 17 ago 1999 Entregado el 26 ago 1999 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Land and buildings on the east side of shaw road oldham t/n's GM538197, LA296148, OL7661 and GM200732. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Legal charge | Creado el 16 nov 1987 Entregado el 19 nov 1987 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción F/H / l/h property k/a or being land and buildings on shaw road oldham greater manchester title no:- la 296148 ol 7661 gm 200732 with all buildings and fixtures thereon the goodwill of the business. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0