BROUGHTON CONTROLS LIMITED

BROUGHTON CONTROLS LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaBROUGHTON CONTROLS LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 01089363
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de BROUGHTON CONTROLS LIMITED?

    • Empresa inactiva (99999) / Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales

    ¿Dónde se encuentra BROUGHTON CONTROLS LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Apex Building
    1 Water Vole Way
    DN4 5JP Doncaster
    England
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de BROUGHTON CONTROLS LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    STEVMORE LIMITED02 ene 197302 ene 1973

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de BROUGHTON CONTROLS LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2021

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para BROUGHTON CONTROLS LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    1 páginasDS01

    Cese del nombramiento de Jonathan Hamer Broughton como director el 17 jun 2022

    1 páginasTM01

    Domicilio social registrado cambiado de Carr Hill Herons Way Balby Doncaster DN4 8WA England a Apex Building 1 Water Vole Way Doncaster DN4 5JP el 21 jun 2022

    1 páginasAD01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2021

    10 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 18 ene 2022 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2020

    10 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 18 ene 2021 con actualizaciones

    4 páginasCS01

    Modification des détails de Crh Fencing & Security Group (Uk) Ltd en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 07 oct 2019

    2 páginasPSC05

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2019

    10 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 18 ene 2020 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Resoluciones

    Resolutions
    3 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    incorporation

    Resolución de modificación de los Artículos de Asociación

    RES01
    incorporation

    Resolución de modificación de los Artículos de Asociación

    RES01

    Cese del nombramiento de Michael Wightman como director el 26 sept 2019

    1 páginasTM01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2018

    16 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 18 ene 2019 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2017

    16 páginasAA

    Cese del nombramiento de Cameron David William Burnett como director el 25 may 2018

    1 páginasTM01

    Declaración de confirmación presentada el 18 ene 2018 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Domicilio social registrado cambiado de 33 Stakehill Industrial Estate Middleton Manchester M24 2RW a Carr Hill Herons Way Balby Doncaster DN4 8WA el 27 feb 2018

    1 páginasAD01

    Nombramiento de Mr Cameron David William Burnett como director el 04 dic 2017

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Andrew Kenneth Peach como director el 15 sept 2017

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Andrew Kenneth Peach como secretario el 15 sept 2017

    1 páginasTM02

    Cese del nombramiento de Andrew Kenneth Peach como secretario el 15 sept 2017

    1 páginasTM02

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2016

    15 páginasAA

    ¿Quiénes son los directivos de BROUGHTON CONTROLS LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    RABOT, Gilles
    1 Water Vole Way
    DN4 5JP Doncaster
    Apex Building
    England
    Director
    1 Water Vole Way
    DN4 5JP Doncaster
    Apex Building
    England
    NetherlandsFrenchDirector201716350001
    BROUGHTON, Dorothy Anne
    Tame Vale House
    Range Lane
    OL3 5SA Denshaw, Oldham
    Lancashire
    Secretario
    Tame Vale House
    Range Lane
    OL3 5SA Denshaw, Oldham
    Lancashire
    English14265450002
    CHADWICK, Philip
    Stakehill Industrial Estate
    Middleton
    M24 2RW Manchester
    33
    England
    Secretario
    Stakehill Industrial Estate
    Middleton
    M24 2RW Manchester
    33
    England
    BritishChartered Accountant66886670002
    DINSLEY, George Paul
    The Beeches 170 Dickens Lane
    Poynton
    SK12 1NU Stockport
    Cheshire
    Secretario
    The Beeches 170 Dickens Lane
    Poynton
    SK12 1NU Stockport
    Cheshire
    BritishAccountant45881950002
    PEACH, Andrew Kenneth
    Stakehill Industrial Estate
    Middleton
    M24 2RW Manchester
    33
    Secretario
    Stakehill Industrial Estate
    Middleton
    M24 2RW Manchester
    33
    218998790001
    BROUGHTON, Dorothy Anne
    Tame Vale House
    Range Lane
    OL3 5SA Denshaw, Oldham
    Lancashire
    Director
    Tame Vale House
    Range Lane
    OL3 5SA Denshaw, Oldham
    Lancashire
    EnglishCompany Secretary14265450002
    BROUGHTON, Eric
    Tamevale House
    Range Lane Denshaw
    OL3 5SA Oldham
    Lancashire
    Director
    Tamevale House
    Range Lane Denshaw
    OL3 5SA Oldham
    Lancashire
    EnglishManaging Director12263850002
    BROUGHTON, Jonathan Hamer
    1 Water Vole Way
    DN4 5JP Doncaster
    Apex Building
    England
    Director
    1 Water Vole Way
    DN4 5JP Doncaster
    Apex Building
    England
    United KingdomBritishCompany Director109768740001
    BURNETT, Cameron David William
    Herons Way
    Balby
    DN4 8WA Doncaster
    Carr Hill
    South Yorkshire
    England
    Director
    Herons Way
    Balby
    DN4 8WA Doncaster
    Carr Hill
    South Yorkshire
    England
    EnglandBritishCountry Manager Uk190998110001
    CHADWICK, Philip
    Stakehill Industrial Estate
    Middleton
    M24 2RW Manchester
    33
    England
    Director
    Stakehill Industrial Estate
    Middleton
    M24 2RW Manchester
    33
    England
    EnglandBritishFinancial Director66886670002
    DICKMAN, Barry Scot
    Stakehill Industrial Estate
    Middleton
    M24 2RW Manchester
    33
    England
    Director
    Stakehill Industrial Estate
    Middleton
    M24 2RW Manchester
    33
    England
    United KingdomBritishSales Director75250520001
    GOODE, Laurence Piers
    Stakehill Industrial Estate
    Middleton
    M24 2RW Manchester
    33
    England
    Director
    Stakehill Industrial Estate
    Middleton
    M24 2RW Manchester
    33
    England
    United KingdomBritishManaging Director66109460001
    KELLY, Roger Grant
    Stakehill Industrial Estate
    Middleton
    M24 2RW Manchester
    33
    England
    Director
    Stakehill Industrial Estate
    Middleton
    M24 2RW Manchester
    33
    England
    United KingdomBritishCompany Director67569120001
    KEYWORTH, Stanley John
    18 Landsdowne Crescent
    WR14 2AW Malvern
    Worcestershire
    Director
    18 Landsdowne Crescent
    WR14 2AW Malvern
    Worcestershire
    EnglandBritishDirector75121880002
    PEACH, Andrew Kenneth
    Stakehill Industrial Estate
    Middleton
    M24 2RW Manchester
    33
    Director
    Stakehill Industrial Estate
    Middleton
    M24 2RW Manchester
    33
    United KingdomBritishManaging Director42769440002
    THOMAS, Philip Kenyon
    The Rydings 4 Hill Grove
    HD3 3TL Huddersfield
    West Yorkshire
    Director
    The Rydings 4 Hill Grove
    HD3 3TL Huddersfield
    West Yorkshire
    BritishDirector14692390001
    TOWERS, Simon Andrew
    Stakehill Industrial Estate
    Middleton
    M24 2RW Manchester
    33
    England
    Director
    Stakehill Industrial Estate
    Middleton
    M24 2RW Manchester
    33
    England
    EnglandBritishCompany Director41657420002
    VALLELY, Anthony William
    Hulme Hall Avenue
    SK8 6LN Cheadle Hulme
    30
    Cheshire
    Director
    Hulme Hall Avenue
    SK8 6LN Cheadle Hulme
    30
    Cheshire
    EnglandBritishFinancial Director138990030001
    VAN SCHIJNDEL, Gerardus Johannes Cornelius Theresia
    Delmerweg 33 5037 Gj
    Tilburg
    Netherlands
    Director
    Delmerweg 33 5037 Gj
    Tilburg
    Netherlands
    NetherlandsDutchDirector85810500001
    WIGHTMAN, Michael
    Herons Way
    Balby
    DN4 8WA Doncaster
    Carr Hill
    England
    Director
    Herons Way
    Balby
    DN4 8WA Doncaster
    Carr Hill
    England
    Northern IrelandBritishDirector144988980001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de BROUGHTON CONTROLS LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Herons Way
    Balby
    DN4 8WA Doncaster
    Herons Way
    England
    06 abr 2016
    Herons Way
    Balby
    DN4 8WA Doncaster
    Herons Way
    England
    No
    Forma jurídicaLimited Company
    País de registroYorkshire
    Autoridad legalLimited Company Law
    Lugar de registroCompanies House
    Número de registro02840742
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.

    ¿Tiene BROUGHTON CONTROLS LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Debenture
    Creado el 17 ago 1999
    Entregado el 26 ago 1999
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 26 ago 1999Registro de un cargo (395)
    • 05 ene 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 17 ago 1999
    Entregado el 26 ago 1999
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Land and buildings on the east side of shaw road oldham t/n's GM538197, LA296148, OL7661 and GM200732. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 26 ago 1999Registro de un cargo (395)
    • 05 ene 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 16 nov 1987
    Entregado el 19 nov 1987
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    F/H / l/h property k/a or being land and buildings on shaw road oldham greater manchester title no:- la 296148 ol 7661 gm 200732 with all buildings and fixtures thereon the goodwill of the business. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personas con derecho
    • Lloyds Bank PLC
    Transacciones
    • 19 nov 1987Registro de una carga
    • 05 ago 1999Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0