ORBITAL MAILING SERVICES LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | ORBITAL MAILING SERVICES LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 01096030 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de ORBITAL MAILING SERVICES LIMITED?
- Actividades de embalaje (82920) / Actividades administrativas y de apoyo
¿Dónde se encuentra ORBITAL MAILING SERVICES LIMITED?
| Dirección de la sede social | Unit E, Twelvetrees Business Park Twelvetrees Crescent E3 3JG London England |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de ORBITAL MAILING SERVICES LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| MACDONALD MAILING LIMITED | 07 oct 2003 | 07 oct 2003 |
| ANNE MACDONALD ASSOCIATES LIMITED | 31 dic 1976 | 31 dic 1976 |
| HALLIGAN MARKETING LIMITED | 14 feb 1973 | 14 feb 1973 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de ORBITAL MAILING SERVICES LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2018 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para ORBITAL MAILING SERVICES LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 3 páginas | DS01 | ||||||||||||||
Cancelación total de la carga 010960300005 | 4 páginas | MR04 | ||||||||||||||
Cancelación total de la carga 010960300006 | 4 páginas | MR04 | ||||||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2018 | 4 páginas | AA | ||||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 12 jun 2019 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||||||||||||||
Segunda presentación para el nombramiento de Mr Gregory John Michael como director | 6 páginas | RP04AP01 | ||||||||||||||
Registro de la carga 010960300006, creada el 28 mar 2019 | 26 páginas | MR01 | ||||||||||||||
Resoluciones Resolutions | 21 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Registro de la carga 010960300005, creada el 04 sept 2018 | 63 páginas | MR01 | ||||||||||||||
Cese del nombramiento de un secretario | 1 páginas | TM02 | ||||||||||||||
Cese del nombramiento de John Francis Alexander Geddes como secretario el 04 sept 2018 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||||||
Nombramiento de Mr Greggory John Michael como director el 04 sept 2018 | 3 páginas | AP01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de 2 World Business Centre Heathrow, Newall Road London Heathrow Airport Hounslow TW6 2SF a Unit E, Twelvetrees Business Park Twelvetrees Crescent London E3 3JG el 11 sept 2018 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||||||
Cese del nombramiento de Mark Stephen Cassie como director el 04 sept 2018 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2017 | 4 páginas | AA | ||||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 09 may 2018 con actualizaciones | 5 páginas | CS01 | ||||||||||||||
Modification des détails de Orbital Marketing Services Group Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 02 ene 2018 | 2 páginas | PSC05 | ||||||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2016 | 4 páginas | AA | ||||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 07 abr 2017 con actualizaciones | 5 páginas | CS01 | ||||||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2015 | 4 páginas | AA | ||||||||||||||
Cese del nombramiento de Forsyth Rutherford Black como director el 05 ago 2016 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||
Nombramiento de Mr Mark Stephen Cassie como director el 05 ago 2016 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||||||
Déclaration annuelle établie au 30 abr 2016 avec liste complète des actionnaires | 4 páginas | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
¿Quiénes son los directivos de ORBITAL MAILING SERVICES LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCCOURT, Paul Raymond Patrick | Director | Twelvetrees Crescent E3 3JG London Unit E, Twelvetrees Business Park England | Scotland | British | 183278190001 | |||||
| MICHAEL, Gregory John | Director | Twelvetrees Crescent E3 3JG London Unit E, Twelvetrees Business Park England | United Kingdom | British | 250488740001 | |||||
| GEDDES, John Francis Alexander | Secretario | Twelvetrees Crescent E3 3JG London Unit E, Twelvetrees Business Park England | 188527670001 | |||||||
| HAYDON, Dawn | Secretario | 4 Sunset Close CT5 4PQ Whitstable Kent | British | 84162040001 | ||||||
| POPE, Bernard John | Secretario | 3 Kingston Close River, River CT17 0NQ Dover Kent | British | 114493670001 | ||||||
| STIMPSON, Sydney Oswald George | Secretario | Valley Farmhouse Stalisfield ME13 0HW Faversham Kent | British | 8459760001 | ||||||
| TIPPING, Barry Peter | Secretario | Acorn Close Hawkinge CT18 7QA Folkestone 5 Kent | British | 91218400003 | ||||||
| TURNBULL, David Alistair | Secretario | New Square TW14 8HA Bedfont Lakes 4 Middlesex | British | 174872230001 | ||||||
| WINDING, Susan Caroline | Secretario | Waterford House Joy Lane CT5 4LS Whitstable Kent | British | 40699270003 | ||||||
| BARRETT, John Robert | Director | 16 Chanctonbury Chase The Grange Seasalter CT5 4SS Whitstable Kent | British | 29240410003 | ||||||
| BLACK, Forsyth Rutherford | Director | World Business Centre Heathrow, Newall Road London Heathrow Airport TW6 2SF Hounslow 2 United Kingdom | United Kingdom | British | 188546240002 | |||||
| BLAND, Catherine Mary | Director | New Square TW14 8HA Bedfont Lakes 4 Middlesex | Scotland | British | 153744340002 | |||||
| BURFORD, Diana Pauline | Director | Spelders Hill Brook TN25 5PB Ashford Spelders Hill Farm Kent | England | British | 35997610001 | |||||
| BURFORD, Ronald Albert | Director | Stone Street Westenhanger CT21 4HS Hythe Lyveden Kent | England | British | 35997620001 | |||||
| CASSIE, Mark Stephen | Director | World Business Centre Heathrow, Newall Road London Heathrow Airport TW6 2SF Hounslow 2 | Scotland | British | 161586010001 | |||||
| KLEINMAN, Andre John Leonard | Director | Cheriton Road CT19 5JR Folkestone 138 Kent | England | British | 94816660001 | |||||
| MARKLAND, Paul | Director | Rydlings Bossingham Road Stelling Minnis CT4 6AZ Canterbury Kent | United Kingdom | British | 15225430003 | |||||
| MCINTOSH, David Dennis | Director | New Square TW14 8HA Bedfont Lakes 4 Middlesex | Scotland | British | 85826730002 | |||||
| MOORE, Phillip John | Director | 171 Dover Road Walmer CT14 7NB Deal Kent | England | British | 100657710001 | |||||
| NANGLE, Thomas Joseph | Director | 1 Croft Walk EN10 6LD Broxbourne Hertfordshire | England | British | 92232470001 | |||||
| POPE, Bernard John | Director | 3 Kingston Close River, River CT17 0NQ Dover Kent | England | British | 114493670001 | |||||
| TIPPING, Barry Peter | Director | Acorn Close Hawkinge CT18 7QA Folkestone 5 Kent | England | British | 91218400003 | |||||
| WINDING, Julian | Director | Waterford House Joy Lane CT5 4LS Whitstable Kent | United Kingdom | British | 8459770004 | |||||
| WINDING, Susan Caroline | Director | Waterford House Joy Lane CT5 4LS Whitstable Kent | British | 40699270003 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de ORBITAL MAILING SERVICES LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Menzies Response Limited | 06 abr 2016 | World Business Centre Heathrow, Newall Road London Heathrow Airport TW6 2SF Hounslow 2 United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
¿Tiene ORBITAL MAILING SERVICES LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Creado el 28 mar 2019 Entregado el 05 abr 2019 | Satisfecho en su totalidad | ||
Breve descripción N/A. La garantía flotante cubre todo: Sí Contiene una promesa negativa: Sí Contiene una garantía flotante: Sí Contiene una garantía fija: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| A registered charge | Creado el 04 sept 2018 Entregado el 17 sept 2018 | Satisfecho en su totalidad | ||
Breve descripción Land on the south side of bluestem road, ransomes europark, ipswich and registered under title number SK181952. For further details of property being charged please see schedule 3 attached to the instrument. La garantía flotante cubre todo: Sí Contiene una promesa negativa: Sí Contiene una garantía flotante: Sí Contiene una garantía fija: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Legal charge | Creado el 10 sept 2001 Entregado el 13 sept 2001 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Michelsons tie factory staplehurst road sittingbourne kent t/nos.K394584 and K109491. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Mortgage debenture | Creado el 01 oct 1991 Entregado el 04 oct 1991 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Legal mortgage | Creado el 14 ago 1990 Entregado el 23 ago 1990 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción 1 saxon road faversham kent t/n - K639384 and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Mortgage | Creado el 22 feb 1980 Entregado el 29 feb 1980 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción 1, saxon road, faversham, kent. Title no. K154695.. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0