ORBITAL MAILING SERVICES LIMITED

ORBITAL MAILING SERVICES LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaORBITAL MAILING SERVICES LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 01096030
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de ORBITAL MAILING SERVICES LIMITED?

    • Actividades de embalaje (82920) / Actividades administrativas y de apoyo

    ¿Dónde se encuentra ORBITAL MAILING SERVICES LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Unit E, Twelvetrees Business Park
    Twelvetrees Crescent
    E3 3JG London
    England
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de ORBITAL MAILING SERVICES LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    MACDONALD MAILING LIMITED07 oct 200307 oct 2003
    ANNE MACDONALD ASSOCIATES LIMITED31 dic 197631 dic 1976
    HALLIGAN MARKETING LIMITED14 feb 197314 feb 1973

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de ORBITAL MAILING SERVICES LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2018

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para ORBITAL MAILING SERVICES LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Cancelación total de la carga 010960300005

    4 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 010960300006

    4 páginasMR04

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2018

    4 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 12 jun 2019 con actualizaciones

    4 páginasCS01

    Segunda presentación para el nombramiento de Mr Gregory John Michael como director

    6 páginasRP04AP01

    Registro de la carga 010960300006, creada el 28 mar 2019

    26 páginasMR01

    Resoluciones

    Resolutions
    21 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resoluciones

    Debenture 04/09/2018
    RES13
    incorporation

    Resolución de adopción de los Artículos de Asociación

    RES01

    Registro de la carga 010960300005, creada el 04 sept 2018

    63 páginasMR01

    Cese del nombramiento de un secretario

    1 páginasTM02

    Cese del nombramiento de John Francis Alexander Geddes como secretario el 04 sept 2018

    1 páginasTM02

    Nombramiento de Mr Greggory John Michael como director el 04 sept 2018

    3 páginasAP01
    Anotaciones
    FechaAnotación
    09 may 2019Clarification A SECOND FILED AP01 WAS REGISTERED ON 09/05/2019

    Domicilio social registrado cambiado de 2 World Business Centre Heathrow, Newall Road London Heathrow Airport Hounslow TW6 2SF a Unit E, Twelvetrees Business Park Twelvetrees Crescent London E3 3JG el 11 sept 2018

    1 páginasAD01

    Cese del nombramiento de Mark Stephen Cassie como director el 04 sept 2018

    1 páginasTM01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2017

    4 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 09 may 2018 con actualizaciones

    5 páginasCS01

    Modification des détails de Orbital Marketing Services Group Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 02 ene 2018

    2 páginasPSC05

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2016

    4 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 07 abr 2017 con actualizaciones

    5 páginasCS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2015

    4 páginasAA

    Cese del nombramiento de Forsyth Rutherford Black como director el 05 ago 2016

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mr Mark Stephen Cassie como director el 05 ago 2016

    2 páginasAP01

    Déclaration annuelle établie au 30 abr 2016 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital21 jun 2016

    Estado de capital el 21 jun 2016

    • Capital: GBP 799
    SH01

    ¿Quiénes son los directivos de ORBITAL MAILING SERVICES LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    MCCOURT, Paul Raymond Patrick
    Twelvetrees Crescent
    E3 3JG London
    Unit E, Twelvetrees Business Park
    England
    Director
    Twelvetrees Crescent
    E3 3JG London
    Unit E, Twelvetrees Business Park
    England
    ScotlandBritish183278190001
    MICHAEL, Gregory John
    Twelvetrees Crescent
    E3 3JG London
    Unit E, Twelvetrees Business Park
    England
    Director
    Twelvetrees Crescent
    E3 3JG London
    Unit E, Twelvetrees Business Park
    England
    United KingdomBritish250488740001
    GEDDES, John Francis Alexander
    Twelvetrees Crescent
    E3 3JG London
    Unit E, Twelvetrees Business Park
    England
    Secretario
    Twelvetrees Crescent
    E3 3JG London
    Unit E, Twelvetrees Business Park
    England
    188527670001
    HAYDON, Dawn
    4 Sunset Close
    CT5 4PQ Whitstable
    Kent
    Secretario
    4 Sunset Close
    CT5 4PQ Whitstable
    Kent
    British84162040001
    POPE, Bernard John
    3 Kingston Close
    River, River
    CT17 0NQ Dover
    Kent
    Secretario
    3 Kingston Close
    River, River
    CT17 0NQ Dover
    Kent
    British114493670001
    STIMPSON, Sydney Oswald George
    Valley Farmhouse
    Stalisfield
    ME13 0HW Faversham
    Kent
    Secretario
    Valley Farmhouse
    Stalisfield
    ME13 0HW Faversham
    Kent
    British8459760001
    TIPPING, Barry Peter
    Acorn Close
    Hawkinge
    CT18 7QA Folkestone
    5
    Kent
    Secretario
    Acorn Close
    Hawkinge
    CT18 7QA Folkestone
    5
    Kent
    British91218400003
    TURNBULL, David Alistair
    New Square
    TW14 8HA Bedfont Lakes
    4
    Middlesex
    Secretario
    New Square
    TW14 8HA Bedfont Lakes
    4
    Middlesex
    British174872230001
    WINDING, Susan Caroline
    Waterford House
    Joy Lane
    CT5 4LS Whitstable
    Kent
    Secretario
    Waterford House
    Joy Lane
    CT5 4LS Whitstable
    Kent
    British40699270003
    BARRETT, John Robert
    16 Chanctonbury Chase The Grange
    Seasalter
    CT5 4SS Whitstable
    Kent
    Director
    16 Chanctonbury Chase The Grange
    Seasalter
    CT5 4SS Whitstable
    Kent
    British29240410003
    BLACK, Forsyth Rutherford
    World Business Centre Heathrow, Newall Road
    London Heathrow Airport
    TW6 2SF Hounslow
    2
    United Kingdom
    Director
    World Business Centre Heathrow, Newall Road
    London Heathrow Airport
    TW6 2SF Hounslow
    2
    United Kingdom
    United KingdomBritish188546240002
    BLAND, Catherine Mary
    New Square
    TW14 8HA Bedfont Lakes
    4
    Middlesex
    Director
    New Square
    TW14 8HA Bedfont Lakes
    4
    Middlesex
    ScotlandBritish153744340002
    BURFORD, Diana Pauline
    Spelders Hill
    Brook
    TN25 5PB Ashford
    Spelders Hill Farm
    Kent
    Director
    Spelders Hill
    Brook
    TN25 5PB Ashford
    Spelders Hill Farm
    Kent
    EnglandBritish35997610001
    BURFORD, Ronald Albert
    Stone Street
    Westenhanger
    CT21 4HS Hythe
    Lyveden
    Kent
    Director
    Stone Street
    Westenhanger
    CT21 4HS Hythe
    Lyveden
    Kent
    EnglandBritish35997620001
    CASSIE, Mark Stephen
    World Business Centre Heathrow, Newall Road
    London Heathrow Airport
    TW6 2SF Hounslow
    2
    Director
    World Business Centre Heathrow, Newall Road
    London Heathrow Airport
    TW6 2SF Hounslow
    2
    ScotlandBritish161586010001
    KLEINMAN, Andre John Leonard
    Cheriton Road
    CT19 5JR Folkestone
    138
    Kent
    Director
    Cheriton Road
    CT19 5JR Folkestone
    138
    Kent
    EnglandBritish94816660001
    MARKLAND, Paul
    Rydlings
    Bossingham Road Stelling Minnis
    CT4 6AZ Canterbury
    Kent
    Director
    Rydlings
    Bossingham Road Stelling Minnis
    CT4 6AZ Canterbury
    Kent
    United KingdomBritish15225430003
    MCINTOSH, David Dennis
    New Square
    TW14 8HA Bedfont Lakes
    4
    Middlesex
    Director
    New Square
    TW14 8HA Bedfont Lakes
    4
    Middlesex
    ScotlandBritish85826730002
    MOORE, Phillip John
    171 Dover Road
    Walmer
    CT14 7NB Deal
    Kent
    Director
    171 Dover Road
    Walmer
    CT14 7NB Deal
    Kent
    EnglandBritish100657710001
    NANGLE, Thomas Joseph
    1 Croft Walk
    EN10 6LD Broxbourne
    Hertfordshire
    Director
    1 Croft Walk
    EN10 6LD Broxbourne
    Hertfordshire
    EnglandBritish92232470001
    POPE, Bernard John
    3 Kingston Close
    River, River
    CT17 0NQ Dover
    Kent
    Director
    3 Kingston Close
    River, River
    CT17 0NQ Dover
    Kent
    EnglandBritish114493670001
    TIPPING, Barry Peter
    Acorn Close
    Hawkinge
    CT18 7QA Folkestone
    5
    Kent
    Director
    Acorn Close
    Hawkinge
    CT18 7QA Folkestone
    5
    Kent
    EnglandBritish91218400003
    WINDING, Julian
    Waterford House
    Joy Lane
    CT5 4LS Whitstable
    Kent
    Director
    Waterford House
    Joy Lane
    CT5 4LS Whitstable
    Kent
    United KingdomBritish8459770004
    WINDING, Susan Caroline
    Waterford House
    Joy Lane
    CT5 4LS Whitstable
    Kent
    Director
    Waterford House
    Joy Lane
    CT5 4LS Whitstable
    Kent
    British40699270003

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de ORBITAL MAILING SERVICES LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    World Business Centre Heathrow, Newall Road
    London Heathrow Airport
    TW6 2SF Hounslow
    2
    United Kingdom
    06 abr 2016
    World Business Centre Heathrow, Newall Road
    London Heathrow Airport
    TW6 2SF Hounslow
    2
    United Kingdom
    No
    Forma jurídicaLimited By Shares
    País de registroEngland
    Autoridad legalUnited Kingdom (England)
    Lugar de registroCompanies House
    Número de registro01471252
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.
    • La persona tiene el derecho, directa o indirectamente, de nombrar o destituir a la mayoría de la junta directiva de la empresa.

    ¿Tiene ORBITAL MAILING SERVICES LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    A registered charge
    Creado el 28 mar 2019
    Entregado el 05 abr 2019
    Satisfecho en su totalidad
    Breve descripción
    N/A.
    La garantía flotante cubre todo:
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía flotante:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland (As Senior Security Agent)
    Transacciones
    • 05 abr 2019Registro de una carga (MR01)
    • 23 nov 2019Satisfacción de una carga (MR04)
    A registered charge
    Creado el 04 sept 2018
    Entregado el 17 sept 2018
    Satisfecho en su totalidad
    Breve descripción
    Land on the south side of bluestem road, ransomes europark, ipswich and registered under title number SK181952. For further details of property being charged please see schedule 3 attached to the instrument.
    La garantía flotante cubre todo:
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía flotante:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Endless LLP
    Transacciones
    • 17 sept 2018Registro de una carga (MR01)
    • 23 nov 2019Satisfacción de una carga (MR04)
    Legal charge
    Creado el 10 sept 2001
    Entregado el 13 sept 2001
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Michelsons tie factory staplehurst road sittingbourne kent t/nos.K394584 and K109491. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 13 sept 2001Registro de un cargo (395)
    • 29 sept 2009Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creado el 01 oct 1991
    Entregado el 04 oct 1991
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 04 oct 1991Registro de una carga
    • 29 sept 2009Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal mortgage
    Creado el 14 ago 1990
    Entregado el 23 ago 1990
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    1 saxon road faversham kent t/n - K639384 and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 23 ago 1990Registro de una carga
    • 17 may 2003Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Mortgage
    Creado el 22 feb 1980
    Entregado el 29 feb 1980
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    1, saxon road, faversham, kent. Title no. K154695.. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 29 feb 1980Registro de una carga
    • 17 may 2003Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0