COMBINED PRECISION COMPONENTS LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | COMBINED PRECISION COMPONENTS LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Activa |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 01098045 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | No |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de COMBINED PRECISION COMPONENTS LIMITED?
- Compañía no comercial (74990) / Actividades profesionales, científicas y técnicas
¿Dónde se encuentra COMBINED PRECISION COMPONENTS LIMITED?
| Dirección de la sede social | 150 Armley Road Leeds LS12 2QQ West Yorkshire |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de COMBINED PRECISION COMPONENTS LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| COMBINED PRECISION COMPONENTS PLC | 06 jul 1988 | 06 jul 1988 |
| COMBINED PRECISION COMPONENTS LIMITED | 31 dic 1976 | 31 dic 1976 |
| EXTEND LIFE TUBES LIMITED | 22 feb 1973 | 22 feb 1973 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de COMBINED PRECISION COMPONENTS LIMITED?
| Vencido | No |
|---|---|
| Próximas cuentas | |
| Próximo período contable finaliza el | 30 jun 2026 |
| Próximas cuentas vencen el | 31 mar 2027 |
| Últimas cuentas | |
| Últimas cuentas cerradas hasta | 30 jun 2025 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para COMBINED PRECISION COMPONENTS LIMITED?
| Última declaración de confirmación cerrada hasta | 16 jun 2026 |
|---|---|
| Próxima declaración de confirmación vence | 30 jun 2026 |
| Última declaración de confirmación | |
| Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 16 jun 2025 |
| Vencido | No |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para COMBINED PRECISION COMPONENTS LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 jun 2025 | 5 páginas | AA | ||
Cambio de datos del director Mr Gavin Peter Hodgson-Silke el 10 oct 2025 | 2 páginas | CH01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 16 jun 2025 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 jun 2024 | 5 páginas | AA | ||
Cambio de datos del director Mr Gavin Peter Hodgson-Silke el 14 nov 2024 | 2 páginas | CH01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 16 jun 2024 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 jun 2023 | 5 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 16 jun 2023 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 jun 2022 | 5 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 16 jun 2022 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 jun 2021 | 5 páginas | AA | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 jun 2020 | 5 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 16 jun 2021 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Nombramiento de Mr Gavin Peter Hodgson-Silke como director el 01 mar 2021 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de Richard Eden como director el 01 mar 2021 | 1 páginas | TM01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 16 jun 2020 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 jun 2019 | 5 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 16 jun 2019 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Nombramiento de Mr Darrel Scott Jackson como director el 30 abr 2019 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de Harvey Woodford como director el 30 abr 2019 | 1 páginas | TM01 | ||
Nombramiento de Mr Richard Eden como director el 25 feb 2019 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de Liam Anthony Heffernan como director el 15 feb 2019 | 1 páginas | TM01 | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 01 jul 2018 | 5 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 16 jun 2018 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cese del nombramiento de Peter Geoffrey Birks como director el 22 jun 2018 | 1 páginas | TM01 | ||
¿Quiénes son los directivos de COMBINED PRECISION COMPONENTS LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HODGSON-SILKE, Gavin Peter | Director | Canal Road LS12 2TU Leeds Farnell England | England | British | 212482320001 | |||||
| JACKSON, Darrel Scott | Director | c/o Avnet Europe - Legal Department De Kleetlaan B-1831 Diegem 3 Belgium | United States | American | 258280470001 | |||||
| HIGGINS, Caroline Patricia | Secretario | 18 Talbot View LS4 2RQ Leeds W Yorks | British | 32519770001 | ||||||
| MCCOY, Michael Ryan, Mr. | Secretario | 150 Armley Road Leeds LS12 2QQ West Yorkshire | 224405260001 | |||||||
| MULLEN, Kenneth John | Secretario | Tonhil House Borrowby YO7 4QQ Thirsk North Yorkshire | Scottish | 146642810001 | ||||||
| PEMBERTON, Eileen Mary | Secretario | 78 Coronation Crescent PR1 4JY Preston Lancashire | British | 60269700001 | ||||||
| WEBB, Steven John | Secretario | Armley Road LS12 2QQ Leeds 150 United Kingdom | British | 71137440003 | ||||||
| AINSWORTH, Robert David | Director | 16 Wakeling Road Denton M34 6ES Manchester | United Kingdom | British | 58139350002 | |||||
| BIRKS, Peter Geoffrey, Mr. | Director | 150 Armley Road Leeds LS12 2QQ West Yorkshire | United Kingdom | English | 199574840001 | |||||
| CADBURY, Nicholas Theodore | Director | Armley Road LS12 2QQ Leeds 150 United Kingdom | England | British | 132224150001 | |||||
| CANHAM, Stephen | Director | 5 Maplewood Gardens Burgess Wood Road South HP9 1BU Beaconsfield Buckinghamshire | United Kingdom | British | 95997260002 | |||||
| COOKE, Christopher Edward Cobden | Director | Chubbers Sterlings Field SL6 9PG Cookham Dean Berkshire | England | British | 2759410001 | |||||
| DUCKETT, Nicholas John | Director | 7 Brook View Fulwood Hall Lane Fulwood PR2 4FG Preston Lancashire | English | 59482110002 | ||||||
| DUCKETT, Richard Arnold Keith Ii, Dir | Director | Dobson Hall Folley Lane Chipping Lancashire | British | 59482020002 | ||||||
| DUCKETT, Richard Arnold Keith | Director | Highr Alston Farm Preston Road Ribchester PR3 2YQ Preston | English | 8350880003 | ||||||
| EDEN, Richard | Director | c/o Avnet Europe - Legal Department De Kleetlaan B-1831 Diegem 3 Belgium | England | British | 85228020001 | |||||
| EMPTAGE, Christopher | Director | Valley View Limestone Court High Street LS23 6HJ Clifford Yorkshire | British | 75702590003 | ||||||
| FISHER, Andrew Charles | Director | Colonnade Sunbridge Road BD1 2LQ Bradford West Yorkshire | United Kingdom | British | 41331580002 | |||||
| GASKIN, David John | Director | Armley Road LS12 2QQ Leeds 150 United Kingdom | Britain | British | 71544920001 | |||||
| GLEAVE, Peter | Director | Semper House Bryning PR4 3PP Preston Lancashire | United Kingdom | English | 69650000001 | |||||
| HAWORTH, Christopher | Director | Mill House Farm Mill House Lane, Longridge PR3 2YP Preston Lancashire | England | British | 8350920007 | |||||
| HEFFERNAN, Liam Anthony | Director | c/o Avnet Europe - Legal Department De Kleetlaan B-1831 Diegem 3 Belgium | England | British | 204389740001 | |||||
| LOAN-CLARKE, David | Director | 2 Rosefold Cottage Stricklands Lane Penwortham PR1 9XX Preston | United Kingdom | British | 84337090002 | |||||
| MANSON, Gavin | Director | Armley Road LS12 2QQ Leeds 150 West Yorkshire United Kingdom | United Kingdom | British | 135453070001 | |||||
| MCCOY, Michael Ryan, Mr. | Director | 150 Armley Road Leeds LS12 2QQ West Yorkshire | United States | American | 187451430001 | |||||
| MULLEN, Kenneth John | Director | Tonhil House Borrowby YO7 4QQ Thirsk North Yorkshire | United Kingdom | Scottish | 146642810001 | |||||
| PEMBERTON, Eileen Mary | Director | 78 Coronation Crescent PR1 4JY Preston Lancashire | British | 60269700001 | ||||||
| POULSON, Howard | Director | Field Gap Trip Garth LS22 4HY Linton Wetherby West Yorkshire | British | 37394840002 | ||||||
| PRICE, Frank | Director | 2 Huntsman Chase Treales Road, Treales PR4 3UX Preston Lancashire | British | 55111890003 | ||||||
| PRIEST, Mark Richard | Director | 150 Armley Road Leeds LS12 2QQ West Yorkshire | United Kingdom | British | 174767820001 | |||||
| ROSS, Nicholas Peter Gilbert | Director | Old Trinity Vicarage Gracious Street HG5 8DT Knaresborough | British | 28788750001 | ||||||
| SUTCLIFFE, Martyn | Director | 78 Mitton Road Whalley BB7 9JN Clitheroe Lancashire | United Kingdom | British | 50730770002 | |||||
| WEBB, Steven John | Director | 150 Armley Road Leeds LS12 2QQ West Yorkshire | England | British | 71137440003 | |||||
| WHITELING, Mark Argent | Director | 150 Armley Road Leeds LS12 2QQ West Yorkshire | England | British | 101297630001 | |||||
| WHITELING, Mark Argent | Director | Armley Road LS12 2QQ Leeds 150 United Kingdom | England | British | 101297630001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de COMBINED PRECISION COMPONENTS LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Farnell Holding Limited | 06 abr 2016 | Forge Lane LS12 2NE Leeds Farnell House United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0