L.C. SEWARD & SONS LIMITED

L.C. SEWARD & SONS LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Cuentas
  • Declaración anual
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaL.C. SEWARD & SONS LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 01103018
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de L.C. SEWARD & SONS LIMITED?

    • Comercio al por mayor no especializado de alimentos, bebidas y tabaco (46390) / Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas

    ¿Dónde se encuentra L.C. SEWARD & SONS LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Equity House
    Irthlingborough Road
    NN8 1LT Wellingborough
    Northamptonshire
    England
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de L.C. SEWARD & SONS LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta27 dic 2014

    ¿Cuál es el estado de la última declaración anual para L.C. SEWARD & SONS LIMITED?

    Declaración anual
    Última declaración anual

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para L.C. SEWARD & SONS LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resoluciones

    Ceased trading res 14/12/2015
    RES13

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01
    A4MG6HMQ

    Resoluciones

    Resolutions
    21 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    incorporation

    Resolución de adopción de los Artículos de Asociación

    RES01

    Declaración de los objetos de la sociedad

    2 páginasCC04
    A4LVKACJ

    Renuncia de un auditor

    3 páginasAA03
    L4FZKTQJ

    Renuncia del auditor

    1 páginasAUD
    A4GFPSRT

    Cese del nombramiento de Timothy Kenny como director el 14 sept 2015

    1 páginasTM01
    X4GYKCHK

    Cese del nombramiento de David Thomas Codd como director el 14 sept 2015

    1 páginasTM01
    X4GYKCKG

    Cese del nombramiento de Christopher Nicholas Martin como director el 14 sept 2015

    1 páginasTM01
    X4GYKCFV

    Cese del nombramiento de David Thomas Codd como secretario el 14 sept 2015

    1 páginasTM02
    X4GYKCJK

    Nombramiento de Mr Mark Chilton como secretario el 14 sept 2015

    2 páginasAP03
    X4GYKCJC

    Nombramiento de Mr Jonathan Paul Prentis como director el 14 sept 2015

    2 páginasAP01
    X4GYKCG8

    Domicilio social registrado cambiado de Musgrave House Widewater Place Moorhall Road Harefield Middlesex UB9 6NS a Equity House Irthlingborough Road Wellingborough Northamptonshire NN8 1LT el 29 sept 2015

    1 páginasAD01
    X4GYKBZL

    Renuncia del auditor

    1 páginasAUD
    L4FZKTT7

    Cuentas completas preparadas hasta el 27 dic 2014

    13 páginasAA
    A4CNN9C1

    Déclaration annuelle établie au 26 jul 2015 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital29 jul 2015

    Estado de capital el 29 jul 2015

    • Capital: GBP 100
    SH01
    X4COYYT5

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2013

    11 páginasAA
    A3HGP6PL

    Déclaration annuelle établie au 26 jul 2014 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital28 jul 2014

    Estado de capital el 28 jul 2014

    • Capital: GBP 100
    SH01
    X3D4277N

    Cese del nombramiento de Donal Horgan como director

    1 páginasTM01
    X36RNOFV

    Cambio de datos del director Mr Christopher Nicholas Martin el 09 dic 2013

    2 páginasCH01
    X2N4PC1D

    Nombramiento de Mr. David Thomas Codd como secretario

    1 páginasAP03
    X2JQSG6B

    Nombramiento de Mr. David Thomas Codd como director

    2 páginasAP01
    X2JQSFWW

    Cese del nombramiento de Julie Wirth como director

    1 páginasTM01
    X2JQSFN5

    ¿Quiénes son los directivos de L.C. SEWARD & SONS LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    CHILTON, Mark
    Irthlingborough Road
    NN8 1LT Wellingborough
    Equity House
    Northamptonshire
    England
    Secretario
    Irthlingborough Road
    NN8 1LT Wellingborough
    Equity House
    Northamptonshire
    England
    201369850001
    PRENTIS, Jonathan Paul
    Irthlingborough Road
    NN8 1LT Wellingborough
    Equity House
    Northamptonshire
    England
    Director
    Irthlingborough Road
    NN8 1LT Wellingborough
    Equity House
    Northamptonshire
    England
    United KingdomBritishFinance Director177693990001
    CODD, David Thomas, Mr.
    Irthlingborough Road
    NN8 1LT Wellingborough
    Equity House
    Northamptonshire
    England
    Secretario
    Irthlingborough Road
    NN8 1LT Wellingborough
    Equity House
    Northamptonshire
    England
    182403050001
    DUNLEA, Aidan Finbar
    39 Redwood Place
    HP9 1RP Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Secretario
    39 Redwood Place
    HP9 1RP Beaconsfield
    Buckinghamshire
    IrishDirector108011300001
    HARE, Richard Warren
    Sunnyside Main Street
    Gawcott
    MK18 4HZ Buckingham
    Buckinghamshire
    Secretario
    Sunnyside Main Street
    Gawcott
    MK18 4HZ Buckingham
    Buckinghamshire
    BritishSolicitor2955620006
    O'FLYNN, David
    Ballyphilip
    IRISH Glanmire
    Co. Cork
    Ireland
    Secretario
    Ballyphilip
    IRISH Glanmire
    Co. Cork
    Ireland
    IrishDirector123363960001
    SEWARD, Roger David
    33 Denmark Avenue
    Woodley
    RG5 4RS Reading
    Berkshire
    Secretario
    33 Denmark Avenue
    Woodley
    RG5 4RS Reading
    Berkshire
    British3451190001
    WIRTH, Julie Ann
    Musgrave House Widewater Place
    Moorhall Road
    UB9 6NS Harefield
    Middlesex
    Secretario
    Musgrave House Widewater Place
    Moorhall Road
    UB9 6NS Harefield
    Middlesex
    BritishDirector114305580001
    BACK, Steven John
    Fennels 119 Bicester Road
    Lower End
    HP18 9EF Long Crendon
    Director
    Fennels 119 Bicester Road
    Lower End
    HP18 9EF Long Crendon
    United KingdomBritishDirector85825120001
    CODD, David Thomas, Mr.
    Irthlingborough Road
    NN8 1LT Wellingborough
    Equity House
    Northamptonshire
    England
    Director
    Irthlingborough Road
    NN8 1LT Wellingborough
    Equity House
    Northamptonshire
    England
    IrelandIrishFinance Director182392430001
    DUNLEA, Aidan Finbar
    39 Redwood Place
    HP9 1RP Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Director
    39 Redwood Place
    HP9 1RP Beaconsfield
    Buckinghamshire
    IrishDirector108011300001
    HORGAN, Donal Patrick
    Musgrave House Widewater Place
    Moorhall Road
    UB9 6NS Harefield
    Middlesex
    Director
    Musgrave House Widewater Place
    Moorhall Road
    UB9 6NS Harefield
    Middlesex
    IrelandIrishManaging Director163398920001
    HYSON, Martin John
    Poplar Lane
    RG10 0DJ Hurst Reading
    White Rose Cottage
    Berkshire
    Director
    Poplar Lane
    RG10 0DJ Hurst Reading
    White Rose Cottage
    Berkshire
    United KingdomBritishDirector128460840001
    KENNY, Timothy, Mr.
    Irthlingborough Road
    NN8 1LT Wellingborough
    Equity House
    Northamptonshire
    England
    Director
    Irthlingborough Road
    NN8 1LT Wellingborough
    Equity House
    Northamptonshire
    England
    IrelandIrishDirector113651250001
    MALONEY, Vincent
    Flat 9 Sunset House
    Grant Road
    HA3 7SA Wealdstone
    Middlesex
    Director
    Flat 9 Sunset House
    Grant Road
    HA3 7SA Wealdstone
    Middlesex
    BritishDirector124418930001
    MARTIN, Christopher Nicholas
    Irthlingborough Road
    NN8 1LT Wellingborough
    Equity House
    Northamptonshire
    England
    Director
    Irthlingborough Road
    NN8 1LT Wellingborough
    Equity House
    Northamptonshire
    England
    United KingdomBritishDirector48484090003
    O'FLYNN, David, Mr.
    Musgrave House Widewater Place
    Moorhall Road
    UB9 6NS Harefield
    Middlesex
    Director
    Musgrave House Widewater Place
    Moorhall Road
    UB9 6NS Harefield
    Middlesex
    IrelandIrishGroup Finance Director163739400001
    O'FLYNN, David
    Ballyphilip
    IRISH Glanmire
    Co. Cork
    Ireland
    Director
    Ballyphilip
    IRISH Glanmire
    Co. Cork
    Ireland
    IrishDirector123363960001
    PYE, James Francis
    11 Neville Crescent
    MK43 8JE Bromham
    Bedfordshire
    Director
    11 Neville Crescent
    MK43 8JE Bromham
    Bedfordshire
    BritishCompany Director99123350001
    PYPER, Simon John
    160 Lauderdale Mansions
    Lauderdale Road
    W9 1NG London
    Director
    160 Lauderdale Mansions
    Lauderdale Road
    W9 1NG London
    BritishAccountant108173190001
    SEWARD, Derek Charles
    Menders Cottage
    Lockram Lane Wokefield
    RG7 3AS Reading
    Berks
    Director
    Menders Cottage
    Lockram Lane Wokefield
    RG7 3AS Reading
    Berks
    EnglandBritishRetailer15740450001
    SEWARD, Iris
    Menders Cottage
    Lockram Lane Wokefield
    RG7 3AS Reading
    Berks
    Director
    Menders Cottage
    Lockram Lane Wokefield
    RG7 3AS Reading
    Berks
    EnglandBritishRetailer15740460001
    SEWARD, Iris
    Menders Cottage
    Lockram Lane Wokefield
    RG7 3AS Reading
    Berks
    Director
    Menders Cottage
    Lockram Lane Wokefield
    RG7 3AS Reading
    Berks
    EnglandBritishRetailer15740460001
    SEWARD, Paul Christopher
    Fulwood Birch Lane
    Mortimer West End
    RG7 3UB Reading
    Berkshire
    Director
    Fulwood Birch Lane
    Mortimer West End
    RG7 3UB Reading
    Berkshire
    EnglandBritishRetailer15740470001
    SEWARD, Roger David
    33 Denmark Avenue
    Woodley
    RG5 4RS Reading
    Berkshire
    Director
    33 Denmark Avenue
    Woodley
    RG5 4RS Reading
    Berkshire
    EnglandBritishRetailer3451190001
    SMITH, Philip Anthony
    Musgrave House Widewater Place
    Moorhall Road
    UB9 6NS Harefield
    Middlesex
    Director
    Musgrave House Widewater Place
    Moorhall Road
    UB9 6NS Harefield
    Middlesex
    EnglandBritishDirector233299960001
    TAYLOR, Michael John
    The Old Parsonage
    Nether Winchendon
    HP18 0EA Aylesbury
    Buckinghamshire
    Director
    The Old Parsonage
    Nether Winchendon
    HP18 0EA Aylesbury
    Buckinghamshire
    United KingdomBritishDirector122666080001
    WILSON, Lawrence Thomas
    3 Dudley Close
    Tilehurst
    RG31 6JJ Reading
    Director
    3 Dudley Close
    Tilehurst
    RG31 6JJ Reading
    BritishCompany Director51059870001
    WIRTH, Julie Ann
    Musgrave House Widewater Place
    Moorhall Road
    UB9 6NS Harefield
    Middlesex
    Director
    Musgrave House Widewater Place
    Moorhall Road
    UB9 6NS Harefield
    Middlesex
    EnglandBritishDirector114305580002

    ¿Tiene L.C. SEWARD & SONS LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Legal mortgage
    Creado el 13 mar 1996
    Entregado el 30 mar 1996
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    F/H property k/a southern view victoria road stratfield mortimer berkshire t/no:- BK145946 together with all buildings and fixtures thereon the goodwill of the business carried on at the property and full benefit of all rentals payable to the company by the tenant. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Lloyds Bank PLC
    Transacciones
    • 30 mar 1996Registro de un cargo (395)
    • 21 feb 2001Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal mortgage
    Creado el 29 abr 1993
    Entregado el 01 may 1993
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    F/H-heather cottage 9 victoria road mortimer reading berkshire. T/n-BK305024 and assigns the goodwill of the business (if any). Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personas con derecho
    • Lloyds Bank PLC
    Transacciones
    • 01 may 1993Registro de un cargo (395)
    • 21 feb 2001Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Rent deposit deed
    Creado el 07 abr 1993
    Entregado el 26 abr 1993
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the underlease dated 7 april 1993
    Breve descripción
    £7,750.
    Personas con derecho
    • Metal Distributors (UK) Limited
    Transacciones
    • 26 abr 1993Registro de un cargo (395)
    • 16 jul 1997Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Single debenture
    Creado el 27 abr 1992
    Entregado el 05 may 1992
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Lloyds Bank PLC
    Transacciones
    • 05 may 1992Registro de un cargo (395)
    • 21 feb 2001Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 29 ene 1990
    Entregado el 02 feb 1990
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    F/H property known as heatherdown, kings street, mortimer, reading, berkshire assigns goodwill (if any). Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personas con derecho
    • Lloyds Bank PLC
    Transacciones
    • 02 feb 1990Registro de una carga
    • 21 feb 2001Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Single debenture
    Creado el 19 jul 1979
    Entregado el 01 ago 1979
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    "Sewards groceries" victoria rd mortimer berkshire title no bk 122105 fixed & floating charge on undertaking and all property and assets present and future including goodwil & uncalled capital with all fixtures (including trade fixtus) fixed plant & machinery (see doc M20 for details).
    Personas con derecho
    • Lloyds Bank PLC
    Transacciones
    • 01 ago 1979Registro de una carga
    • 21 feb 2001Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 09 sept 1976
    Entregado el 16 sept 1976
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    Sterling pounds 29000
    Breve descripción
    Shop and premises on the north side of victoria road mortimer berkshire known as sewards fruiterers and off licence together with the yard at rear and all that freehold property hitherto known as southern view victoria road mortimer.
    Personas con derecho
    • Leonard Charles Steward
    Transacciones
    • 16 sept 1976Registro de una carga
    • 22 ago 1995Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 01 may 1973
    Entregado el 07 may 1973
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Seward stores victoria road mortimer berks.
    Personas con derecho
    • Lloyds Bank PLC
    Transacciones
    • 07 may 1973Registro de una carga
    • 21 feb 2001Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0