L.C. SEWARD & SONS LIMITED
Visión general
Nombre de la empresa | L.C. SEWARD & SONS LIMITED |
---|---|
Estado de la empresa | Disuelta |
Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
Número de empresa | 01103018 |
Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
Fecha de constitución | |
Fecha de cese |
Resumen
Tiene PSCs súper seguros | No |
---|---|
Tiene gravámenes | Sí |
Tiene historial de insolvencia | No |
La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de L.C. SEWARD & SONS LIMITED?
- Comercio al por mayor no especializado de alimentos, bebidas y tabaco (46390) / Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas
¿Dónde se encuentra L.C. SEWARD & SONS LIMITED?
Dirección de la sede social | Equity House Irthlingborough Road NN8 1LT Wellingborough Northamptonshire England |
---|---|
Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles son las últimas cuentas de L.C. SEWARD & SONS LIMITED?
Últimas cuentas | |
---|---|
Últimas cuentas cerradas hasta | 27 dic 2014 |
¿Cuál es el estado de la última declaración anual para L.C. SEWARD & SONS LIMITED?
Declaración anual |
|
---|
¿Cuáles son las últimas presentaciones para L.C. SEWARD & SONS LIMITED?
Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 3 páginas | DS01 | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 21 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Declaración de los objetos de la sociedad | 2 páginas | CC04 | ||||||||||
Renuncia de un auditor | 3 páginas | AA03 | ||||||||||
Renuncia del auditor | 1 páginas | AUD | ||||||||||
Cese del nombramiento de Timothy Kenny como director el 14 sept 2015 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de David Thomas Codd como director el 14 sept 2015 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Christopher Nicholas Martin como director el 14 sept 2015 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de David Thomas Codd como secretario el 14 sept 2015 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Mark Chilton como secretario el 14 sept 2015 | 2 páginas | AP03 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Jonathan Paul Prentis como director el 14 sept 2015 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de Musgrave House Widewater Place Moorhall Road Harefield Middlesex UB9 6NS a Equity House Irthlingborough Road Wellingborough Northamptonshire NN8 1LT el 29 sept 2015 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Renuncia del auditor | 1 páginas | AUD | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 27 dic 2014 | 13 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 26 jul 2015 avec liste complète des actionnaires | 4 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2013 | 11 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 26 jul 2014 avec liste complète des actionnaires | 4 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cese del nombramiento de Donal Horgan como director | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr Christopher Nicholas Martin el 09 dic 2013 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr. David Thomas Codd como secretario | 1 páginas | AP03 | ||||||||||
Nombramiento de Mr. David Thomas Codd como director | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Julie Wirth como director | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de L.C. SEWARD & SONS LIMITED?
Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHILTON, Mark | Secretario | Irthlingborough Road NN8 1LT Wellingborough Equity House Northamptonshire England | 201369850001 | |||||||
PRENTIS, Jonathan Paul | Director | Irthlingborough Road NN8 1LT Wellingborough Equity House Northamptonshire England | United Kingdom | British | Finance Director | 177693990001 | ||||
CODD, David Thomas, Mr. | Secretario | Irthlingborough Road NN8 1LT Wellingborough Equity House Northamptonshire England | 182403050001 | |||||||
DUNLEA, Aidan Finbar | Secretario | 39 Redwood Place HP9 1RP Beaconsfield Buckinghamshire | Irish | Director | 108011300001 | |||||
HARE, Richard Warren | Secretario | Sunnyside Main Street Gawcott MK18 4HZ Buckingham Buckinghamshire | British | Solicitor | 2955620006 | |||||
O'FLYNN, David | Secretario | Ballyphilip IRISH Glanmire Co. Cork Ireland | Irish | Director | 123363960001 | |||||
SEWARD, Roger David | Secretario | 33 Denmark Avenue Woodley RG5 4RS Reading Berkshire | British | 3451190001 | ||||||
WIRTH, Julie Ann | Secretario | Musgrave House Widewater Place Moorhall Road UB9 6NS Harefield Middlesex | British | Director | 114305580001 | |||||
BACK, Steven John | Director | Fennels 119 Bicester Road Lower End HP18 9EF Long Crendon | United Kingdom | British | Director | 85825120001 | ||||
CODD, David Thomas, Mr. | Director | Irthlingborough Road NN8 1LT Wellingborough Equity House Northamptonshire England | Ireland | Irish | Finance Director | 182392430001 | ||||
DUNLEA, Aidan Finbar | Director | 39 Redwood Place HP9 1RP Beaconsfield Buckinghamshire | Irish | Director | 108011300001 | |||||
HORGAN, Donal Patrick | Director | Musgrave House Widewater Place Moorhall Road UB9 6NS Harefield Middlesex | Ireland | Irish | Managing Director | 163398920001 | ||||
HYSON, Martin John | Director | Poplar Lane RG10 0DJ Hurst Reading White Rose Cottage Berkshire | United Kingdom | British | Director | 128460840001 | ||||
KENNY, Timothy, Mr. | Director | Irthlingborough Road NN8 1LT Wellingborough Equity House Northamptonshire England | Ireland | Irish | Director | 113651250001 | ||||
MALONEY, Vincent | Director | Flat 9 Sunset House Grant Road HA3 7SA Wealdstone Middlesex | British | Director | 124418930001 | |||||
MARTIN, Christopher Nicholas | Director | Irthlingborough Road NN8 1LT Wellingborough Equity House Northamptonshire England | United Kingdom | British | Director | 48484090003 | ||||
O'FLYNN, David, Mr. | Director | Musgrave House Widewater Place Moorhall Road UB9 6NS Harefield Middlesex | Ireland | Irish | Group Finance Director | 163739400001 | ||||
O'FLYNN, David | Director | Ballyphilip IRISH Glanmire Co. Cork Ireland | Irish | Director | 123363960001 | |||||
PYE, James Francis | Director | 11 Neville Crescent MK43 8JE Bromham Bedfordshire | British | Company Director | 99123350001 | |||||
PYPER, Simon John | Director | 160 Lauderdale Mansions Lauderdale Road W9 1NG London | British | Accountant | 108173190001 | |||||
SEWARD, Derek Charles | Director | Menders Cottage Lockram Lane Wokefield RG7 3AS Reading Berks | England | British | Retailer | 15740450001 | ||||
SEWARD, Iris | Director | Menders Cottage Lockram Lane Wokefield RG7 3AS Reading Berks | England | British | Retailer | 15740460001 | ||||
SEWARD, Iris | Director | Menders Cottage Lockram Lane Wokefield RG7 3AS Reading Berks | England | British | Retailer | 15740460001 | ||||
SEWARD, Paul Christopher | Director | Fulwood Birch Lane Mortimer West End RG7 3UB Reading Berkshire | England | British | Retailer | 15740470001 | ||||
SEWARD, Roger David | Director | 33 Denmark Avenue Woodley RG5 4RS Reading Berkshire | England | British | Retailer | 3451190001 | ||||
SMITH, Philip Anthony | Director | Musgrave House Widewater Place Moorhall Road UB9 6NS Harefield Middlesex | England | British | Director | 233299960001 | ||||
TAYLOR, Michael John | Director | The Old Parsonage Nether Winchendon HP18 0EA Aylesbury Buckinghamshire | United Kingdom | British | Director | 122666080001 | ||||
WILSON, Lawrence Thomas | Director | 3 Dudley Close Tilehurst RG31 6JJ Reading | British | Company Director | 51059870001 | |||||
WIRTH, Julie Ann | Director | Musgrave House Widewater Place Moorhall Road UB9 6NS Harefield Middlesex | England | British | Director | 114305580002 |
¿Tiene L.C. SEWARD & SONS LIMITED alguna carga?
Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
---|---|---|---|---|
Legal mortgage | Creado el 13 mar 1996 Entregado el 30 mar 1996 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción F/H property k/a southern view victoria road stratfield mortimer berkshire t/no:- BK145946 together with all buildings and fixtures thereon the goodwill of the business carried on at the property and full benefit of all rentals payable to the company by the tenant. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Legal mortgage | Creado el 29 abr 1993 Entregado el 01 may 1993 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción F/H-heather cottage 9 victoria road mortimer reading berkshire. T/n-BK305024 and assigns the goodwill of the business (if any). Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Rent deposit deed | Creado el 07 abr 1993 Entregado el 26 abr 1993 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the underlease dated 7 april 1993 | |
Breve descripción £7,750. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Single debenture | Creado el 27 abr 1992 Entregado el 05 may 1992 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Legal charge | Creado el 29 ene 1990 Entregado el 02 feb 1990 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción F/H property known as heatherdown, kings street, mortimer, reading, berkshire assigns goodwill (if any). Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Single debenture | Creado el 19 jul 1979 Entregado el 01 ago 1979 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción "Sewards groceries" victoria rd mortimer berkshire title no bk 122105 fixed & floating charge on undertaking and all property and assets present and future including goodwil & uncalled capital with all fixtures (including trade fixtus) fixed plant & machinery (see doc M20 for details). | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Legal charge | Creado el 09 sept 1976 Entregado el 16 sept 1976 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada Sterling pounds 29000 | |
Breve descripción Shop and premises on the north side of victoria road mortimer berkshire known as sewards fruiterers and off licence together with the yard at rear and all that freehold property hitherto known as southern view victoria road mortimer. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Legal charge | Creado el 01 may 1973 Entregado el 07 may 1973 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Seward stores victoria road mortimer berks. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0