MOTHERCARE TOYS 3 LIMITED

MOTHERCARE TOYS 3 LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaMOTHERCARE TOYS 3 LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 01103663
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de MOTHERCARE TOYS 3 LIMITED?

    • Compañía no comercial (74990) / Actividades profesionales, científicas y técnicas

    ¿Dónde se encuentra MOTHERCARE TOYS 3 LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Resolve Advisory Limited
    22 York Buildings
    WC2N 6JU London
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de MOTHERCARE TOYS 3 LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    EARLY LEARNING LIMITED23 mar 197323 mar 1973

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de MOTHERCARE TOYS 3 LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta27 mar 2021

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para MOTHERCARE TOYS 3 LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros

    18 páginasLIQ13

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 24 oct 2023

    17 páginasLIQ03

    Domicilio social registrado cambiado de Westside 1 London Road Hemel Hempstead HP3 9TD United Kingdom a Resolve Advisory Limited 22 York Buildings London WC2N 6JU el 07 nov 2022

    2 páginasAD01

    Declaración de solvencia

    5 páginasLIQ01

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    3 páginas600

    Resoluciones

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    liquidation

    Acuerdo especial para la liquidación el 25 oct 2022

    LRESSP

    Declaración de confirmación presentada el 19 jun 2022 con actualizaciones

    4 páginasCS01

    Estado de capital el 25 abr 2022

    • Capital: GBP 1
    3 páginasSH19

    legacy

    1 páginasSH20

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resolución de reducción del capital social emitido

    RES06

    Todo el bien o empresa ha sido liberado de la carga 6

    2 páginasMR05

    Todo el bien o empresa ha sido liberado de la carga 011036630007

    1 páginasMR05

    Todo el bien o empresa ha sido liberado de la carga 011036630008

    1 páginasMR05

    Todo el bien o empresa ha sido liberado de la carga 011036630009

    1 páginasMR05

    Todo el bien o empresa ha sido liberado de la carga 011036630010

    1 páginasMR05

    Cancelación total de la carga 6

    1 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 011036630007

    1 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 5

    1 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 011036630008

    1 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 011036630009

    1 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 011036630010

    1 páginasMR04

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 27 mar 2021

    11 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 19 jun 2021 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    ¿Quiénes son los directivos de MOTHERCARE TOYS 3 LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    MEDINI, Lynne Samatha
    22 York Buildings
    WC2N 6JU London
    Resolve Advisory Limited
    Secretario
    22 York Buildings
    WC2N 6JU London
    Resolve Advisory Limited
    British167184730001
    COOK, Andrew
    22 York Buildings
    WC2N 6JU London
    Resolve Advisory Limited
    Director
    22 York Buildings
    WC2N 6JU London
    Resolve Advisory Limited
    EnglandBritishAccountant266409860001
    MEDINI, Lynne Samantha
    22 York Buildings
    WC2N 6JU London
    Resolve Advisory Limited
    Director
    22 York Buildings
    WC2N 6JU London
    Resolve Advisory Limited
    EnglandBritishChartered Secretary70989770003
    ANDERSON, Charles Adair
    Ravensheugh
    TD7 5LS Selkirk
    Secretario
    Ravensheugh
    TD7 5LS Selkirk
    British44142970001
    BRAMALL, Helen Mary
    Cherry Tree Road
    WD24 6SH Watford
    Hertfordshire
    Secretario
    Cherry Tree Road
    WD24 6SH Watford
    Hertfordshire
    BritishCompany Secretary59695650001
    GRIFFITHS, David
    17 Cransley Grove
    B91 3ZA Solihull
    West Midlands
    Secretario
    17 Cransley Grove
    B91 3ZA Solihull
    West Midlands
    BritishFinance Director78157950002
    JONES, Gavin Stewart
    25 The Drive
    Henleaze
    BS9 4LD Bristol
    Avon
    Secretario
    25 The Drive
    Henleaze
    BS9 4LD Bristol
    Avon
    British116097830001
    MULHOLLAND, Eric
    81 Auchingane
    EH10 7HU Edinburgh
    Secretario
    81 Auchingane
    EH10 7HU Edinburgh
    British984680001
    MULHOLLAND, Eric
    81 Auchingane
    EH10 7HU Edinburgh
    Secretario
    81 Auchingane
    EH10 7HU Edinburgh
    British984680001
    SELBER, Kimberley Lynn
    1 Bellevue Road
    Barnes
    SW13 0BJ London
    Secretario
    1 Bellevue Road
    Barnes
    SW13 0BJ London
    UsFinance Director97940820001
    THOMPSON, Nicholas Raymond
    Eynella Road
    East Dulwich
    SE10 8HR London
    4
    United Kingdom
    Secretario
    Eynella Road
    East Dulwich
    SE10 8HR London
    4
    United Kingdom
    British134102250001
    J M SECRETARIES LIMITED
    34 Ely Place
    EC1N 6TD London
    Secretario corporativo
    34 Ely Place
    EC1N 6TD London
    61308040001
    ANDERSON, Charles Adair
    Ravensheugh
    TD7 5LS Selkirk
    Director
    Ravensheugh
    TD7 5LS Selkirk
    United KingdomBritishChartered Accountant44142970001
    ANDERSON, Charles Adair
    Ravensheugh
    TD7 5LS Selkirk
    Director
    Ravensheugh
    TD7 5LS Selkirk
    United KingdomBritishChartered Accountant44142970001
    ASHBY, Timothy John
    Cherry Tree Road
    WD24 6SH Watford
    Hertfordshire
    Director
    Cherry Tree Road
    WD24 6SH Watford
    Hertfordshire
    Great BritainBritishGeneral Counsel162876770001
    ATWAL, Harminder Singh
    Cherry Tree Road
    WD24 6SH Watford
    Hertfordshire
    Director
    Cherry Tree Road
    WD24 6SH Watford
    Hertfordshire
    United KingdomBritishAccountant167976490001
    BENNETT, James Douglas Scott
    The Well House
    3 Easter Belmont Road
    EH12 6EX Edinburgh
    Director
    The Well House
    3 Easter Belmont Road
    EH12 6EX Edinburgh
    BritishCompany Director365550003
    BLACK, Robert
    The Coach House 1 Templars Cramond
    EH4 6BY Edinburgh
    Director
    The Coach House 1 Templars Cramond
    EH4 6BY Edinburgh
    BritishCompany Director50558240001
    BOYDELL, Joanna
    Cherry Tree Road
    WD24 6SH Watford
    Hertfordshire
    Director
    Cherry Tree Road
    WD24 6SH Watford
    Hertfordshire
    EnglandBritishChartered Accountant118883430001
    CLARK, Darren Wayne
    Cherry Tree Road
    WD24 6SH Watford
    Hertfordshire
    Director
    Cherry Tree Road
    WD24 6SH Watford
    Hertfordshire
    United KingdomBritishAccountant212137270001
    CRANKSHAW, Andrew Ernest
    Lucerne Piece 51 Cricklade Road
    Highworth
    SN6 7RJ Swindon
    Director
    Lucerne Piece 51 Cricklade Road
    Highworth
    SN6 7RJ Swindon
    United KingdomBritishCompany Director28581470002
    DUNCAN, Robert Ian
    Oakley Houser
    Oak Drive
    SN6 7BP Swindon
    Wiltshire
    Director
    Oakley Houser
    Oak Drive
    SN6 7BP Swindon
    Wiltshire
    BritishCompany Director59423840001
    ELLIS, Peter Malcolm
    The Orchard
    Old Forge, Ewen
    GL7 6BU Cirencester
    Gloucestershire
    Director
    The Orchard
    Old Forge, Ewen
    GL7 6BU Cirencester
    Gloucestershire
    BritishCompany Director55540630003
    FRANCE, Michael Bernard Anthony
    Ford Cottage Sandpit Lane
    Bledlow
    HP27 9QL Princess Risborough
    Buckinghamshire
    Director
    Ford Cottage Sandpit Lane
    Bledlow
    HP27 9QL Princess Risborough
    Buckinghamshire
    United KingdomBritishCompany Director141561430001
    GRIFFITHS, David
    17 Cransley Grove
    B91 3ZA Solihull
    West Midlands
    Director
    17 Cransley Grove
    B91 3ZA Solihull
    West Midlands
    BritishFinance Director78157950002
    HARRINGTON, Neil Simon
    Cherry Tree Road
    WD24 6SH Watford
    Hertfordshire
    Director
    Cherry Tree Road
    WD24 6SH Watford
    Hertfordshire
    EnglandBritishGroup Finance Director157815820001
    HOMER, Kirsty Rowena
    Cherry Tree Road
    WD24 6SH Watford
    Hertfordshire
    Director
    Cherry Tree Road
    WD24 6SH Watford
    Hertfordshire
    United KingdomBritishHr Director235620910001
    JENKINSON, Dermot Julian
    Mersington House
    Greenlaw
    TD10 6UL Duns
    Berwickshire
    Director
    Mersington House
    Greenlaw
    TD10 6UL Duns
    Berwickshire
    ScotlandBritishCompany Director681840002
    JONES, Gavin Stewart
    25 The Drive
    Henleaze
    BS9 4LD Bristol
    Avon
    Director
    25 The Drive
    Henleaze
    BS9 4LD Bristol
    Avon
    EnglandBritishFinance Director116097830001
    JUCKES, Daniel
    London Road
    HP3 9TD Hemel Hempstead
    Westside 1
    United Kingdom
    Director
    London Road
    HP3 9TD Hemel Hempstead
    Westside 1
    United Kingdom
    EnglandBritishChartered Accountant255996600001
    MACKAY, David James
    4 East Harbour Road
    KY11 3EA Charlestown
    Fife
    Director
    4 East Harbour Road
    KY11 3EA Charlestown
    Fife
    ScotlandBritishCompany Director681850002
    MARTIN, Alan
    Cherry Tree Road
    WD24 6SH Watford
    Hertfordshire
    Director
    Cherry Tree Road
    WD24 6SH Watford
    Hertfordshire
    EnglandBritishAccountant188726960001
    NEEDHAM, Phillip Geoffrey
    Dickens House Charlham Lane
    Down Ampney
    GL7 5RQ Cirencester
    Gloucestershire
    Director
    Dickens House Charlham Lane
    Down Ampney
    GL7 5RQ Cirencester
    Gloucestershire
    BritishCompany Director58920590001
    NOEL-PATON, Frederick Ranald, The Hon
    Easter Dunbarnie
    Bridge Of Earn
    PH2 9ED Perth
    Perthshire
    Director
    Easter Dunbarnie
    Bridge Of Earn
    PH2 9ED Perth
    Perthshire
    BritishCompany Director21482560001
    RAINER, Michael James
    98 Castellain Mansions
    Castellain Road
    W9 1HB London
    Director
    98 Castellain Mansions
    Castellain Road
    W9 1HB London
    United KingdomBritishChartered Accounta14442650003

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de MOTHERCARE TOYS 3 LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    London Road
    HP3 9TD Hemel Hempstead
    Westside 1
    United Kingdom
    06 abr 2016
    London Road
    HP3 9TD Hemel Hempstead
    Westside 1
    United Kingdom
    No
    Forma jurídicaLimited By Shares
    País de registroUnited Kingdom
    Autoridad legalUnited Kingdom
    Lugar de registroCompanies House
    Número de registro00102194
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.
    • La persona tiene el derecho, directa o indirectamente, de nombrar o destituir a la mayoría de la junta directiva de la empresa.

    ¿Tiene MOTHERCARE TOYS 3 LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    A registered charge
    Creado el 17 may 2018
    Entregado el 23 may 2018
    Satisfecho en su totalidad
    Breve descripción
    N/A.
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Hsbc Bank PLC (As Security Agent)
    Transacciones
    • 23 may 2018Registro de una carga (MR01)
    • 06 dic 2021Todo el bien o empresa ha sido liberado de la carga (MR05)
    • 06 dic 2021Satisfacción de una carga (MR04)
    A registered charge
    Creado el 17 may 2018
    Entregado el 23 may 2018
    Satisfecho en su totalidad
    Breve descripción
    N/A.
    La garantía flotante cubre todo:
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía flotante:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Hsbc Bank PLC (As Security Agent)
    Transacciones
    • 23 may 2018Registro de una carga (MR01)
    • 20 may 2019Parte del bien o empresa ha sido liberada y ya no forma parte de la carga (MR05)
    • 06 dic 2021Todo el bien o empresa ha sido liberado de la carga (MR05)
    • 06 dic 2021Satisfacción de una carga (MR04)
    A registered charge
    Creado el 05 may 2017
    Entregado el 12 may 2017
    Satisfecho en su totalidad
    Breve descripción
    N/A.
    La garantía flotante cubre todo:
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía flotante:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Hsbc Bank PLC (As Security Agent)
    Transacciones
    • 12 may 2017Registro de una carga (MR01)
    • 20 may 2019Parte del bien o empresa ha sido liberada y ya no forma parte de la carga (MR05)
    • 06 dic 2021Todo el bien o empresa ha sido liberado de la carga (MR05)
    • 06 dic 2021Satisfacción de una carga (MR04)
    A registered charge
    Creado el 05 may 2017
    Entregado el 12 may 2017
    Satisfecho en su totalidad
    Breve descripción
    N/A.
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Hsbc Bank PLC (As Security Agent)
    Transacciones
    • 12 may 2017Registro de una carga (MR01)
    • 06 dic 2021Todo el bien o empresa ha sido liberado de la carga (MR05)
    • 06 dic 2021Satisfacción de una carga (MR04)
    Share mortgage
    Creado el 18 may 2012
    Entregado el 07 jun 2012
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the each obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    The shares being 100 ordinary share of hk$1 each in the issued share capital of mgsl, constituting the entire issued share capital of mgsl, comprising of 1 ordinary share being held by the chargor and 99 ordinary shares being held by early learning centre limited.
    Personas con derecho
    • Hsbc Bank PLC
    Transacciones
    • 07 jun 2012Registro de un cargo (MG01)
    • 06 dic 2021Todo el bien o empresa ha sido liberado de la carga (MR05)
    • 06 dic 2021Satisfacción de una carga (MR04)
    Security agreement
    Creado el 11 abr 2012
    Entregado el 26 abr 2012
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the obligors under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personas con derecho
    • Hsbc Bank PLC
    Transacciones
    • 26 abr 2012Registro de un cargo (MG01)
    • 20 may 2019Parte del bien o empresa ha sido liberada y ya no forma parte de la carga (MR05)
    • 06 dic 2021Satisfacción de una carga (MR04)
    Guarantee & debenture
    Creado el 11 ago 2006
    Entregado el 30 ago 2006
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from each obligor to the secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    87 high street bedford t/no BD103103 3 hounds hill centre blackpool t/no LA501867 31 lion yard cambridge t/no CB58716 (for details of further properties charged. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • D.C. Thomson & Company Limited
    Transacciones
    • 30 ago 2006Registro de un cargo (395)
    • 17 jul 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Guarantee & debenture
    Creado el 02 abr 2004
    Entregado el 15 abr 2004
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from each obligor to the security trustee and the secured parties (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    87 high street bedford t/n BD103103, 3 hounds hill centre t/n LA501867, 31 lionyard cambridge t/n CB58716 for details of further properties charged please refe. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Agent and Trustee for Itself and for Eachof the Secured Parties
    Transacciones
    • 15 abr 2004Registro de un cargo (395)
    • 17 jul 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 28 sept 2001
    Entregado el 09 oct 2001
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee or any holder of payment in kind notes pursuant to the investment agreement of even date
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • 3I Investments PLC
    Transacciones
    • 09 oct 2001Registro de un cargo (395)
    • 10 abr 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Creado el 28 sept 2001
    Entregado el 05 oct 2001
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All indebtedness liabilities and obligations which are as at 28 september 2001 or may at any time thereafter be due owing or incurred in any manner whatsoever to the bank by any group company on any account whatsoever under the terms of the deed
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 05 oct 2001Registro de un cargo (395)
    • 11 may 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    ¿Tiene MOTHERCARE TOYS 3 LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    25 oct 2022Inicio de la liquidación
    17 may 2024Fecha de disolución
    Liquidación voluntaria de socios
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Ben David Woodthorpe
    22 York Buildings
    WC2N 6JU London
    Profesional
    22 York Buildings
    WC2N 6JU London
    Simon Jagger
    22 York Buildings
    WC2N 6JU London
    Profesional
    22 York Buildings
    WC2N 6JU London

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0