ASSETFINANCE DECEMBER (A) LIMITED

ASSETFINANCE DECEMBER (A) LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaASSETFINANCE DECEMBER (A) LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 01105441
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de ASSETFINANCE DECEMBER (A) LIMITED?

    • Arrendamiento financiero (64910) / Actividades financieras y de seguros

    ¿Dónde se encuentra ASSETFINANCE DECEMBER (A) LIMITED?

    Dirección de la sede social
    8 Canada Square
    London
    E14 5HQ
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de ASSETFINANCE DECEMBER (A) LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    FTBF LEASING DECEMBER (A) LIMITED15 feb 199515 feb 1995
    FORWARD ASSET LEASING DECEMBER (A) LIMITED14 ago 199214 ago 1992
    MIDLAND MONTAGU EQUIPMENT FINANCE LIMITED30 mar 197330 mar 1973

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de ASSETFINANCE DECEMBER (A) LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2014

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para ASSETFINANCE DECEMBER (A) LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Segunda presentación para la terminación de Robin Louise Henning Bencard como director

    5 páginasRP04TM01

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Cese del nombramiento de Robin Louis Henning Bencard como director el 08 ago 2016

    2 páginasTM01
    Anotaciones
    FechaAnotación
    09 sept 2016Clarification A second filed TM01 was registered on 09/09/2016

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    4 páginasDS01

    legacy

    1 páginasSH20

    Resoluciones

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resolución de reducción del capital social emitido

    RES06

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Déclaration annuelle établie au 01 may 2016 avec liste complète des actionnaires

    9 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital05 may 2016

    Estado de capital el 05 may 2016

    • Capital: GBP 50,000
    SH01

    Nombramiento de Mr Simon Einar Long como director el 15 mar 2016

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de David John Cavanna como director el 31 dic 2015

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mr Michael Connelly Anderson como director el 16 dic 2015

    2 páginasAP01

    Renuncia del auditor

    2 páginasAUD

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2014

    19 páginasAA

    Renuncia del auditor

    1 páginasAUD

    Cese del nombramiento de Hannah Elizabeth Shepherd como secretario el 28 may 2015

    1 páginasTM02

    Nombramiento de Ms Romana Lewis como secretario el 28 may 2015

    2 páginasAP03

    Déclaration annuelle établie au 01 may 2015 avec liste complète des actionnaires

    8 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital08 may 2015

    Estado de capital el 08 may 2015

    • Capital: GBP 50,000
    SH01

    Nombramiento de Hannah Elizabeth Shepherd como secretario el 05 ene 2015

    2 páginasAP03

    Cese del nombramiento de Tony Bhambhra como secretario el 05 ene 2015

    1 páginasTM02

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2013

    20 páginasAA

    Nombramiento de Tony Bhambhra como secretario

    2 páginasAP03

    Cese del nombramiento de Katherine Dean como secretario

    1 páginasTM02

    Déclaration annuelle établie au 01 may 2014 avec liste complète des actionnaires

    8 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital08 may 2014

    Estado de capital el 08 may 2014

    • Capital: GBP 50,000
    SH01

    Resoluciones

    Resolutions
    52 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    incorporation

    Resolución del Memorándum de Asociación

    RES01

    ¿Quiénes son los directivos de ASSETFINANCE DECEMBER (A) LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    LEWIS, Romana
    Canada Square
    14th Floor Canary Wharf
    E145HQ London, Greater London
    8
    England
    England
    Secretario
    Canada Square
    14th Floor Canary Wharf
    E145HQ London, Greater London
    8
    England
    England
    198057230001
    ANDERSON, Michael Connelly
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    Director
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    EnglandBritish269666390001
    KENT, John Richard
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    Director
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    United KingdomBritish174308200001
    LONG, Simon Einar
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    Director
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    United KingdomBritish206202590001
    OWEN CONWAY, Gareth
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    Director
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    United KingdomBritish82999960002
    SUBRAMANIYAN, Jaya
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    Director
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    United KingdomMalaysian136924480002
    BAYER, George William
    Flat 1
    Old Bank House, 110 Bermondsey Street
    SE1 3TX London
    Secretario
    Flat 1
    Old Bank House, 110 Bermondsey Street
    SE1 3TX London
    Other123920600002
    BHAMBHRA, Tony
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    Secretario
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    187824150001
    DEAN, Katherine
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    Secretario
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    180092200001
    GOTT, Sarah Caroline
    Whitworth Street
    SE10 9EN London
    13
    United Kingdom
    Secretario
    Whitworth Street
    SE10 9EN London
    13
    United Kingdom
    British136485400005
    MCKENZIE, John Hume
    37 Lime Trees
    Staplehurst
    TN12 0SS Tonbridge
    Kent
    Secretario
    37 Lime Trees
    Staplehurst
    TN12 0SS Tonbridge
    Kent
    British67406010001
    MCQUILLAN, Pauline Louise
    1 Bolney Court
    Portsmouth Road
    KT6 4HX Surbiton
    Surrey
    Secretario
    1 Bolney Court
    Portsmouth Road
    KT6 4HX Surbiton
    Surrey
    British109247130001
    MCQUILLAN, Pauline Louise
    1 Bolney Court
    Portsmouth Road
    KT6 4HX Surbiton
    Surrey
    Secretario
    1 Bolney Court
    Portsmouth Road
    KT6 4HX Surbiton
    Surrey
    British109247130001
    MUSGROVE, Robert Hugh
    6 Barn Meadow
    Staplehurst
    TN12 0SY Tonbridge
    Kent
    Secretario
    6 Barn Meadow
    Staplehurst
    TN12 0SY Tonbridge
    Kent
    Other76913670001
    NIVEN, Frances Julie
    73 Celestial Gardens
    SE13 5RU London
    Secretario
    73 Celestial Gardens
    SE13 5RU London
    British78670270001
    PEARCE, Mark Vivian
    55 Huntly Road
    Talbot Woods
    BH3 7HG Bournemouth
    Dorset
    Secretario
    55 Huntly Road
    Talbot Woods
    BH3 7HG Bournemouth
    Dorset
    British26776940002
    READ, Alice
    188 Berglen Court
    7 Branch Road
    E14 7JZ London
    Secretario
    188 Berglen Court
    7 Branch Road
    E14 7JZ London
    British106168980003
    SHEPHERD, Hannah Elizabeth
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    Secretario
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    194209400001
    SHEPHERD, Hannah Elizabeth
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    Secretario
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    154911860001
    WOOD, Hollie Rheanna
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    Secretario
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    166967460001
    BARKER, Fiona Ann
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    Director
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    United KingdomBritish151858510001
    BENCARD, Robin Louis Henning
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    Director
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    United KingdomBritish46782110002
    BROOKES, Malcolm James
    3 School Close
    Pinvin
    WR10 2TZ Pershore
    Worcestershire
    Director
    3 School Close
    Pinvin
    WR10 2TZ Pershore
    Worcestershire
    British61727900003
    CARNEY, Brian
    Springwood Lodge
    Owler Park Road
    LS29 0BG Ilkley
    West Yorkshire
    Director
    Springwood Lodge
    Owler Park Road
    LS29 0BG Ilkley
    West Yorkshire
    British100001170001
    CAVANNA, David John
    8 Canada Square
    London
    E14 5HQ
    Director
    8 Canada Square
    London
    E14 5HQ
    United KingdomBritish180384720001
    EVANS, Geoffrey William
    The Trumpet House Kington Lane
    Claverdon
    CV35 8PP Warwick
    Director
    The Trumpet House Kington Lane
    Claverdon
    CV35 8PP Warwick
    British42712190001
    GILMAN, David William
    32 Riverside Drive
    Selly Oak
    B29 7ES Birmingham
    Director
    32 Riverside Drive
    Selly Oak
    B29 7ES Birmingham
    British5681410002
    HARRIS, Christopher David
    8 Verdon Place
    Barford
    CV35 8BT Warwick
    Director
    8 Verdon Place
    Barford
    CV35 8BT Warwick
    British28742940002
    HOLMES, Timothy Victor
    18 The Badgers
    Mearse Lane Barnt Green
    B45 8QR Birmingham
    Director
    18 The Badgers
    Mearse Lane Barnt Green
    B45 8QR Birmingham
    British28497420002
    KELL, Christopher Raymond
    6 Gorse Close
    WR9 7SG Droitwich
    Worcestershire
    Director
    6 Gorse Close
    WR9 7SG Droitwich
    Worcestershire
    British87307470001
    KENNY, Mary Bridget
    178 Empire Square West
    Long Lane
    SE1 4NL London
    Director
    178 Empire Square West
    Long Lane
    SE1 4NL London
    United KingdomBritish118995490002
    LANE, Robert David
    42 Bridgnorth Road
    WV5 0AA Wombourne
    Staffordshire
    Director
    42 Bridgnorth Road
    WV5 0AA Wombourne
    Staffordshire
    EnglandBritish150099050001
    LEECH, Ian Robert
    139 Lordswood Road
    Harborne
    B17 9BL Birmingham
    Director
    139 Lordswood Road
    Harborne
    B17 9BL Birmingham
    British52909330001
    LESTER, Edward Paul
    26 St Barnabas Road
    CB1 2BY Cambridge
    Cambridgeshire
    Director
    26 St Barnabas Road
    CB1 2BY Cambridge
    Cambridgeshire
    British4300370001
    MEAD, David Harry
    Willowbank
    Pirton
    WR8 9ED Worcester
    Worcestershire
    Director
    Willowbank
    Pirton
    WR8 9ED Worcester
    Worcestershire
    EnglandBritish254170760001

    ¿Tiene ASSETFINANCE DECEMBER (A) LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Amended and restated intercreditor agreement
    Creado el 19 dic 1997
    Entregado el 31 dic 1997
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    In favour of chase manhattan international limited as security agent and trustee for the senior creditors (as defined) and the lessors (as defined) (1)the senior debt, subject to clause 11.2, clause 11.4, clause 27.3(iii) and clause 27.4(b) of the intercreditor agreement all present and future liabilities (actual or contingent) payable or owing by the obligors to the senior creditors under or in connection with the senior finance documents (as defined), (2)the lease debt, all present and future liabilities (actual or contingent) payable or owing by the obligors to the lessors under or in connection with the lease finance documents (as defined) and (3) the subordinated debt, all present and future liabilities (actual or contingent) payable or owing by the obligors to the subordinated creditors (as defined) under or in connection with the subordinated debt documents or in connection with treasury debt and all indemnity rights
    Breve descripción
    If at any time prior to the later of the senior discharge date the company receives a payment or distribution in cash or kind of or on account of any lease debt or prior to the senior discharge date any lease debt is discharged in each case in a manner not permitted by clause 6 (permitted lease payments) by clause 7 (permitted subordinated payments) or clause 15.1 (permitted lease enforcement) clause 15.2 (permitted enforcement action in respect of vat) or by clause 17 (proceeds of enforcement of security) the company will subject to clause 10.9 (exclusion of trust) hold such recovery payment distribution proceeds set-off or other amount in trust for the security trustee.
    Personas con derecho
    • Chase Manhattan International Limited
    Transacciones
    • 31 dic 1997Registro de un cargo (395)
    Chattel mortgage
    Creado el 19 dic 1997
    Entregado el 31 dic 1997
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the chattel mortgage under and in accordance with clause 4 (sales representative) of the direct agreement
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the english assets ,the scottish assets and the northern irish assets including the sale proceeds thereof for full details of charged assets please refer to form 395.
    Personas con derecho
    • Chase Manhattan International Limited
    Transacciones
    • 31 dic 1997Registro de un cargo (395)
    Lessor's security assignment (as defined)
    Creado el 19 dic 1996
    Entregado el 27 dic 1996
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All or any obligations and liabilities of the company to the chargee to apply or to procure the application of relevant proceeds under or pursuant to the provisions of clauses 15.2(b),19.3(b),21.3(b),24 and schedule 6 of the lease and to sell the vessel or to execute a purchase contract transfer under or pursuant to clause 23 of the lease and under this mortgage
    Breve descripción
    All rights,title and interest in respect of clause 5.1 of the conditional sale agreement to acquire ownership of the vessel "hull 1233". see the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Samoco 1233 Trust
    Transacciones
    • 27 dic 1996Registro de un cargo (395)
    • 12 feb 2009Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Mortgage
    Creado el 10 dic 1996
    Entregado el 20 dic 1996
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All or any obligations and liabilities of the company to the chargee to apply or to procure the application of relevant proceeds under or pursuant to the provisions of clauses 15.2(b),19.3(b),21.3(b),24 and schedule 6 of the lease and to sell the vessel or to execute a purchase contract transfer under or pursuant to clause 23 of the lease and under this mortgage
    Breve descripción
    All rights,title,interest,insurances and proceeds of sale in the vessel "hull 1233". see the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Samoco 1233 Trust
    Transacciones
    • 20 dic 1996Registro de un cargo (395)
    • 12 feb 2009Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0