LLOYDS DEVELOPMENT CAPITAL (HOLDINGS) LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | LLOYDS DEVELOPMENT CAPITAL (HOLDINGS) LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Activa |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 01107542 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | No |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de LLOYDS DEVELOPMENT CAPITAL (HOLDINGS) LIMITED?
- Otras actividades de apoyo a los negocios n.c.p. (82990) / Actividades administrativas y de apoyo
¿Dónde se encuentra LLOYDS DEVELOPMENT CAPITAL (HOLDINGS) LIMITED?
| Dirección de la sede social | One Vine Street W1J 0AH London |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de LLOYDS DEVELOPMENT CAPITAL (HOLDINGS) LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| LLOYDS TSB DEVELOPMENT CAPITAL LIMITED | 01 mar 1999 | 01 mar 1999 |
| LLOYDS DEVELOPMENT CAPITAL LIMITED | 17 jun 1985 | 17 jun 1985 |
| PEGASUS HOLDINGS LIMITED | 31 dic 1981 | 31 dic 1981 |
| LLOYDS LEASING (LOMBARD STREET NOMINEES) LIMITED | 11 abr 1973 | 11 abr 1973 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de LLOYDS DEVELOPMENT CAPITAL (HOLDINGS) LIMITED?
| Vencido | No |
|---|---|
| Próximas cuentas | |
| Próximo período contable finaliza el | 31 dic 2025 |
| Próximas cuentas vencen el | 30 sept 2026 |
| Últimas cuentas | |
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2024 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para LLOYDS DEVELOPMENT CAPITAL (HOLDINGS) LIMITED?
| Última declaración de confirmación cerrada hasta | 20 feb 2027 |
|---|---|
| Pr óxima declaración de confirmación vence | 06 mar 2027 |
| Última declaración de confirmación | |
| Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 20 feb 2026 |
| Vencido | No |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para LLOYDS DEVELOPMENT CAPITAL (HOLDINGS) LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Declaración de confirmación presentada el 20 feb 2026 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2024 | 46 páginas | AA | ||
Cambio de datos del secretario Mrs Alyson Elizabeth Mulholland el 12 may 2025 | 1 páginas | CH03 | ||
Declaración de confirmación presentada el 20 feb 2025 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2023 | 43 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 20 feb 2024 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2022 | 43 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 13 abr 2023 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2021 | 42 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 13 abr 2022 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cambio de datos del director Mr Alan Toby Rougier el 07 ene 2022 | 2 páginas | CH01 | ||
Cese del nombramiento de Martin John Draper como director el 31 dic 2021 | 1 páginas | TM01 | ||
Nombramiento de Mrs Ann Maria Kenny como director el 08 dic 2021 | 2 páginas | AP01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2020 | 40 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 13 abr 2021 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cese del nombramiento de Christopher Richard Hurley como director el 03 feb 2021 | 1 páginas | TM01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2019 | 38 páginas | AA | ||
Nombramiento de Mrs Alyson Elizabeth Mulholland como secretario el 14 may 2020 | 2 páginas | AP03 | ||
Cese del nombramiento de David Dermot Hennessey como secretario el 14 may 2020 | 1 páginas | TM02 | ||
Declaración de confirmación presentada el 13 abr 2020 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
La dirección de inspección del registro se ha cambiado de Tower House Charterhall Drive Chester CH88 3AN United Kingdom a Cawley House Chester Business Park Chester CH4 9FB | 1 páginas | AD02 | ||
Cambio de datos del secretario Mr David Dermot Hennessey el 04 nov 2019 | 1 páginas | CH03 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2018 | 40 páginas | AA | ||
Nombramiento de Mr William Leon David Chalmers como director el 12 sept 2019 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de Mark George Culmer como director el 01 ago 2019 | 1 páginas | TM01 | ||
¿Quiénes son los directivos de LLOYDS DEVELOPMENT CAPITAL (HOLDINGS) LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MULHOLLAND, Alison Elizabeth | Secretario | Chester Business Park CH4 9FB Chester Cawley House United Kingdom | 270134950002 | |||||||
| CHALMERS, William Leon David | Director | Gresham Street EC2V 7HN London 25 United Kingdom | United Kingdom | British | 261222830001 | |||||
| KENNY, Ann Maria | Director | W1J 0AH London One Vine Street United Kingdom | United Kingdom | Irish | 290578080001 | |||||
| ROUGIER, Alan Toby | Director | W1J 0AH London One Vine Street United Kingdom | United Kingdom | British | 108954830002 | |||||
| BOSTON, Marc-John | Secretario | Gresham Street EC2V 7HN London 25 United Kingdom | 157785550001 | |||||||
| GITTINS, Paul | Secretario | Charterhall Drive CH88 3AN Chester Tower House United Kingdom | 196766850001 | |||||||
| HATCHER, Michael Roger | Secretario | Hunyani Ardleigh Road Little Bromley CO11 2QA Manningtree Essex | British | 6759000002 | ||||||
| HENNESSEY, David Dermot | Secretario | Chester Business Park CH4 9FB Chester Cawley House United Kingdom | 247840790001 | |||||||
| HOPKINS, Stephen John | Secretario | 25 Gresham Street EC2V 7HN London | British | 39632020002 | ||||||
| TAYLOR, Kevin Rohan | Secretario | Gresham Street EC2V 7HN London 25 United Kingdom | 184106620001 | |||||||
| BACON, Nicholas Andrew William | Director | Shaftesbury House Clover Hill Old Warwick Road, Lapworth B94 6JY Solihull West Midlands | United Kingdom | British | 159081540001 | |||||
| BALL, Andrew Derek | Director | The Barn 3 Devonshire House BD20 8EU Lothersdale Keighley | United Kingdom | British | 93558090001 | |||||
| BERRY, Grant Rostron | Director | 54 Carrwood Road Pownall Park SK9 5DN Wilmslow Cheshire | England | British | 93319000002 | |||||
| BESTER, Andrew John Milton | Director | Gresham Street EC2V 7HN London 25 United Kingdom | United Kingdom | British | 176754250001 | |||||
| BIRCH, Ian Gregory | Director | Little Pond Cottage Bisterne Close Burley BH24 4AZ Ringwood Hampshire | British | 58137370001 | ||||||
| BROOKS, Peter John Sutton | Director | 1st Floor 28 Kempe Road Queens Park NW6 6SJ London | United Kingdom | British | 41626680001 | |||||
| BROWN, Paul Gregorius | Director | Royal York House Flat 7 Royal York Villas Clifton BS8 4SR Bristol | British | 10791010003 | ||||||
| BUDDLE, John David | Director | Brambledene Tabley Cottages Tidebrook Road TN5 6LH Wadhurst East Sussex | British | 49745030001 | ||||||
| BURNS, Ian Thomas | Director | Amadeus 26a Hollow Way Lane Chesham Bois HP6 6DJ Amersham Bucks | England | British | 27981710001 | |||||
| CARLE, Steven Alexander Anderson | Director | 14 Western Road RG9 1JL Henley On Thames Oxfordshire | United Kingdom | British | 98131030001 | |||||
| CARPENTER, Keith George | Director | Brock Place The Rise SO42 7SJ Brockenhurst Hampshire | British | 8851690002 | ||||||
| CARPENTER, Keith George | Director | 19 Crosby Hill Drive GU15 3TZ Camberley Surrey | British | 8851690001 | ||||||
| CARR, Julian Edward | Director | 23 Prebend Gardens Chiswick W4 1TN London | United Kingdom | British | 141307960001 | |||||
| CLARKE, David Clarence | Director | Hyde Park Residence 55 Park Lane W1Y 3DB London | New Zealand | 65056500001 | ||||||
| CRAWLEY, Frederick William | Director | 4 The Hexagon Fitzroy Park N6 6HR London | Scotland | British | 464490001 | |||||
| CULMER, Mark George | Director | Gresham Street EC2V 7HN London 25 United Kingdom | England | British | 98008120001 | |||||
| DALE, Bernard John | Director | Clyde House 23 Westgate NG25 0JN Southwell Nottinghamshire | England | British | 106438400001 | |||||
| DEMPSEY, Simon Joseph | Director | Main Road Wigginton B79 9DS Tamworth The Old Vicarage Staffs | England | United Kingdom | 113103110003 | |||||
| DILLON, John Eamon | Director | 25 Park Avenue B91 3EJ Solihull West Midlands | British | 54871970004 | ||||||
| DRAPER, Martin John | Director | W1J 0AH London One Vine Street United Kingdom | United Kingdom | British | 99906900004 | |||||
| EALES, Darryl Charles | Director | W1J 0AH London One Vine Street United Kingdom | England | British | 154807060001 | |||||
| EVANS, Philip Arthur | Director | Endicott Busbridge Lane GU7 1PU Godalming Surrey | British | 27318970001 | ||||||
| FARAZMAND, Timothy Bahram Neville | Director | Sandhurst Road DA15 7HL Sidcup 19 Kent | United Kingdom | British | 41057030002 | |||||
| FREER, Mark Stephen | Director | Park House 35 Barker Road Four Oaks B74 2NZ Sutton Coldfield West Midlands | England | British | 111975330001 | |||||
| GECZY, Andrew William | Director | Gresham Street EC2V 7AE London 10 United Kingdom | United Kingdom | American | 82820480001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de LLOYDS DEVELOPMENT CAPITAL (HOLDINGS) LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lbg Equity Investments Limited | 24 nov 2017 | Gresham Street EC2V 7HN London 25 United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
| Lloyds Bank Plc | 06 abr 2016 | Gresham Street EC2V 7HN London 25 United Kingdom | Sí | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0