JENWAY LIMITED
Visión general
Nombre de la empresa | JENWAY LIMITED |
---|---|
Estado de la empresa | Disuelta |
Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
Número de empresa | 01119693 |
Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
Fecha de constitución | |
Fecha de cese |
Resumen
Tiene PSCs súper seguros | No |
---|---|
Tiene gravámenes | Sí |
Tiene historial de insolvencia | No |
La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de JENWAY LIMITED?
- Compañía no comercial (74990) / Actividades profesionales, científicas y técnicas
¿Dónde se encuentra JENWAY LIMITED?
Dirección de la sede social | 4 Felstead Gardens Ferry Street E14 3BS London |
---|---|
Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles son las últimas cuentas de JENWAY LIMITED?
Últimas cuentas | |
---|---|
Últimas cuentas cerradas hasta | 30 sept 2013 |
¿Cuál es el estado de la última declaración anual para JENWAY LIMITED?
Declaración anual |
|
---|
¿Cuáles son las últimas presentaciones para JENWAY LIMITED?
Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 3 páginas | DS01 | ||||||||||||||
Todo el bien o empresa ha sido liberado de la carga 5 | 2 páginas | MR05 | ||||||||||||||
Cambio de datos del director Michael Eric Nevin el 01 jun 2015 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||||||
Cese del nombramiento de Adam David Robson como director el 12 abr 2015 | TM01 | |||||||||||||||
Déclaration annuelle établie au 04 ene 2015 avec liste complète des actionnaires | 5 páginas | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Cambio de datos del director Michael Eric Nevin el 09 oct 2014 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||||||
legacy | 1 páginas | SH20 | ||||||||||||||
legacy | 1 páginas | CAP-SS | ||||||||||||||
Resoluciones Resolutions | RESOLUTIONS | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Déclaration annuelle établie au 04 ene 2014 avec liste complète des actionnaires | 5 páginas | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 sept 2013 | 5 páginas | AA | ||||||||||||||
Déclaration annuelle établie au 04 ene 2013 avec liste complète des actionnaires | 5 páginas | AR01 | ||||||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 sept 2012 | 5 páginas | AA | ||||||||||||||
Cambio de datos del director Adam David Robson el 15 feb 2012 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||||||
Cambio de datos del director Adam David Robson el 15 feb 2012 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||||||
Déclaration annuelle établie au 04 ene 2012 avec liste complète des actionnaires | 5 páginas | AR01 | ||||||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 sept 2011 | 5 páginas | AA | ||||||||||||||
Déclaration annuelle établie au 04 ene 2011 avec liste complète des actionnaires | 5 páginas | AR01 | ||||||||||||||
Cambio de datos del director Adam David Robson el 06 dic 2010 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||||||
Cambio de datos del director Michael Eric Nevin el 06 dic 2010 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 sept 2010 | 5 páginas | AA | ||||||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 sept 2009 | 6 páginas | AA | ||||||||||||||
Déclaration annuelle établie au 04 ene 2010 avec liste complète des actionnaires | 5 páginas | AR01 | ||||||||||||||
¿Quiénes son los directivos de JENWAY LIMITED?
Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAMESTOWN INVESTMENTS LIMITED | Secretario corporativo | 4 Felstead Gardens Ferry Street E14 3BS London | 43844040001 | |||||||
NEVIN, Michael Eric | Director | Suite 1924 Bressenden Place SW1E 5RS London Portland House United Kingdom | United Kingdom | British | Investment Partner | 112409940001 | ||||
BASHFORD, Sidney George | Secretario | Janroma Bartholomew Green CM3 1QG Chelmsford Essex | British | 2938770002 | ||||||
BEAN, Roger James | Secretario | 10 Highwood Close SL7 3PG Marlow Buckinghamshire | British | 8855620001 | ||||||
CULSHAW, Alasdair Douglas | Secretario | 20 Old Malt Way Horsell GU21 4QD Woking Surrey | British | Director | 5333430001 | |||||
FAHY, Michael Jon | Secretario | 2 Farm Crescent Napsbury Park AL2 1UQ St Albans Hertfordshire | British | Company Secretary | 12938290003 | |||||
MORTON, John George | Secretario | 13 Fermoy Road SS1 3HA Southend On Sea Essex | British | Fund Accountant | 45914390002 | |||||
SMITH, Eugene Luke | Secretario | 33 The Oaks KT14 6RN West Byfleet Surrey | British | Finance Director | 55201820001 | |||||
BANNISTER, Andrew Charles | Director | Buckleigh Oval Way SL9 8QB Gerrards Cross Buckinghamshire | England | British | Finance Director | 64381410001 | ||||
BASHFORD, Sidney George | Director | Janroma Bartholomew Green CM3 1QG Chelmsford Essex | British | Electronics Engineer | 2938770002 | |||||
BOYD, Simon John | Director | The Stables Millfarm Black Bourton OX18 2PE Bampton Oxfordshire | British | Company Director | 59715820002 | |||||
CHRISTIE, James Archibald | Director | Belmont 2 Plums Lane Bardfield Saling CM7 5EH Braintree Essex | British | Managing Director | 14773320002 | |||||
CULSHAW, Alasdair Douglas | Director | 20 Old Malt Way Horsell GU21 4QD Woking Surrey | British | Director | 5333430001 | |||||
DE FLORIN, Jill Wendy | Director | Lower Lodge Hope End HR8 1JG Ledbury Herefordshire | British | Company Director | 14773310001 | |||||
FAHY, Michael Jon | Director | 2 Farm Crescent Napsbury Park AL2 1UQ St Albans Hertfordshire | United Kingdom | British | Company Secretary | 12938290003 | ||||
FALL, Martyn John | Director | Slough Farm Stambourne CO9 4PD Halstead Essex | England | British | Managing Director | 106960880001 | ||||
HART, Paul Clifford | Director | 11 Bulford Lane Black Notley CM7 8NW Braintree Essex | England | British | Manufacturing Director | 164220500001 | ||||
HORSFIELD, Philip | Director | Woodbine Cottage Priest Hutton LA6 1JL Carnforth Lancashire | British | Finance Director | 1842690001 | |||||
JONES, Kathryn Ada | Director | 11b Osward Road SW17 7SS London | United Kingdom | British | Investment Associate | 117914790001 | ||||
MAY, Richard Michael | Director | Garretts Garretts Lane Shalford CM7 5BA Braintree Essex | British | Chairman | 30835240001 | |||||
MAYBURY, Peter Joseph | Director | Glenburn 13 Riddings Road Hale WA15 9DS Altrincham Cheshire | England | British | Chief Executive | 2889740001 | ||||
O'CONNOR, Christopher James | Director | Canterbury House 191 Huntingdon Road CB3 0DL Cambridge Cambridgeshire | England | British | Managing Director | 126446780001 | ||||
PARTRIDGE, David John | Director | Beauchamp House 26 Leam Terrace CV31 1BB Leamington Spa Warwickshire | British | Director | 3880730002 | |||||
PERROTT, Hugh Richard Iliff | Director | Gilletts Farm Oast Water Lane TN27 8QB Smarden Kent | British | Company Director | 61012290001 | |||||
POSSEE, David Rowland | Director | 22 Stubbs Lane CM7 3NR Braintree Essex | British | Accountant | 77192600001 | |||||
RAMPTON, Geoffrey Roy | Director | Gunn Cottage Station Road South Leigh OX8 6XJ Witney Oxfordshire | British | Director | 12413300001 | |||||
ROBSON, Adam David | Director | Floor Cayzer House 30 Buckingham Gate SW1E 6NN London 1st United Kingdom | England | British | Operating Partner | 125503850001 | ||||
RUTHERFORD, James | Director | 97 High Street CB2 5QB Harston Cambridgeshire | British | Director | 92778600001 | |||||
SMITH, Desmond John | Director | 5 The Rettery Hoxne Road IT23 7NJ Eye Suffolk | British | Director | 57814530001 | |||||
SMITH, Eugene Luke | Director | 33 The Oaks KT14 6RN West Byfleet Surrey | England | British | Finance Director | 55201820001 | ||||
SPINK, Geoffrey | Director | Fiddlers Green Clandon Road, West Clandon GU4 7TL Guildford Surrey | United Kingdom | British | Director | 84940730001 | ||||
WHEELER, Mervyn James | Director | 43 Nether Court CO9 2HN Halstead Essex | British | Sales Director | 14773330001 | |||||
WICKS, Jonathon Neil | Director | 2 Northbrook Copse Forest Park RG12 0UA Bracknell Berkshire | England | British | Company Director | 56518060001 | ||||
WYNN, Edward Charles | Director | 34 Windmill Lane DE6 1EY Ashbourne Derbyshire | United Kingdom | British | Sales And Marketing Director | 60801950001 |
¿Tiene JENWAY LIMITED alguna carga?
Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
---|---|---|---|---|
Deed of accession | Creado el 30 nov 2007 Entregado el 08 dic 2007 | Pendiente | Cantidad garantizada All monies due or to become due from any obligor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción The mortgaged property means the real property listed in the schedule 2 to the debenture, fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
A credit agreement entitled "prompt credit application" | Creado el 19 ago 1993 Entregado el 01 sept 1993 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada £19,176.35 due from the company to the chargee under the terms of the agreement | |
Breve descripción All its right title and interest in and to all sums payable under the insurance. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Fixed charge over book debts | Creado el 18 dic 1990 Entregado el 29 dic 1990 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a factoring agreement leasing agreement or on any account whatsoever. | |
Breve descripción The ultimate balance due or owing to the company by tih under any present or future factoring agreement providing for the purchase by tih of book debts of the company. All other book and other debts and claims both present and future. (Please see doc M395 for full details). | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Legal mortgage | Creado el 22 nov 1990 Entregado el 26 nov 1990 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Breve descripción The cottage gransmore green, felsted, essex. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Legal mortgage | Creado el 24 ago 1978 Entregado el 13 sept 1978 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Land & factory premises at grasmore green felsted essex. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0