JENWAY LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Cuentas
  • Declaración anual
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaJENWAY LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 01119693
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de JENWAY LIMITED?

    • Compañía no comercial (74990) / Actividades profesionales, científicas y técnicas

    ¿Dónde se encuentra JENWAY LIMITED?

    Dirección de la sede social
    4 Felstead Gardens
    Ferry Street
    E14 3BS London
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de JENWAY LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta30 sept 2013

    ¿Cuál es el estado de la última declaración anual para JENWAY LIMITED?

    Declaración anual
    Última declaración anual

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para JENWAY LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Todo el bien o empresa ha sido liberado de la carga 5

    2 páginasMR05

    Cambio de datos del director Michael Eric Nevin el 01 jun 2015

    2 páginasCH01

    Cese del nombramiento de Adam David Robson como director el 12 abr 2015

    TM01

    Déclaration annuelle établie au 04 ene 2015 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital02 feb 2015

    Estado de capital el 02 feb 2015

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Cambio de datos del director Michael Eric Nevin el 09 oct 2014

    2 páginasCH01

    legacy

    1 páginasSH20

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Resoluciones

    Resolutions
    RESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    incorporation

    Resolución de modificación de los Artículos de Asociación

    RES01
    capital

    Resolución de reducción del capital social emitido

    RES06

    Déclaration annuelle établie au 04 ene 2014 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital23 ene 2014

    Estado de capital el 23 ene 2014

    • Capital: GBP 415,639
    SH01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 sept 2013

    5 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 04 ene 2013 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 sept 2012

    5 páginasAA

    Cambio de datos del director Adam David Robson el 15 feb 2012

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del director Adam David Robson el 15 feb 2012

    2 páginasCH01

    Déclaration annuelle établie au 04 ene 2012 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 sept 2011

    5 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 04 ene 2011 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01

    Cambio de datos del director Adam David Robson el 06 dic 2010

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del director Michael Eric Nevin el 06 dic 2010

    2 páginasCH01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 sept 2010

    5 páginasAA

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 sept 2009

    6 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 04 ene 2010 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01

    ¿Quiénes son los directivos de JENWAY LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    JAMESTOWN INVESTMENTS LIMITED
    4 Felstead Gardens
    Ferry Street
    E14 3BS London
    Secretario corporativo
    4 Felstead Gardens
    Ferry Street
    E14 3BS London
    43844040001
    NEVIN, Michael Eric
    Suite 1924
    Bressenden Place
    SW1E 5RS London
    Portland House
    United Kingdom
    Director
    Suite 1924
    Bressenden Place
    SW1E 5RS London
    Portland House
    United Kingdom
    United KingdomBritishInvestment Partner112409940001
    BASHFORD, Sidney George
    Janroma
    Bartholomew Green
    CM3 1QG Chelmsford
    Essex
    Secretario
    Janroma
    Bartholomew Green
    CM3 1QG Chelmsford
    Essex
    British2938770002
    BEAN, Roger James
    10 Highwood Close
    SL7 3PG Marlow
    Buckinghamshire
    Secretario
    10 Highwood Close
    SL7 3PG Marlow
    Buckinghamshire
    British8855620001
    CULSHAW, Alasdair Douglas
    20 Old Malt Way
    Horsell
    GU21 4QD Woking
    Surrey
    Secretario
    20 Old Malt Way
    Horsell
    GU21 4QD Woking
    Surrey
    BritishDirector5333430001
    FAHY, Michael Jon
    2 Farm Crescent
    Napsbury Park
    AL2 1UQ St Albans
    Hertfordshire
    Secretario
    2 Farm Crescent
    Napsbury Park
    AL2 1UQ St Albans
    Hertfordshire
    BritishCompany Secretary12938290003
    MORTON, John George
    13 Fermoy Road
    SS1 3HA Southend On Sea
    Essex
    Secretario
    13 Fermoy Road
    SS1 3HA Southend On Sea
    Essex
    BritishFund Accountant45914390002
    SMITH, Eugene Luke
    33 The Oaks
    KT14 6RN West Byfleet
    Surrey
    Secretario
    33 The Oaks
    KT14 6RN West Byfleet
    Surrey
    BritishFinance Director55201820001
    BANNISTER, Andrew Charles
    Buckleigh
    Oval Way
    SL9 8QB Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Director
    Buckleigh
    Oval Way
    SL9 8QB Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    EnglandBritishFinance Director64381410001
    BASHFORD, Sidney George
    Janroma
    Bartholomew Green
    CM3 1QG Chelmsford
    Essex
    Director
    Janroma
    Bartholomew Green
    CM3 1QG Chelmsford
    Essex
    BritishElectronics Engineer2938770002
    BOYD, Simon John
    The Stables
    Millfarm Black Bourton
    OX18 2PE Bampton
    Oxfordshire
    Director
    The Stables
    Millfarm Black Bourton
    OX18 2PE Bampton
    Oxfordshire
    BritishCompany Director59715820002
    CHRISTIE, James Archibald
    Belmont
    2 Plums Lane Bardfield Saling
    CM7 5EH Braintree
    Essex
    Director
    Belmont
    2 Plums Lane Bardfield Saling
    CM7 5EH Braintree
    Essex
    BritishManaging Director14773320002
    CULSHAW, Alasdair Douglas
    20 Old Malt Way
    Horsell
    GU21 4QD Woking
    Surrey
    Director
    20 Old Malt Way
    Horsell
    GU21 4QD Woking
    Surrey
    BritishDirector5333430001
    DE FLORIN, Jill Wendy
    Lower Lodge
    Hope End
    HR8 1JG Ledbury
    Herefordshire
    Director
    Lower Lodge
    Hope End
    HR8 1JG Ledbury
    Herefordshire
    BritishCompany Director14773310001
    FAHY, Michael Jon
    2 Farm Crescent
    Napsbury Park
    AL2 1UQ St Albans
    Hertfordshire
    Director
    2 Farm Crescent
    Napsbury Park
    AL2 1UQ St Albans
    Hertfordshire
    United KingdomBritishCompany Secretary12938290003
    FALL, Martyn John
    Slough Farm
    Stambourne
    CO9 4PD Halstead
    Essex
    Director
    Slough Farm
    Stambourne
    CO9 4PD Halstead
    Essex
    EnglandBritishManaging Director106960880001
    HART, Paul Clifford
    11 Bulford Lane
    Black Notley
    CM7 8NW Braintree
    Essex
    Director
    11 Bulford Lane
    Black Notley
    CM7 8NW Braintree
    Essex
    EnglandBritishManufacturing Director164220500001
    HORSFIELD, Philip
    Woodbine Cottage
    Priest Hutton
    LA6 1JL Carnforth
    Lancashire
    Director
    Woodbine Cottage
    Priest Hutton
    LA6 1JL Carnforth
    Lancashire
    BritishFinance Director1842690001
    JONES, Kathryn Ada
    11b Osward Road
    SW17 7SS London
    Director
    11b Osward Road
    SW17 7SS London
    United KingdomBritishInvestment Associate117914790001
    MAY, Richard Michael
    Garretts Garretts Lane
    Shalford
    CM7 5BA Braintree
    Essex
    Director
    Garretts Garretts Lane
    Shalford
    CM7 5BA Braintree
    Essex
    BritishChairman30835240001
    MAYBURY, Peter Joseph
    Glenburn 13 Riddings Road
    Hale
    WA15 9DS Altrincham
    Cheshire
    Director
    Glenburn 13 Riddings Road
    Hale
    WA15 9DS Altrincham
    Cheshire
    EnglandBritishChief Executive2889740001
    O'CONNOR, Christopher James
    Canterbury House
    191 Huntingdon Road
    CB3 0DL Cambridge
    Cambridgeshire
    Director
    Canterbury House
    191 Huntingdon Road
    CB3 0DL Cambridge
    Cambridgeshire
    EnglandBritishManaging Director126446780001
    PARTRIDGE, David John
    Beauchamp House 26 Leam Terrace
    CV31 1BB Leamington Spa
    Warwickshire
    Director
    Beauchamp House 26 Leam Terrace
    CV31 1BB Leamington Spa
    Warwickshire
    BritishDirector3880730002
    PERROTT, Hugh Richard Iliff
    Gilletts Farm Oast
    Water Lane
    TN27 8QB Smarden
    Kent
    Director
    Gilletts Farm Oast
    Water Lane
    TN27 8QB Smarden
    Kent
    BritishCompany Director61012290001
    POSSEE, David Rowland
    22 Stubbs Lane
    CM7 3NR Braintree
    Essex
    Director
    22 Stubbs Lane
    CM7 3NR Braintree
    Essex
    BritishAccountant77192600001
    RAMPTON, Geoffrey Roy
    Gunn Cottage
    Station Road South Leigh
    OX8 6XJ Witney
    Oxfordshire
    Director
    Gunn Cottage
    Station Road South Leigh
    OX8 6XJ Witney
    Oxfordshire
    BritishDirector12413300001
    ROBSON, Adam David
    Floor
    Cayzer House 30 Buckingham Gate
    SW1E 6NN London
    1st
    United Kingdom
    Director
    Floor
    Cayzer House 30 Buckingham Gate
    SW1E 6NN London
    1st
    United Kingdom
    EnglandBritishOperating Partner125503850001
    RUTHERFORD, James
    97 High Street
    CB2 5QB Harston
    Cambridgeshire
    Director
    97 High Street
    CB2 5QB Harston
    Cambridgeshire
    BritishDirector92778600001
    SMITH, Desmond John
    5 The Rettery
    Hoxne Road
    IT23 7NJ Eye
    Suffolk
    Director
    5 The Rettery
    Hoxne Road
    IT23 7NJ Eye
    Suffolk
    BritishDirector57814530001
    SMITH, Eugene Luke
    33 The Oaks
    KT14 6RN West Byfleet
    Surrey
    Director
    33 The Oaks
    KT14 6RN West Byfleet
    Surrey
    EnglandBritishFinance Director55201820001
    SPINK, Geoffrey
    Fiddlers Green
    Clandon Road, West Clandon
    GU4 7TL Guildford
    Surrey
    Director
    Fiddlers Green
    Clandon Road, West Clandon
    GU4 7TL Guildford
    Surrey
    United KingdomBritishDirector84940730001
    WHEELER, Mervyn James
    43 Nether Court
    CO9 2HN Halstead
    Essex
    Director
    43 Nether Court
    CO9 2HN Halstead
    Essex
    BritishSales Director14773330001
    WICKS, Jonathon Neil
    2 Northbrook Copse
    Forest Park
    RG12 0UA Bracknell
    Berkshire
    Director
    2 Northbrook Copse
    Forest Park
    RG12 0UA Bracknell
    Berkshire
    EnglandBritishCompany Director56518060001
    WYNN, Edward Charles
    34 Windmill Lane
    DE6 1EY Ashbourne
    Derbyshire
    Director
    34 Windmill Lane
    DE6 1EY Ashbourne
    Derbyshire
    United KingdomBritishSales And Marketing Director60801950001

    ¿Tiene JENWAY LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Deed of accession
    Creado el 30 nov 2007
    Entregado el 08 dic 2007
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from any obligor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    The mortgaged property means the real property listed in the schedule 2 to the debenture, fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Hsbc Bank PLC as Agent and Security Trustee for the Finance Parties (The Security Trustee)
    Transacciones
    • 08 dic 2007Registro de un cargo (395)
    • 18 jun 2015Todo el bien o empresa ha sido liberado de la carga (MR05)
    A credit agreement entitled "prompt credit application"
    Creado el 19 ago 1993
    Entregado el 01 sept 1993
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £19,176.35 due from the company to the chargee under the terms of the agreement
    Breve descripción
    All its right title and interest in and to all sums payable under the insurance. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Close Brothers Limited
    Transacciones
    • 01 sept 1993Registro de un cargo (395)
    • 15 nov 1994Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Fixed charge over book debts
    Creado el 18 dic 1990
    Entregado el 29 dic 1990
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a factoring agreement leasing agreement or on any account whatsoever.
    Breve descripción
    The ultimate balance due or owing to the company by tih under any present or future factoring agreement providing for the purchase by tih of book debts of the company. All other book and other debts and claims both present and future. (Please see doc M395 for full details).
    Personas con derecho
    • Trade Indemnity -Heller Commercial Financial Limited
    Transacciones
    • 29 dic 1990Registro de una carga
    • 13 jul 2001Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal mortgage
    Creado el 22 nov 1990
    Entregado el 26 nov 1990
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Breve descripción
    The cottage gransmore green, felsted, essex.
    Personas con derecho
    • Sidney George Bashford
    • Richard Michael May
    Transacciones
    • 26 nov 1990Registro de una carga
    • 23 sept 1994Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal mortgage
    Creado el 24 ago 1978
    Entregado el 13 sept 1978
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Land & factory premises at grasmore green felsted essex. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank LTD
    Transacciones
    • 13 sept 1978Registro de una carga
    • 13 jul 2001Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0