ENGLISH & OVERSEAS PROPERTIES LIMITED

ENGLISH & OVERSEAS PROPERTIES LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaENGLISH & OVERSEAS PROPERTIES LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 01129454
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de ENGLISH & OVERSEAS PROPERTIES LIMITED?

    • Desarrollo de proyectos de construcción (41100) / Construcción

    ¿Dónde se encuentra ENGLISH & OVERSEAS PROPERTIES LIMITED?

    Dirección de la sede social
    180 Great Portland Street
    W1W 5QZ London
    United Kingdom
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de ENGLISH & OVERSEAS PROPERTIES LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    ENGLISH & OVERSEAS PROPERTIES PLC16 ago 197316 ago 1973

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de ENGLISH & OVERSEAS PROPERTIES LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2018

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para ENGLISH & OVERSEAS PROPERTIES LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    1 páginasDS01

    Cancelación total de la carga 011294540025

    1 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 011294540026

    1 páginasMR04

    Cese del nombramiento de Michael Ben Jenkins como director el 31 dic 2020

    1 páginasTM01

    Declaración de confirmación presentada el 10 may 2020 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Nombramiento de Mr Philip Simon Slavin como director el 13 feb 2020

    2 páginasAP01

    legacy

    2 páginasSH20

    Estado de capital el 13 dic 2019

    • Capital: GBP 100
    5 páginasSH19

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resoluciones

    The company capital redemption reserve account of the company be cancelled 09/12/2019
    RES13

    Cese del nombramiento de Angus Alexander Dodd como director el 07 nov 2019

    1 páginasTM01

    Cuentas para una empresa pequeña preparadas hasta el 31 dic 2018

    18 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 10 may 2019 con actualizaciones

    5 páginasCS01

    Cuentas para una empresa pequeña preparadas hasta el 31 dic 2017

    18 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 10 may 2018 con actualizaciones

    5 páginasCS01

    legacy

    2 páginasSH20

    Estado de capital el 03 abr 2018

    • Capital: GBP 100
    5 páginasSH19

    legacy

    2 páginasCAP-SS

    Resoluciones

    Resolutions
    3 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resoluciones

    Share premium a/c cancelled 12/03/2018
    RES13

    Estado de capital el 15 feb 2018

    • Capital: GBP 100
    5 páginasSH19

    legacy

    2 páginasSH20

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resolución de reducción del capital social emitido

    RES06

    ¿Quiénes son los directivos de ENGLISH & OVERSEAS PROPERTIES LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    HEAZELL, Frances Victoria
    Great Portland Street
    W1W 5QZ London
    180
    United Kingdom
    Secretario
    Great Portland Street
    W1W 5QZ London
    180
    United Kingdom
    215875630001
    SAUNDERS, James Michael Edward
    Great Portland Street
    W1W 5QZ London
    180
    United Kingdom
    Director
    Great Portland Street
    W1W 5QZ London
    180
    United Kingdom
    EnglandBritishCompany Director192568400002
    SLAVIN, Philip Simon
    Great Portland Street
    W1W 5QZ London
    180
    United Kingdom
    Director
    Great Portland Street
    W1W 5QZ London
    180
    United Kingdom
    United KingdomBritishChartered Accountant267205160001
    DIXON, Susan Elizabeth
    Flat 1 29-31 Dingley Place
    EC1 8BR London
    Secretario
    Flat 1 29-31 Dingley Place
    EC1 8BR London
    British90007990001
    EASTWOOD, Charlotte Ind
    16 Edna Street
    SW11 3DP London
    Secretario
    16 Edna Street
    SW11 3DP London
    British50099790003
    GIBSON, Timothy David
    52a Grenville Road
    N19 4EH London
    Secretario
    52a Grenville Road
    N19 4EH London
    BritishAccountant50070710001
    HUGHES, Paul
    Lark Rise
    5 Greville Park Avenue
    KT21 2QS Ashtead
    Surrey
    Secretario
    Lark Rise
    5 Greville Park Avenue
    KT21 2QS Ashtead
    Surrey
    BritishChartered Accountant23950030001
    ODELL, Sandra Judith
    Portman Square
    W1H 6LY London
    43-45
    United Kingdom
    Secretario
    Portman Square
    W1H 6LY London
    43-45
    United Kingdom
    175104150001
    ROBSON SKEETE, Gail
    22a Woodpecker Copse
    Locks Heath
    SO31 6WS Southampton
    Hampshire
    Secretario
    22a Woodpecker Copse
    Locks Heath
    SO31 6WS Southampton
    Hampshire
    BritishAccountant66939460001
    ROBSON SKEETE, Gail
    17 Field Close
    Locks Heath
    SO31 6TX Southampton
    Hampshire
    Secretario
    17 Field Close
    Locks Heath
    SO31 6TX Southampton
    Hampshire
    British58498140001
    WOOLLEY, Peter Thomas Griffith
    2 Fernsleigh Close
    SL9 0HR Chalfont St Peter
    Buckinghamshire
    Secretario
    2 Fernsleigh Close
    SL9 0HR Chalfont St Peter
    Buckinghamshire
    British39676720001
    WORTHINGTON, Rebecca Jane
    The Old Cottage 97 The High Street
    RG10 8DD Wargrave
    Berkshire
    Secretario
    The Old Cottage 97 The High Street
    RG10 8DD Wargrave
    Berkshire
    British130493170001
    AL-SAGER, Mohammed Jassem
    Dahiyat Abdullah Al Salem
    Area 4 Street No 43 Viilla 24
    FOREIGN Kuwait City Kuwaiti
    Director
    Dahiyat Abdullah Al Salem
    Area 4 Street No 43 Viilla 24
    FOREIGN Kuwait City Kuwaiti
    BritishChairman & Managing Director36413770001
    ARRA, Giorgio
    26 Hereford House
    66 North Row
    W1R 1DE London
    Director
    26 Hereford House
    66 North Row
    W1R 1DE London
    ItalianManager71142090001
    BROOKER, Alfred Thomas
    Crispin
    The Approach, Dormans Park
    RH19 3NU East Grinstead
    West Sussex
    Director
    Crispin
    The Approach, Dormans Park
    RH19 3NU East Grinstead
    West Sussex
    EnglandBritishBusiness Executive29444930001
    CARTER, Simon Geoffrey
    Portman Square
    W1H 6LY London
    43-45
    United Kingdom
    Director
    Portman Square
    W1H 6LY London
    43-45
    United Kingdom
    United KingdomBritishChartered Accountant184444990001
    CLARK, James Robert
    Logmore 37 The Avenue
    SM2 7QA Cheam
    Surrey
    Director
    Logmore 37 The Avenue
    SM2 7QA Cheam
    Surrey
    United KingdomBritishDirector52063220001
    DEAR, Michael Raymond
    16 Calvin Close
    GU15 1DN Camberley
    Surrey
    Director
    16 Calvin Close
    GU15 1DN Camberley
    Surrey
    BritishDirector11171470001
    DODD, Angus Alexander
    Great Portland Street
    W1W 5QZ London
    180
    United Kingdom
    Director
    Great Portland Street
    W1W 5QZ London
    180
    United Kingdom
    EnglandBritishSenior Managing Director201606390001
    DUGDALE, Edward Stratford
    Tickwood Hall
    TF13 6NZ Much Wenlock
    Shropshire
    Director
    Tickwood Hall
    TF13 6NZ Much Wenlock
    Shropshire
    EnglandBritishCompany Director35942980003
    DWYER, Tonianne
    170 Bishops Road
    Fulham
    SW6 7JG London
    Director
    170 Bishops Road
    Fulham
    SW6 7JG London
    United KingdomAustralianProperty Fund Manager94124780001
    ELLIS, Nigel George
    Willmead Farm
    Bovey Tracey
    TQ13 9NP Newton Abbot
    Devon
    Director
    Willmead Farm
    Bovey Tracey
    TQ13 9NP Newton Abbot
    Devon
    BritishChartered Accountant/Cd14185110002
    GAVAGHAN, David Nicholas
    16 Grosvenor Street
    London
    W1K 4QF
    Director
    16 Grosvenor Street
    London
    W1K 4QF
    United KingdomBritishFund Manager151855940001
    GREENSLADE, Daniel Mark
    Portman Square
    W1H 6LY London
    43-45
    United Kingdom
    Director
    Portman Square
    W1H 6LY London
    43-45
    United Kingdom
    EnglandBritishChartered Accountant196504990001
    HAMILTON STUBBER, James Robert
    1 The Regency
    Hide Place
    SW1P 4HD London
    Director
    1 The Regency
    Hide Place
    SW1P 4HD London
    United KingdomBritishDirector84913850002
    HOOPER, Patrick Paul
    Thornfield 92 Station Road
    Balsall Common
    CV7 7FL Coventry
    West Midlands
    Director
    Thornfield 92 Station Road
    Balsall Common
    CV7 7FL Coventry
    West Midlands
    BritishDirector455570001
    JAMES, Maxwell David Shaw
    Portman Square
    W1H 6LY London
    43-45
    United Kingdom
    Director
    Portman Square
    W1H 6LY London
    43-45
    United Kingdom
    EnglandBritishCompany Director164108510003
    JENKINS, Michael Ben
    Great Portland Street
    W1W 5QZ London
    180
    United Kingdom
    Director
    Great Portland Street
    W1W 5QZ London
    180
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Director221017630001
    KATZ, Jonathan
    60 Mount Ephraim Lane
    SW16 1JD London
    Director
    60 Mount Ephraim Lane
    SW16 1JD London
    EnglandBritishFinance Director33805490001
    KNIGHT, Eric
    7 Boulevard Des Moulins
    MC9800 Monaco
    Director
    7 Boulevard Des Moulins
    MC9800 Monaco
    ItalianCompany Director55114600003
    LAZARUS, James Nicholas
    Misbourne 47 Foxdell Way
    Chalfont St Peter
    SL9 0PL Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Director
    Misbourne 47 Foxdell Way
    Chalfont St Peter
    SL9 0PL Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    United KingdomBritishDirector8315580001
    PARRY, John Richard
    High Barn The Paddocks
    Dog Kennel Lane
    WD3 5EE Chorleywood
    Hertfordshire
    Director
    High Barn The Paddocks
    Dog Kennel Lane
    WD3 5EE Chorleywood
    Hertfordshire
    BritishChartered Surveyor2995850001
    RILEY, Michael Edward
    Tylers Barn
    Tylers Green Broad Street
    RH17 5DX Cuckfield
    West Sussex
    Director
    Tylers Barn
    Tylers Green Broad Street
    RH17 5DX Cuckfield
    West Sussex
    BritishChartered Surveyor94724020002
    SANDERSON, Eric Fenton
    10 Harelaw Road
    EH13 0DR Edinburgh
    Midlothian
    Director
    10 Harelaw Road
    EH13 0DR Edinburgh
    Midlothian
    ScotlandBritishDirector126848980001
    SHATTOCK, Nicholas Simon Keith
    1 Court Lane
    Dulwich
    SE21 7DH London
    Director
    1 Court Lane
    Dulwich
    SE21 7DH London
    EnglandBritishSolicitor43632680001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de ENGLISH & OVERSEAS PROPERTIES LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Great Portland Street
    W1W 5QZ London
    180
    United Kingdom
    06 abr 2016
    Great Portland Street
    W1W 5QZ London
    180
    United Kingdom
    No
    Forma jurídicaLimited By Shares
    País de registroEngland And Wales
    Autoridad legalUnited Kingdom (England And Wales)
    Lugar de registroCompanies House
    Número de registro2694983
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.
    • La persona tiene el derecho, directa o indirectamente, de nombrar o destituir a la mayoría de la junta directiva de la empresa.

    ¿Tiene ENGLISH & OVERSEAS PROPERTIES LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    A registered charge
    Creado el 03 nov 2017
    Entregado el 07 nov 2017
    Satisfecho en su totalidad
    Breve descripción
    None.
    La garantía flotante cubre todo:
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía flotante:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Homes and Communities Agency
    Transacciones
    • 07 nov 2017Registro de una carga (MR01)
    • 18 ene 2021Satisfacción de una carga (MR04)
    A registered charge
    Creado el 03 nov 2016
    Entregado el 15 nov 2016
    Satisfecho en su totalidad
    La garantía flotante cubre todo:
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía flotante:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Wells Fargo Bank, N.A., London Branch, 90 Long Acre, London, WC2E 9RA (As Common Security Agent for Each of the Secured Parties)
    Transacciones
    • 15 nov 2016Registro de una carga (MR01)
    • 18 ene 2021Satisfacción de una carga (MR04)
    Floating charge security agreement
    Creado el 14 mar 2008
    Entregado el 17 mar 2008
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and each other chargor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    First floating charge all its assets see image for full details.
    Personas con derecho
    • Bank of Scotland PLC (The "Security Agent")
    Transacciones
    • 17 mar 2008Registro de un cargo (395)
    • 25 oct 2016Satisfacción de una carga (MR04)
    A security agreement
    Creado el 04 feb 2008
    Entregado el 15 feb 2008
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from each obligor to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Assigns all rights under any hedging arrangements. By way of first floating charge all assets not otherwise ffectively mortgages charged or assigned by way of fixed mortgage charge or assignment. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Hsbc Bank PLC as Agent and Trustee for the Finance Parties (The Facility Agent)
    Transacciones
    • 15 feb 2008Registro de un cargo (395)
    • 19 mar 2008Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    A security agreement
    Creado el 29 ene 2008
    Entregado el 07 feb 2008
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from each obligor to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Assigns all rights under any hedging arrangements. By way of first floating charge all assets not otherwise effectively mortgages charged or assigned by way of fixed mortgage charge or assignment. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Bank PLC as Agent and Trustee for the Finance Parties (The Facility Agent)
    Transacciones
    • 07 feb 2008Registro de un cargo (395)
    • 19 mar 2008Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    A security agreement
    Creado el 29 ene 2008
    Entregado el 01 feb 2008
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from each obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    All rights under any hedging arrangements. By way of floating charge all assets not effectively mortgaged charged or assigned by way of fixed mortgage charge or assignment under the charge. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Barclays Capital as Agent and Trustee for the Finance Parties (The Facility Agent)
    Transacciones
    • 01 feb 2008Registro de un cargo (395)
    • 19 mar 2008Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Security agreement
    Creado el 22 oct 2007
    Entregado el 25 oct 2007
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from each obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    The company assigns all of its rights under any hedging arrangements; a first floating charge all its assets not at any time otherwise effectively mortgaged charged or assigned by way of fixed mortgage. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Bank of Scotland PLC as Agent and Trustee for the Finance Parties (The Facility Agent)
    Transacciones
    • 25 oct 2007Registro de un cargo (395)
    • 19 mar 2008Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Security agreement
    Creado el 26 oct 2005
    Entregado el 11 nov 2005
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    By way of a first floating charge all its assets not at any time othererwise effectively mortgages charged of assigned. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 11 nov 2005Registro de un cargo (395)
    • 19 mar 2008Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Security agreement
    Creado el 26 oct 2005
    Entregado el 11 nov 2005
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    By way of a first floating charge all its assets not at any time othererwise effectively mortgages charged of assigned. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 11 nov 2005Registro de un cargo (395)
    • 19 mar 2008Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Mortgage by way of assignment
    Creado el 03 mar 2000
    Entregado el 09 mar 2000
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under a legal mortgage dated 25TH march 1999
    Breve descripción
    All the company's rights title and interest in and to a building contract dated 4TH october 1999 made between holmes building PLC (1) and the company (2) (the "building contract").. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Bank of Wales PLC
    Transacciones
    • 09 mar 2000Registro de un cargo (395)
    • 10 mar 2008Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal mortgage
    Creado el 25 mar 1999
    Entregado el 30 mar 1999
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Property k/a land lying to the north of holloway lane harmondsworth hillingdon t/n AGL17932 along with the goodwill of any business. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personas con derecho
    • Bank of Wales PLC
    Transacciones
    • 30 mar 1999Registro de un cargo (395)
    • 10 mar 2008Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Deed of charge
    Creado el 07 dic 1998
    Entregado el 11 dic 1998
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever except for any obligation which, if it were so included, would result in a contravention of section 151 of the companies act 1985
    Breve descripción
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    Transacciones
    • 11 dic 1998Registro de un cargo (395)
    • 10 mar 2008Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 01 may 1998
    Entregado el 08 may 1998
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    22 buckingham gate l/b of city of westminster t/n 61747.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 08 may 1998Registro de un cargo (395)
    • 10 mar 2008Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 09 ene 1998
    Entregado el 17 ene 1998
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    F/H mevile house 8 10 & 12 woodhouse road finchley london N3 t/n NGL429496.
    Personas con derecho
    • The British Linen Bank Limited
    Transacciones
    • 17 ene 1998Registro de un cargo (395)
    • 10 mar 2008Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 14 feb 1996
    Entregado el 20 feb 1996
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    29 buckingham gate, l/b of city of westminster t/no: 44712.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 20 feb 1996Registro de un cargo (395)
    • 10 mar 2008Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Shares charge
    Creado el 23 ene 1995
    Entregado el 31 ene 1995
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under each of a credit agreement of even date,the debenture dated 26TH january 1995,the subordination deed dated 23RD january 1995 and this charge
    Breve descripción
    100 ordinary shares of £1 each fully paid up and 50,000 ordinary £1 shares paid up as to 25 pence each in the issued capital; all other shares in english & overseas investments PLC.......all stocks,shares and other securities.............etc.. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Deutsche Pfandbrief-Und Hypothekenbank Aktiengesellschaft
    Transacciones
    • 31 ene 1995Registro de un cargo (395)
    • 10 mar 2008Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 28 abr 1989
    Entregado el 06 may 1989
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    77 st john street, london EC1.
    Personas con derecho
    • The British Linen Bank Limited
    Transacciones
    • 06 may 1989Registro de una carga
    • 10 mar 2008Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 10 abr 1989
    Entregado el 14 abr 1989
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    The coalyard marsh lane hampton in arden west midlands t/n wm 441272.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 14 abr 1989Registro de una carga
    • 10 mar 2008Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 10 abr 1989
    Entregado el 14 abr 1989
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Enterprise house fentham road hampton in arden west midlands t/nos: wm 294348 & wm 439700.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 14 abr 1989Registro de una carga
    • 10 mar 2008Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 04 jul 1988
    Entregado el 13 jul 1988
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or blegberry limited to the chargee on any account whatsoever.
    Breve descripción
    F/H property k/a 94 & 94A st john's wood high street london NW8 T.N. ln 104564.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 13 jul 1988Registro de una carga
    • 10 mar 2008Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 01 jul 1988
    Entregado el 12 jul 1988
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    28/30 coppergate york north yorkshire.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 12 jul 1988Registro de una carga
    • 10 mar 2008Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 01 jul 1988
    Entregado el 12 jul 1988
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    5/6 horsemarket darlington durham. Title no:- du 22186.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 12 jul 1988Registro de una carga
    • 10 mar 2008Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 01 jul 1988
    Entregado el 12 jul 1988
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Land at pembroke park waterbeach cambridge cambridgeshire.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 12 jul 1988Registro de una carga
    • 10 mar 2008Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 01 jul 1988
    Entregado el 12 jul 1988
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Land at maskell road and garratt lane l/b of wandsworth.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 12 jul 1988Registro de una carga
    • 10 mar 2008Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 01 jul 1988
    Entregado el 12 jul 1988
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    17 st sepulchre gate doncaster south yorkshire.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 12 jul 1988Registro de una carga
    • 10 mar 2008Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0