P.C.P. HARRIS (BUILDERS MERCHANTS ) LIMITED

P.C.P. HARRIS (BUILDERS MERCHANTS ) LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaP.C.P. HARRIS (BUILDERS MERCHANTS ) LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 01131488
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de P.C.P. HARRIS (BUILDERS MERCHANTS ) LIMITED?

    • Empresa inactiva (99999) / Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales

    ¿Dónde se encuentra P.C.P. HARRIS (BUILDERS MERCHANTS ) LIMITED?

    Dirección de la sede social
    C/O Mazars Llp 1st Floor
    Two Chamberlain Square
    B3 3AX Birmingham
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de P.C.P. HARRIS (BUILDERS MERCHANTS ) LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2018

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para P.C.P. HARRIS (BUILDERS MERCHANTS ) LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros

    13 páginasLIQ13

    Domicilio social registrado cambiado de C/O Mazars Llp 45 Church Street Birmingham B3 2RT a C/O Mazars Llp 1st Floor Two Chamberlain Square Birmingham B3 3AX el 20 abr 2021

    2 páginasAD01

    La dirección de inspección del registro se ha cambiado a Lodge Way House Lodge Way Harlestone Road Northampton NN5 7UG

    2 páginasAD02

    Domicilio social registrado cambiado de Lodge Way House Lodge Way Harlestone Road Northampton NN5 7UG a C/O Mazars Llp 45 Church Street Birmingham B3 2RT el 28 sept 2020

    2 páginasAD01

    Declaración de solvencia

    5 páginasLIQ01

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    3 páginas600

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    liquidation

    Acuerdo especial para la liquidación el 27 ago 2020

    LRESSP

    legacy

    1 páginasSH20

    Estado de capital el 02 jul 2020

    • Capital: GBP 1
    3 páginasSH19

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Resoluciones

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resolución de reducción del capital social emitido

    RES06

    Declaración de confirmación presentada el 01 may 2020 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2018

    1 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 01 may 2019 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2017

    1 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 01 may 2018 con actualizaciones

    4 páginasCS01

    Cese del nombramiento de Deborah Grimason como director el 06 mar 2018

    1 páginasTM01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2016

    1 páginasAA

    Nombramiento de Mr Alan Richard Williams como director el 11 jul 2017

    2 páginasAP01

    Declaración de confirmación presentada el 01 may 2017 con actualizaciones

    5 páginasCS01

    Cambio de datos del director Miss Deborah Grimason el 13 oct 2016

    2 páginasCH01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2015

    1 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 25 may 2016 avec liste complète des actionnaires

    3 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital01 jun 2016

    Estado de capital el 01 jun 2016

    • Capital: GBP 5,000
    SH01

    Cese del nombramiento de John Peter Carter como director el 21 oct 2015

    1 páginasTM01

    ¿Quiénes son los directivos de P.C.P. HARRIS (BUILDERS MERCHANTS ) LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    WILLIAMS, Alan Richard
    Lodge Way
    Harlestone Road
    NN5 7UG Northampton
    Lodge Way House
    United Kingdom
    Director
    Lodge Way
    Harlestone Road
    NN5 7UG Northampton
    Lodge Way House
    United Kingdom
    United KingdomBritish137582690004
    TP DIRECTORS LTD
    Lodge Way
    Harlestone Road
    NN5 7UG Northampton
    Lodge Way House
    United Kingdom
    Director corporativo
    Lodge Way
    Harlestone Road
    NN5 7UG Northampton
    Lodge Way House
    United Kingdom
    Tipo de identificaciónSociedad limitada del Reino Unido
    Número de registro03480295
    191205550001
    HARRIS, Jane Gwendoline
    Tithe Farm Barton Road
    Congerstone
    CV13 6NB Nuneaton
    Warks
    Secretario
    Tithe Farm Barton Road
    Congerstone
    CV13 6NB Nuneaton
    Warks
    British13905760001
    PIKE, Andrew Stephen
    Lodge Way House
    Lodge Way, Harlestone Road
    NN5 7UG Northampton
    Travis Perkins Plc
    Northamptonshire
    Secretario
    Lodge Way House
    Lodge Way, Harlestone Road
    NN5 7UG Northampton
    Travis Perkins Plc
    Northamptonshire
    British65678800002
    RICHARDSON, Barbara Jane
    8 Wide Street
    Hathern
    LE12 5JH Loughborough
    Leicestershire
    Secretario
    8 Wide Street
    Hathern
    LE12 5JH Loughborough
    Leicestershire
    British48223350001
    BUFFIN, Anthony David
    Lodge Way House
    Lodge Way
    NN5 7UG Harlestone Road
    Northampton
    Director
    Lodge Way House
    Lodge Way
    NN5 7UG Harlestone Road
    Northampton
    EnglandBritish178011680002
    CARTER, John Peter
    Lodge Way
    Harlestone Road
    NN5 7UG Northampton
    Lodge Way House
    United Kingdom
    Director
    Lodge Way
    Harlestone Road
    NN5 7UG Northampton
    Lodge Way House
    United Kingdom
    United KingdomBritish46226920007
    COOPER, Geoffrey Ian
    Travis Perkins Plc, Lodge Way House
    Lodge Way, Harlestone Road
    NN5 7UG Northampton
    Northamptonshire
    Director
    Travis Perkins Plc, Lodge Way House
    Lodge Way, Harlestone Road
    NN5 7UG Northampton
    Northamptonshire
    United KingdomBritish104472550001
    ELLIOT, Colin Richard
    3 Meadow Crescent
    Castle Donington
    DE74 2LX Derby
    Derbyshire
    Director
    3 Meadow Crescent
    Castle Donington
    DE74 2LX Derby
    Derbyshire
    British13905780002
    GRIMASON, Deborah
    Lodge Way House
    Lodge Way
    NN5 7UG Harlestone Road
    Northampton
    Director
    Lodge Way House
    Lodge Way
    NN5 7UG Harlestone Road
    Northampton
    EnglandBritish185755960002
    HAMPDEN SMITH, Paul Nigel
    Travis Perkins Plc, Lodge Way House
    Lodge Way, Harlestone Road
    NN5 7UG Northampton
    Northamptonshire
    Director
    Travis Perkins Plc, Lodge Way House
    Lodge Way, Harlestone Road
    NN5 7UG Northampton
    Northamptonshire
    United KingdomBritish72135950007
    HARRIS, Jane Gwendoline
    Tithe Farm Barton Road
    Congerstone
    CV13 6NB Nuneaton
    Warks
    Director
    Tithe Farm Barton Road
    Congerstone
    CV13 6NB Nuneaton
    Warks
    British13905760001
    HARRIS, Peter Christopher Peile
    Tithe Farm Barton Road
    Congerstone
    CV13 6NB Nuneaton
    Warks
    Director
    Tithe Farm Barton Road
    Congerstone
    CV13 6NB Nuneaton
    Warks
    United KingdomBritish13905790002
    MCKAY, Francis John
    Lodge Way House
    Lodge Way
    NN5 7UG Harlestone Road
    Northampton
    Director
    Lodge Way House
    Lodge Way
    NN5 7UG Harlestone Road
    Northampton
    British78787530001
    RICHARDSON, Barbara Jane
    8 Wide Street
    Hathern
    LE12 5JH Loughborough
    Leicestershire
    Director
    8 Wide Street
    Hathern
    LE12 5JH Loughborough
    Leicestershire
    British48223350001
    RICHARDSON, Peter David
    8 Wide Street
    Hathern
    LE12 5JH Loughborough
    Leicestershire
    Director
    8 Wide Street
    Hathern
    LE12 5JH Loughborough
    Leicestershire
    British13905770002

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de P.C.P. HARRIS (BUILDERS MERCHANTS ) LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    P.C.P. Harris (Holdings) Limited
    Lodge Way
    Lodge Farm Industrial Estate
    NN5 7UG Northampton
    Lodge Way House
    England
    06 abr 2016
    Lodge Way
    Lodge Farm Industrial Estate
    NN5 7UG Northampton
    Lodge Way House
    England
    No
    Forma jurídicaPrivate Limited Company
    País de registroUnited Kingdom
    Autoridad legalCompanies Act
    Lugar de registroEngland And Wales
    Número de registro3679395
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.
    • La persona tiene el derecho, directa o indirectamente, de nombrar o destituir a la mayoría de la junta directiva de la empresa.

    ¿Tiene P.C.P. HARRIS (BUILDERS MERCHANTS ) LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Mortgage debenture
    Creado el 22 dic 1998
    Entregado el 05 ene 1999
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 05 ene 1999Registro de un cargo (395)
    • 13 dic 2003Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 03 ago 1989
    Entregado el 07 ago 1989
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    F/H property units 5 & 6 old station close, shepshed. Title no lt 124595 by way of equitable charge all moneys received of any insurance in respect of loss or damage by fire or otherwide to the buildings or any part being subject to the security.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 07 ago 1989Registro de una carga
    • 23 jun 1999Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 25 abr 1989
    Entregado el 05 may 1989
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 05 may 1989Registro de una carga
    • 23 jun 1999Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 31 ene 1986
    Entregado el 04 feb 1986
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed charge over piece of land situate & having a frontage to trent lane, castle donington leics., Containing an area of 1.76 acres or thereabouts, together with all buildings fixtures fixed plant & machinery. All other l/h & f/h property together with buildings fixtures fixed plant & machinery. Goodwill, uncalled capital book & other debts. Floating charge over stock-on-trade, work-in-progress, pre payments investments all other undertaking & property & assets.
    Personas con derecho
    • Investor in Industry PLC.
    Transacciones
    • 04 feb 1986Registro de una carga
    • 23 jun 1999Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 03 jun 1985
    Entregado el 10 jun 1985
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 10 jun 1985Registro de una carga
    Legal charge
    Creado el 10 dic 1982
    Entregado el 13 dic 1982
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    F/H units 5 & 6 old station close shepshed leicestershire by way of equi table charge all moneys received of any insurance whatsoever in respect of loss or damage by fire or otherwise to the buildings or any part thereof being subject to the security.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 13 dic 1982Registro de una carga
    Mortgage
    Creado el 05 nov 1979
    Entregado el 07 nov 1979
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed charge by way of legal mortgage upon plot 5B old station close, shepshed, leics together with all buildings and fixtures.
    Personas con derecho
    • Industrial and Commercial Finance Cooperation Limited
    Transacciones
    • 07 nov 1979Registro de una carga
    • 16 oct 1999Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    ¿Tiene P.C.P. HARRIS (BUILDERS MERCHANTS ) LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    27 ago 2020Inicio de la liquidación
    28 sept 2021Fecha de disolución
    Liquidación voluntaria de socios
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Simon David Chandler
    C/O Mazars Llp 1st Floor
    Two Chamberlain Square
    B3 3AX Birmingham
    Profesional
    C/O Mazars Llp 1st Floor
    Two Chamberlain Square
    B3 3AX Birmingham
    Scott Christian Bevan
    Mazars Llp 45 Church Street
    B3 2RT Birmingham
    Profesional
    Mazars Llp 45 Church Street
    B3 2RT Birmingham

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0