TP SHELFCO NO.3 LIMITED

TP SHELFCO NO.3 LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaTP SHELFCO NO.3 LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 01132499
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de TP SHELFCO NO.3 LIMITED?

    • Empresa inactiva (99999) / Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales

    ¿Dónde se encuentra TP SHELFCO NO.3 LIMITED?

    Dirección de la sede social
    C/O Mazars Llp 1st Floor
    Two Chamberlain Square
    B3 3AX Birmingham
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de TP SHELFCO NO.3 LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    BIRCHWOOD PRODUCTS LIMITED04 dic 199604 dic 1996
    J.B. SIMONS LIMITED04 sept 197304 sept 1973

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de TP SHELFCO NO.3 LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2019

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para TP SHELFCO NO.3 LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros

    11 páginasLIQ13

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    3 páginas600

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    liquidation

    Acuerdo especial para la liquidación el 15 sept 2021

    LRESSP

    Domicilio social registrado cambiado de Lodge Way House Lodge Way Harlestone Road Northampton NN5 7UG a C/O Mazars Llp 1st Floor Two Chamberlain Square Birmingham B3 3AX el 29 sept 2021

    2 páginasAD01

    Declaración de solvencia

    5 páginasLIQ01

    La dirección de inspección del registro se ha cambiado a Lodge Way House Lodge Way Harlestone Road Northampton NN5 7UG

    2 páginasAD02

    Declaración de confirmación presentada el 01 abr 2021 con actualizaciones

    5 páginasCS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2019

    1 páginasAA

    legacy

    1 páginasSH20

    Estado de capital el 02 jul 2020

    • Capital: GBP 1
    3 páginasSH19

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Resoluciones

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resolución de reducción del capital social emitido

    RES06

    Declaración de confirmación presentada el 01 abr 2020 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2018

    1 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 01 abr 2019 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Resoluciones

    Resolutions
    3 páginasRESOLUTIONS
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    change-of-name26 sept 2018

    Cambio de nombre por resolución

    NM01
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    change-of-name

    Resolución de cambio de nombre de la empresa el 25 sept 2018

    RES15

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2017

    1 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 01 abr 2018 con actualizaciones

    4 páginasCS01

    Cese del nombramiento de Deborah Grimason como director el 06 mar 2018

    1 páginasTM01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2016

    1 páginasAA

    Cese del nombramiento de John Peter Carter como director el 18 jul 2017

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Miss Deborah Grimason como director el 18 jul 2017

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Anthony David Buffin como director el 11 jul 2017

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mr Alan Richard Williams como director el 11 jul 2017

    2 páginasAP01

    ¿Quiénes son los directivos de TP SHELFCO NO.3 LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    WILLIAMS, Alan Richard
    Lodge Way
    Harlestone Road
    NN5 7UG Northampton
    Lodge Way House
    United Kingdom
    Director
    Lodge Way
    Harlestone Road
    NN5 7UG Northampton
    Lodge Way House
    United Kingdom
    United KingdomBritish137582690004
    TP DIRECTORS LTD
    Lodge Way
    Harlestone Road
    NN5 7UG Northampton
    Lodge Way House
    United Kingdom
    Director corporativo
    Lodge Way
    Harlestone Road
    NN5 7UG Northampton
    Lodge Way House
    United Kingdom
    Tipo de identificaciónSociedad limitada del Reino Unido
    Número de registro03480295
    191205550001
    BALL, Ute Suse
    Lee Circle
    LE1 3QQ Leicester
    Fleet House
    Secretario
    Lee Circle
    LE1 3QQ Leicester
    Fleet House
    British118371550001
    BOLLU, Pierre
    20 Lime Grove Avenue
    NG9 4AR Chilwell
    Nottinghamshire
    Secretario
    20 Lime Grove Avenue
    NG9 4AR Chilwell
    Nottinghamshire
    British92317380001
    PIKE, Andrew Stephen
    Lodge Way
    Harlestone Road
    NN5 7UG Northampton
    Lodge Way House
    United Kingdom
    Secretario
    Lodge Way
    Harlestone Road
    NN5 7UG Northampton
    Lodge Way House
    United Kingdom
    158161020001
    SIMONS, John Barry
    28 Bromyard Terrace
    St Johns
    WR2 5BW Worcester
    Worcestershire
    Secretario
    28 Bromyard Terrace
    St Johns
    WR2 5BW Worcester
    Worcestershire
    British94492900001
    SIMONS, Pamela Helen
    12 Delville Avenue
    Keyworth
    NG12 5JA Nottingham
    Nottinghamshire
    Secretario
    12 Delville Avenue
    Keyworth
    NG12 5JA Nottingham
    Nottinghamshire
    British26705640001
    SMITH, Anthony Edward
    278 Heanor Road
    DE7 8TG Ilkeston
    Derbyshire
    Secretario
    278 Heanor Road
    DE7 8TG Ilkeston
    Derbyshire
    British36984820003
    BELL, Norman
    Lodge Way
    Harlestone Road
    NN5 7UG Northampton
    Lodge Way House
    United Kingdom
    Director
    Lodge Way
    Harlestone Road
    NN5 7UG Northampton
    Lodge Way House
    United Kingdom
    United KingdomBritish106766000001
    BUFFIN, Anthony David
    Lodge Way
    Harlestone Road
    NN5 7UG Northampton
    Lodge Way House
    United Kingdom
    Director
    Lodge Way
    Harlestone Road
    NN5 7UG Northampton
    Lodge Way House
    United Kingdom
    EnglandBritish178011680002
    BURTON, Alan
    Beck House
    Hawthorn Close
    NG14 7HW Bleasby
    Nottinghamshire
    Director
    Beck House
    Hawthorn Close
    NG14 7HW Bleasby
    Nottinghamshire
    British79640650001
    CARTER, John Peter
    Lodge Way
    Harlestone Road
    NN5 7UG Northampton
    Lodge Way House
    United Kingdom
    Director
    Lodge Way
    Harlestone Road
    NN5 7UG Northampton
    Lodge Way House
    United Kingdom
    United KingdomBritish46226920007
    COOPER, Geoffrey Ian
    Lodge Way
    Harlestone Road
    NN5 7UG Northampton
    Lodge Way House
    United Kingdom
    Director
    Lodge Way
    Harlestone Road
    NN5 7UG Northampton
    Lodge Way House
    United Kingdom
    United KingdomBritish104472550001
    GREATOREX, Sue
    Lodge Way
    Harlestone Road
    NN5 7UG Northampton
    Lodge Way House
    United Kingdom
    Director
    Lodge Way
    Harlestone Road
    NN5 7UG Northampton
    Lodge Way House
    United Kingdom
    United KingdomBritish177194840001
    GRIMASON, Deborah
    Lodge Way
    Harlestone Road
    NN5 7UG Northampton
    Lodge Way House
    Director
    Lodge Way
    Harlestone Road
    NN5 7UG Northampton
    Lodge Way House
    EnglandBritish185755960002
    HAMPDEN SMITH, Paul Nigel
    Lodge Way
    Harlestone Road
    NN5 7UG Northampton
    Lodge Way House
    United Kingdom
    Director
    Lodge Way
    Harlestone Road
    NN5 7UG Northampton
    Lodge Way House
    United Kingdom
    United KingdomBritish72135950007
    KAVANAGH, Carol
    Lodge Way
    Harlestone Road
    NN5 7UG Northampton
    Lodge Way House
    United Kingdom
    Director
    Lodge Way
    Harlestone Road
    NN5 7UG Northampton
    Lodge Way House
    United Kingdom
    United KingdomBritish127248260001
    MEECH, Martin Richard
    Lodge Way
    Harlestone Road
    NN5 7UG Northampton
    Lodge Way House
    United Kingdom
    Director
    Lodge Way
    Harlestone Road
    NN5 7UG Northampton
    Lodge Way House
    United Kingdom
    EnglandBritish108246880001
    MURRAY, John Roderick
    Lee Circle
    LE1 3QQ Leicester
    Fleet House
    Director
    Lee Circle
    LE1 3QQ Leicester
    Fleet House
    United KingdomBritish145111310001
    OOSTEN, Jean-Jacques Michel Van
    Lodge Way
    Harlestone Road
    NN5 7UG Northampton
    Lodge Way House
    United Kingdom
    Director
    Lodge Way
    Harlestone Road
    NN5 7UG Northampton
    Lodge Way House
    United Kingdom
    United KingdomBelgian177926250001
    PROCTOR, Robin David
    Lodge Way
    Harlestone Road
    NN5 7UG Northampton
    Lodge Way House
    United Kingdom
    Director
    Lodge Way
    Harlestone Road
    NN5 7UG Northampton
    Lodge Way House
    United Kingdom
    United KingdomBritish117945650001
    SIMONS, John Barry
    28 Bromyard Terrace
    St Johns
    WR2 5BW Worcester
    Worcestershire
    Director
    28 Bromyard Terrace
    St Johns
    WR2 5BW Worcester
    Worcestershire
    United KingdomBritish94492900001
    SIMPSON, Paul Anthony
    Field Farm Ember Lane
    Langham Road Langham
    LN13 9SL Mumby
    Lincolnshire
    Director
    Field Farm Ember Lane
    Langham Road Langham
    LN13 9SL Mumby
    Lincolnshire
    United KingdomBritish198094060001
    SKELTON, Steven Donald
    4 Conniston Close
    SL7 2RG Marlow
    Buckinghamshire
    Director
    4 Conniston Close
    SL7 2RG Marlow
    Buckinghamshire
    British7330680001
    SLARK, Gavin
    Lee Circle
    LE1 3QQ Leicester
    Fleet House
    Director
    Lee Circle
    LE1 3QQ Leicester
    Fleet House
    United KingdomBritish162972090001
    SMITH, Anthony Edward
    Bonita House
    11 Risborrow Close
    DE65 6HY Etwall
    Derbyshire
    Director
    Bonita House
    11 Risborrow Close
    DE65 6HY Etwall
    Derbyshire
    United KingdomBritish36984820004
    SWANWICK, Paul
    59 Maple Avenue
    Beeston Rylands
    NG9 1PU Nottingham
    Nottinghamshire
    Director
    59 Maple Avenue
    Beeston Rylands
    NG9 1PU Nottingham
    Nottinghamshire
    British60218470001
    TALLENTIRE, Paul John
    Lee Circle
    LE1 3QQ Leicester
    Fleet House
    Leicestershire
    United Kingdom
    Director
    Lee Circle
    LE1 3QQ Leicester
    Fleet House
    Leicestershire
    United Kingdom
    EnglandBritish134335900002

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de TP SHELFCO NO.3 LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Travis Perkins Financing Company No.3 Limited
    Lodge Way
    Lodge Farm Industrial Estate
    NN5 7UG Northampton
    Lodge Way House
    England
    06 abr 2016
    Lodge Way
    Lodge Farm Industrial Estate
    NN5 7UG Northampton
    Lodge Way House
    England
    No
    Forma jurídicaPrivate Limited Company
    País de registroUnited Kingdom
    Autoridad legalCompanies Act
    Lugar de registroEngland And Wales
    Número de registro07180292
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.
    • La persona tiene el derecho, directa o indirectamente, de nombrar o destituir a la mayoría de la junta directiva de la empresa.

    ¿Tiene TP SHELFCO NO.3 LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Debenture
    Creado el 02 may 2006
    Entregado el 11 may 2006
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transacciones
    • 11 may 2006Registro de un cargo (395)
    • 12 mar 2008Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 17 dic 2004
    Entregado el 21 dic 2004
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    F/H property k/a dg house, park lodge lane, giltbrook, nottingham.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 21 dic 2004Registro de un cargo (395)
    • 22 feb 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Creado el 31 oct 2003
    Entregado el 13 nov 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    All f/h and l/h property of the chargor situate in england and wales and all liens, charges, options, agreements, rights and interests in or over land or the proceeds of sale of land, and all buildings, fixtures (including trade fixtures) and fixed plant and machinery from time to time on such property or land. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 13 nov 2003Registro de un cargo (395)
    • 18 ago 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Creado el 31 oct 2003
    Entregado el 11 nov 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and all other companies therein to the chargee
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Barry Simons
    Transacciones
    • 11 nov 2003Registro de un cargo (395)
    • 12 mar 2008Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 31 oct 2003
    Entregado el 11 nov 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Unit 5 cossall industrial estate ilkeston derbyshire DE7 5UB.
    Personas con derecho
    • Barry Simons
    Transacciones
    • 11 nov 2003Registro de un cargo (395)
    • 12 mar 2008Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 06 ene 1997
    Entregado el 13 ene 1997
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Factory premises at units 5 a, b, c & d cossall industrial estate coronation road cossall nottinghamshire t/n: NT287721.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 13 ene 1997Registro de un cargo (395)
    • 05 may 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 12 nov 1996
    Entregado el 20 nov 1996
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 20 nov 1996Registro de un cargo (395)
    • 18 ago 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Guarantee & debenture
    Creado el 13 nov 1985
    Entregado el 20 nov 1985
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 20 nov 1985Registro de una carga
    • 12 mar 1994Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 20 abr 1983
    Entregado el 10 may 1983
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    F/H property at brand street nottingham title no nt 66141.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 10 may 1983Registro de una carga
    • 05 may 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 02 ene 1980
    Entregado el 09 ene 1980
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Factory premises at castle meadow rd nottingham.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 09 ene 1980Registro de una carga
    • 05 may 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Guarantee & debenture
    Creado el 26 jul 1979
    Entregado el 07 ago 1979
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or needham and jackson LTD to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed & floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill & bookdebts uncalled capital with all buildings fixtures fixed plant & machinery.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 07 ago 1979Registro de una carga
    • 12 mar 1994Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    ¿Tiene TP SHELFCO NO.3 LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    15 sept 2021Inicio de la liquidación
    09 dic 2022Fecha de disolución
    Liquidación voluntaria de socios
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Simon David Chandler
    1st Floor Two Chamberlain Square
    B3 3AX Birmingham
    Profesional
    1st Floor Two Chamberlain Square
    B3 3AX Birmingham
    Scott Christian Bevan
    Mazars Llp First Floor, Two Chamberlain Square
    B3 3AX Birmingham
    Profesional
    Mazars Llp First Floor, Two Chamberlain Square
    B3 3AX Birmingham

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0