EMIG 6 LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | EMIG 6 LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 01133617 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de EMIG 6 LIMITED?
- fabricación de aparatos y equipos de telégrafo y teléfono (26301) / Industrias manufactureras
¿Dónde se encuentra EMIG 6 LIMITED?
| Dirección de la sede social | 364-366 Kensington High Street W14 8NS London |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de EMIG 6 LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| THORN SECURE SCIENCE LIMITED | 22 ene 1990 | 22 ene 1990 |
| GROWELECT LIMITED | 11 sept 1973 | 11 sept 1973 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de EMIG 6 LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2014 |
¿Cuál es el estado de la última declaración anual para EMIG 6 LIMITED?
| Declaración anual |
|
|---|
¿Cuáles son las últimas presentaciones para EMIG 6 LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 3 páginas | DS01 | ||||||||||
legacy | 1 páginas | SH20 | ||||||||||
Estado de capital el 09 dic 2015
| 5 páginas | SH19 | ||||||||||
legacy | 2 páginas | CAP-SS | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2014 | 7 páginas | AA | ||||||||||
Nombramiento de Mr Adam Martin Barker como director el 13 feb 2015 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr David Richard James Sharpe como director el 13 feb 2015 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 15 dic 2014 avec liste complète des actionnaires | 7 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2013 | 7 páginas | AA | ||||||||||
Exercice comptable précédent raccourci du 31 mar 2014 au 31 dic 2013 | 1 páginas | AA01 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 15 dic 2013 avec liste complète des actionnaires | 7 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2013 | 8 páginas | AA | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr Richard Michael Constant el 27 sept 2013 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr Andrew Brown el 08 feb 2013 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr Boyd Johnston Muir el 08 feb 2013 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de * 27 Wrights Lane London W8 5SW* el 08 feb 2013 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 15 dic 2012 avec liste complète des actionnaires | 7 páginas | AR01 | ||||||||||
La dirección de inspección del registro se ha cambiado de 5Th Floor 6 St Andrew Street London EC4A 3AE United Kingdom | 1 páginas | AD02 | ||||||||||
Nombramiento de Mrs Abolanle Abioye como secretario | 2 páginas | AP03 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Tmf Corporate Administration Services Limited como secretario | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
legacy | 3 páginas | MG02 | ||||||||||
legacy | 3 páginas | MG02 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de EMIG 6 LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABIOYE, Abolanle | Secretario | Kensington High Street W14 8NS London 364-366 United Kingdom | 174414520001 | |||||||||||
| BARKER, Adam Martin | Director | Kensington High Street W14 8NS London 364-366 United Kingdom | England | British | 162279360001 | |||||||||
| BROWN, Andrew | Director | Kensington High Street W14 8NS London 364-366 United Kingdom | England | British | 163199590001 | |||||||||
| CONSTANT, Richard Michael | Director | Kensington High Street W14 8NS London 364-366 United Kingdom | United Kingdom | British | 43836310003 | |||||||||
| MUIR, Boyd Johnston | Director | Kensington High Street W14 8NS London 364-366 United Kingdom | United States | British | 172824510001 | |||||||||
| SHARPE, David Richard James | Director | Kensington High Street W14 8NS London 364-366 United Kingdom | England | Irish | 166109150001 | |||||||||
| BELL, Andrew James | Secretario | 21 Horseshoe Crescent Peatmoor SN5 5AH Swindon Wiltshire | British | 47481660001 | ||||||||||
| WAREHAM, Edward Stanley | Secretario | 19 Hansler Grove KT8 9JN East Molesey Surrey | British | 16008210001 | ||||||||||
| MAWLAW SECRETARIES LIMITED | Secretario corporativo | Bishopsgate EC2M 3AF London 201 | 39182980003 | |||||||||||
| TMF CORPORATE ADMINISTRATION SERVICES LIMITED | Secretario corporativo | 6 St Andrew Street EC4A 3AE London 5th Floor United Kingdom |
| 140723560001 | ||||||||||
| ALEXANDER, Stephen Harold | Director | 39 Wandle Road SW17 7DL London | United Kingdom | British | 126427510001 | |||||||||
| ANCLIFF, Christopher John | Director | 13 Camley Park Drive SL6 6QF Maidenhead Berkshire | United Kingdom | British | 52876050002 | |||||||||
| ARNOLD, David Howard, Dr | Director | 20 Pine Grove KT13 9AW Weybridge Surrey | United Kingdom | British | 29230470001 | |||||||||
| ASHCROFT, Charles Patrick | Director | 53 Cardross Street W6 0DP London | British | 50649650002 | ||||||||||
| BATES, Stephen Ronald | Director | 25 Willow Avenue HP12 4QU High Wycombe Buckinghamshire | British | 25024280001 | ||||||||||
| BELL, Andrew James | Director | 21 Horseshoe Crescent Peatmoor SN5 5AH Swindon Wiltshire | British | 47481660001 | ||||||||||
| CHADD, Andrew Peter | Director | Wrights Lane W8 5SW London 27 United Kingdom | United Kingdom | British | 133578890002 | |||||||||
| CHRISTIAN, Christopher Lindsay | Director | 47 Court Way TW2 7SA Twickenham Middlesex | British | 15441800002 | ||||||||||
| COTTIS, Stephen Martin | Director | 61 Oaken Grove SL6 6HN Maidenhead Berkshire | England | British | 36088340002 | |||||||||
| FAXON, Roger Conant | Director | Ninth Avenue 4th Floor NY 10011 New York 75 Usa | Usa | American | 161824550001 | |||||||||
| GRAY, Kenneth Walter, Doctor | Director | Broadgates Manor Road HP10 8JA Penn Buckinghamshire | British | 38348300001 | ||||||||||
| KENNEDY, Christopher John | Director | 31 Bath Road Chiswick W4 1LJ London | United Kingdom | British | 62227310005 | |||||||||
| NAUGHTON, Shane Paul | Director | Wrights Lane W8 5SW London 27 United Kingdom | England | Irish | 150186560001 | |||||||||
| PRIOR, Ruth Catherine | Director | Wrights Lane W8 5SW London 27 United Kingdom | United Kingdom | British | 161825160001 | |||||||||
| PUNJA, Riaz | Director | Apartment 31 Albert Bridge House 127 Albert Bridge Road SW11 4PA London | United Kingdom | British | 58870910002 | |||||||||
| RAINFORTH, Warren Leonard | Director | Hendal View Withyham Road Groombridge TN3 9QT Tunbridge Wells Kent | British | 18100370001 | ||||||||||
| ROLING, Christopher John | Director | 82 Oak End Way SL9 8DB Gerrards Cross Buckinghamshire | British American | 119379800001 | ||||||||||
| TARRANT, Hugh | Director | 4 Old Rickyard Fyfield SN8 1PQ Marlborough Wiltshire | British | 61112530002 | ||||||||||
| VAIDYA, Ashok Wasudeo, Dr | Director | Ridge Lea Woolton Hill RG20 9UT Newbury Berkshire | British | 47481790001 | ||||||||||
| WAREHAM, Edward Stanley | Director | 19 Hansler Grove KT8 9JN East Molesey Surrey | British | 16008210001 |
¿Tiene EMIG 6 LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| A recorded music division security agreement | Creado el 01 oct 2008 Entregado el 10 oct 2008 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the obligors and the participating employers on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción All of its copyrights which are governed by english law, all of its music contracts and exploitation contracts, and all receivables relating to any copyright asset. Floating charge all of its assets see image for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| A deed of accession and charge | Creado el 28 ene 2008 Entregado el 31 ene 2008 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the obligors and the participating employers under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0