ASPECT VISION CARE

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Declaración anual
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaASPECT VISION CARE
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad privada sin límite de capital
    Número de empresa 01134463
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de ASPECT VISION CARE?

    • Otras industrias manufactureras n.c.p. (32990) / Industrias manufactureras
    • Comercio al por mayor no especializado (46900) / Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas

    ¿Dónde se encuentra ASPECT VISION CARE?

    Dirección de la sede social
    Delta Park, Concorde Way
    Segensworth North
    PO15 5RL Fareham
    Hampshire
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de ASPECT VISION CARE?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    COOPERVISION LIMITED26 mar 199926 mar 1999
    ASPECT VISION CARE LIMITED27 sept 199127 sept 1991
    FOCUS CONTACT LENS LABORATORY LIMITED17 sept 197317 sept 1973

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de ASPECT VISION CARE?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 oct 2007

    ¿Cuál es el estado de la última declaración anual para ASPECT VISION CARE?

    Declaración anual
    Última declaración anual

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para ASPECT VISION CARE?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Cese del nombramiento de Alan Edwards como secretario

    1 páginasTM02

    Déclaration annuelle établie au 14 sept 2013 avec liste complète des actionnaires

    15 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital11 oct 2013

    Estado de capital el 11 oct 2013

    • Capital: GBP 7,411,297.061115
    SH01

    Cambio de datos del secretario Alan Wayne Edwards el 05 feb 2013

    2 páginasCH03

    Déclaration annuelle établie au 14 sept 2012 avec liste complète des actionnaires

    15 páginasAR01

    Cese del nombramiento de Juan Aragon como director

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mr Michael Francis Wilkinson como director

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Juan Carlos Aragon como director

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Gregory Wayne Matz como director

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Eugene Midlock como director

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Andrew Sedgwick como director

    1 páginasTM01

    Déclaration annuelle établie au 14 sept 2011 avec liste complète des actionnaires

    15 páginasAR01

    Déclaration annuelle établie au 14 sept 2010 avec liste complète des actionnaires

    15 páginasAR01

    Cambio de datos del director Andrew Nigel Sedgwick el 17 ago 2010

    2 páginasCH01

    Déclaration annuelle établie au 14 sept 2009 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01

    legacy

    1 páginas288a

    legacy

    1 páginas288b

    legacy

    4 páginas363a

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 oct 2007

    11 páginasAA

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resoluciones

    Sub diveded 13/07/2008
    RES13

    legacy

    1 páginas225

    legacy

    1 páginas288b

    legacy

    1 páginas288a

    ¿Quiénes son los directivos de ASPECT VISION CARE?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    KAUFMAN, Carol Rose
    3400 Oakhill Court
    San Mateo
    California
    Usa
    Director
    3400 Oakhill Court
    San Mateo
    California
    Usa
    United StatesAmerican80908120001
    MATZ, Gregory Wayne
    White Oak Way
    94949 Novato
    1
    California
    United States Of America
    Director
    White Oak Way
    94949 Novato
    1
    California
    United States Of America
    UsaAmerican165444120001
    WILKINSON, Michael Francis
    Hill Pound
    SO32 2UN Swanmore
    Hawthorn Cottage
    Hampshire
    United Kingdom
    Director
    Hill Pound
    SO32 2UN Swanmore
    Hawthorn Cottage
    Hampshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish131404720001
    BUSSEY, Ian Robert
    3 Chapel Court
    SO20 8AD Broughton
    Hampshire
    Secretario
    3 Chapel Court
    SO20 8AD Broughton
    Hampshire
    British124114740001
    EDWARDS, Alan Wayne
    Concorde Way
    Segensworth North
    PO15 5RL Fareham
    Delta Park
    Hampshire
    United Kingdom
    Secretario
    Concorde Way
    Segensworth North
    PO15 5RL Fareham
    Delta Park
    Hampshire
    United Kingdom
    British136806120001
    EDWARDS, Alan Wayne
    Apartment 33
    23 Hulse Road
    SO15 2QZ Southampton
    Hampshire
    Secretario
    Apartment 33
    23 Hulse Road
    SO15 2QZ Southampton
    Hampshire
    British63648340002
    GALLEY, Anthony David
    Beacon Wey The Hangers
    Bishops Waltham
    SO32 1FZ Southampton
    Hampshire
    Secretario
    Beacon Wey The Hangers
    Bishops Waltham
    SO32 1FZ Southampton
    Hampshire
    British16170510004
    HENDERSON, James Peter
    Flat 2
    Mirage, 33 Shore Road
    BH13 7PJ Poole
    Dorset
    Secretario
    Flat 2
    Mirage, 33 Shore Road
    BH13 7PJ Poole
    Dorset
    British108797680003
    ARAGON, Juan Carlos
    Alma Avenue #202
    Walnut Creek
    1800
    California 94596
    United States Of America
    Director
    Alma Avenue #202
    Walnut Creek
    1800
    California 94596
    United States Of America
    United States Of AmericaAmerican165443000001
    BEVIS, Barrie
    53 Wilderness Heights
    West End
    SO18 3PS Southampton
    Hampshire
    Director
    53 Wilderness Heights
    West End
    SO18 3PS Southampton
    Hampshire
    British41012560001
    BROOKER, Wilfred Trevor
    Grimbles Barn
    Buckland Village
    HP22 5HY Aston Clinton
    Buckinghamshire
    Director
    Grimbles Barn
    Buckland Village
    HP22 5HY Aston Clinton
    Buckinghamshire
    British19394670001
    BUSSEY, Ian Robert
    3 Chapel Court
    SO20 8AD Broughton
    Hampshire
    Director
    3 Chapel Court
    SO20 8AD Broughton
    Hampshire
    United KingdomBritish124114740001
    CARROLL, Glenn Anthony John
    34 Spitfire Way
    Hamble
    SO31 4RT Southampton
    Hampshire
    Director
    34 Spitfire Way
    Hamble
    SO31 4RT Southampton
    Hampshire
    British74851390003
    DE CARLE, John Trevor
    Lowicks House Sandy Lane
    Tilford
    GU10 2EX Farnham
    Surrey
    Director
    Lowicks House Sandy Lane
    Tilford
    GU10 2EX Farnham
    Surrey
    United KingdomBritish25107730001
    EDWARDS, Alan Wayne
    Apartment 33
    23 Hulse Road
    SO15 2QZ Southampton
    Hampshire
    Director
    Apartment 33
    23 Hulse Road
    SO15 2QZ Southampton
    Hampshire
    British63648340002
    FRYLING, Gregory Alan
    29802 High View Circle
    San Juan Capistrano
    FOREIGN California
    92675
    Usa
    Director
    29802 High View Circle
    San Juan Capistrano
    FOREIGN California
    92675
    Usa
    American55962330001
    GALLEY, Anthony David
    Summer Lodge
    The Coach Road, West Tytherley
    SP5 1LB Salisbury
    Wiltshire
    Director
    Summer Lodge
    The Coach Road, West Tytherley
    SP5 1LB Salisbury
    Wiltshire
    British16170510006
    GALLEY, Geoffrey Harrison
    Red Lodge The Close
    Totteridge
    N20 8PJ London
    Director
    Red Lodge The Close
    Totteridge
    N20 8PJ London
    United KingdomBritish13521740001
    HENDERSON, James Peter
    Flat 2
    Mirage, 33 Shore Road
    BH13 7PJ Poole
    Dorset
    Director
    Flat 2
    Mirage, 33 Shore Road
    BH13 7PJ Poole
    Dorset
    British108797680003
    MCDERMOTT, Ian Arthur
    North View 75 Upper Barn Copse
    Fair Oak
    SO50 8DB Eastleigh
    Hampshire
    Director
    North View 75 Upper Barn Copse
    Fair Oak
    SO50 8DB Eastleigh
    Hampshire
    British62576510001
    MIDLOCK, Eugene Joseph
    Campbell Avenue
    CA 94024 Los Altos
    999
    California
    United States Of America
    Director
    Campbell Avenue
    CA 94024 Los Altos
    999
    California
    United States Of America
    Other128896780001
    NEIL, Steven Mead
    26343 Esperanza Drive
    Los Altos Hills
    California
    Ca 94022
    United States Of America
    Director
    26343 Esperanza Drive
    Los Altos Hills
    California
    Ca 94022
    United States Of America
    United States Of AmericaUnited States108650690001
    SEDGWICK, Andrew Nigel
    Garrison Hill
    Droxford
    SO32 3QL Southampton
    The Crest
    Hampshire
    United Kingdom
    Director
    Garrison Hill
    Droxford
    SO32 3QL Southampton
    The Crest
    Hampshire
    United Kingdom
    British103237160003
    WEISS, Robert Stephen
    1775 Spumante Place
    Pleasanton
    California Ca 94566
    Usa
    Director
    1775 Spumante Place
    Pleasanton
    California Ca 94566
    Usa
    American86354710001
    WYATT, Simon David
    14 Bleriot Crescent
    Whiteley
    PO15 7JD Fareham
    Hampshire
    Director
    14 Bleriot Crescent
    Whiteley
    PO15 7JD Fareham
    Hampshire
    British76917880001

    ¿Tiene ASPECT VISION CARE alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Debenture
    Creado el 01 may 2002
    Entregado el 14 may 2002
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from any of the UK borrowers or any of the UK guarantors to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Keybank National Association (As Security Trustee)
    Transacciones
    • 14 may 2002Registro de un cargo (395)
    • 18 ene 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal mortgage
    Creado el 16 jun 1997
    Entregado el 01 jul 1997
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    F/H property known as land lying to the south of hamble lane hamble hampshire t/n-HP359537.. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 01 jul 1997Registro de un cargo (395)
    • 29 abr 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 27 sept 1996
    Entregado el 16 oct 1996
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £300,000 (the defered payment) due or to become due from the company to the chargee under the terms of an agreement of even date
    Breve descripción
    F/H land at south point industrial park ensign way hamble k/a unit 2 ensign way and adjoining land.
    Personas con derecho
    • Arc Property Developments Limited
    Transacciones
    • 16 oct 1996Registro de un cargo (395)
    • 20 feb 1999Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal mortgage
    Creado el 27 sept 1996
    Entregado el 04 oct 1996
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    F/H property k/a unit 2 southpoint hamble southampton hampshire part t/no.HP516344 and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 04 oct 1996Registro de un cargo (395)
    • 29 abr 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Fixed equitable charge
    Creado el 02 sept 1994
    Entregado el 09 sept 1994
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    All book debts invoice debts accounts notes bills acceptances and/or other forms of obligation (receivables) the subject of a factoring agreement, all title property right or interest in any goods & all guarantees indemnities insurances or securities. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Griffin Factors Limited
    Transacciones
    • 09 sept 1994Registro de un cargo (395)
    • 31 mar 1998Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Rent security deposit deed
    Creado el 19 jul 1994
    Entregado el 08 ago 1994
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    The due performance and observance of the covenants,agreements and conditions from the company to the chargee under the lease
    Breve descripción
    £13,000 in an account in the name of baker & mckenzie of 100 new bridge st,london EC4V 6JA pursuant to the rent deposit deed.
    Personas con derecho
    • Arc Properties Developments Limited
    Transacciones
    • 08 ago 1994Registro de un cargo (395)
    • 19 nov 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 29 oct 1991
    Entregado el 31 oct 1991
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    All book debts and benefits thereto.
    Personas con derecho
    • Maddox Factoring (UK) Limited
    Transacciones
    • 31 oct 1991Registro de una carga
    • 05 jun 1997Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creado el 28 jun 1989
    Entregado el 05 jul 1989
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Legal mortgage over unit b northbridge road berkhamsted herts t/n hd 133568 and/or proceeds of sale thereof.. A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 05 jul 1989Registro de una carga
    • 29 abr 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creado el 02 nov 1988
    Entregado el 04 nov 1988
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £112,226.77 and all other monies due or to become due from the company to the chargee. Under the terms of a the charge.
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Geoffrey Harrison Galley
    Transacciones
    • 04 nov 1988Registro de una carga
    Debenture
    Creado el 08 dic 1982
    Entregado el 16 dic 1982
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed & floating charge over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital, buildings fixtures, fixed plant & machinery.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 16 dic 1982Registro de una carga
    Charge
    Creado el 27 abr 1981
    Entregado el 06 may 1981
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    All book debts and other debts now and from time to time due owing or incurred to the company.
    Personas con derecho
    • Midland Bank PLC
    Transacciones
    • 06 may 1981Registro de una carga
    Mortgage
    Creado el 04 ago 1980
    Entregado el 08 ago 1980
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    F/H land & premises unit b nathbridge road beckhamsted herts together with fixtures whatsoever.
    Personas con derecho
    • Midland Bank PLC
    Transacciones
    • 08 ago 1980Registro de una carga
    Floating charge
    Creado el 07 mar 1980
    Entregado el 14 mar 1980
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    A floating charge over the undertaking and all property and assets presen t and future including book debts uncalled capital.
    Personas con derecho
    • Midland Bank PLC
    Transacciones
    • 14 mar 1980Registro de una carga

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0