EMAP RADIO (NORTH EAST) LIMITED

EMAP RADIO (NORTH EAST) LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaEMAP RADIO (NORTH EAST) LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 01144062
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de EMAP RADIO (NORTH EAST) LIMITED?

    • Compañía no comercial (74990) / Actividades profesionales, científicas y técnicas
    • Empresa inactiva (99999) / Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales

    ¿Dónde se encuentra EMAP RADIO (NORTH EAST) LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Greater London House
    Hampstead Road
    NW1 7EJ London
    United Kingdom
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de EMAP RADIO (NORTH EAST) LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    METRO RADIO GROUP LIMITED25 nov 198825 nov 1988
    NORTH EAST BROADCASTING CO. PLC 07 nov 197307 nov 1973

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de EMAP RADIO (NORTH EAST) LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2010

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para EMAP RADIO (NORTH EAST) LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Cese del nombramiento de Emily Henrietta Gestetner como director el 29 jun 2012

    1 páginasTM01

    Nombramiento de John Keith Gulliver como director el 11 jun 2012

    2 páginasAP01

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Cambio de datos del director Mr Duncan Anthony Painter el 02 abr 2012

    2 páginasCH01

    Déclaration annuelle établie au 31 mar 2012 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital02 abr 2012

    Estado de capital el 02 abr 2012

    • Capital: GBP 1
    SH01

    legacy

    3 páginasMG04

    Nombramiento de Mr Duncan Anthony Painter como director el 22 dic 2011

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Martyn John Hindley como director el 22 dic 2011

    1 páginasTM01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2010

    13 páginasAA

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Misceláneos

    Section 519
    1 páginasMISC

    Déclaration annuelle établie au 31 mar 2011 avec liste complète des actionnaires

    3 páginasAR01

    Estado de capital el 15 dic 2010

    • Capital: GBP 1
    4 páginasSH19

    legacy

    1 páginasSH20

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resoluciones

    Reduce share prem account 09/11/2010
    RES13

    Resoluciones

    Resolutions
    30 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resolución de asignación de valores

    RES10
    incorporation

    Resolución de adopción de los Artículos de Asociación

    RES01

    Cambio de datos del director Martyn John Hindley el 30 sept 2010

    2 páginasCH01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2009

    2 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 31 mar 2010 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01

    Cambio de datos del secretario Ms Shanny Looi el 01 mar 2010

    1 páginasCH03

    Cambio de datos del director Martyn John Hindley el 01 mar 2010

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del director Emily Henrietta Gestetner el 01 mar 2010

    2 páginasCH01

    Cese del nombramiento de Helen Frances Hay como secretario

    1 páginasTM02

    ¿Quiénes son los directivos de EMAP RADIO (NORTH EAST) LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    LOOI, Shanny
    Hampstead Road
    NW1 7EJ London
    Greater London House
    United Kingdom
    Secretario
    Hampstead Road
    NW1 7EJ London
    Greater London House
    United Kingdom
    British129906110001
    GULLIVER, John Keith
    Hampstead Road
    NW1 7EJ London
    Greater London House
    United Kingdom
    Director
    Hampstead Road
    NW1 7EJ London
    Greater London House
    United Kingdom
    United KingdomBritish170112360001
    PAINTER, Duncan Anthony
    Hampstead Road
    NW1 7EJ London
    Greater London House
    United Kingdom
    Director
    Hampstead Road
    NW1 7EJ London
    Greater London House
    United Kingdom
    EnglandBritish132649960001
    ELSDON, Kate
    51 Sackville Crescent
    Harold Wood
    RM3 0EH Romford
    Essex
    Secretario
    51 Sackville Crescent
    Harold Wood
    RM3 0EH Romford
    Essex
    British107227940002
    GILES, Nicholas David Martin
    8 Pyms Gardens
    Abbotsley
    PE19 6UR St Neots
    Cambs
    Secretario
    8 Pyms Gardens
    Abbotsley
    PE19 6UR St Neots
    Cambs
    British85529870001
    HAY, Helen Frances
    MK43 7BB Odell
    The Old Stable Yard
    Beds
    Secretario
    MK43 7BB Odell
    The Old Stable Yard
    Beds
    146425180001
    HENSON, Mark Richard
    5 Hazeland Steading
    PE10 0PW Morton
    Lincolnshire
    Secretario
    5 Hazeland Steading
    PE10 0PW Morton
    Lincolnshire
    British104630800001
    HOGG, Marianne Lisa
    43b Norroy Road
    Putney
    SW15 1PQ London
    Secretario
    43b Norroy Road
    Putney
    SW15 1PQ London
    British101383970001
    LAWRENCE, Eric Alexander
    26 Foxhills Covert
    Whickham
    NE16 5TN Newcastle Upon Tyne
    Secretario
    26 Foxhills Covert
    Whickham
    NE16 5TN Newcastle Upon Tyne
    British4250810002
    NAREBOR, Torugbene Eniyekeye
    10 Portland Road
    ME7 2NP Gillingham
    Kent
    Secretario
    10 Portland Road
    ME7 2NP Gillingham
    Kent
    British120147010002
    WALMSLEY, Derek Kerr
    High Street
    Pavenham
    MK43 7NJ Bedford
    Walnut Barn
    Bedfordshire
    Secretario
    High Street
    Pavenham
    MK43 7NJ Bedford
    Walnut Barn
    Bedfordshire
    British135181230001
    AITCHISON, Sally Fiona
    Redplains
    118 Darlington Road, Hartburn
    TS18 5EZ Stockton
    Cleveland
    Director
    Redplains
    118 Darlington Road, Hartburn
    TS18 5EZ Stockton
    Cleveland
    United KingdomBritish152260030001
    BHAKTA-JONES, Nilema
    7b Wolseley Road
    N8 8RR London
    Director
    7b Wolseley Road
    N8 8RR London
    United KingdomBritish124888590001
    BROWN, James
    25 Trinity Courtyard
    St Peters Marina
    NE6 1TS Newcastle Upon Tyne
    Director
    25 Trinity Courtyard
    St Peters Marina
    NE6 1TS Newcastle Upon Tyne
    British50345140001
    CHAPMAN, Elizabeth Mary
    Stonehaven
    Coatham House Farm
    DL1 3NJ Darlington
    County Durham
    Director
    Stonehaven
    Coatham House Farm
    DL1 3NJ Darlington
    County Durham
    EnglandBritish109560890001
    CHARLTON, John, Sir
    Cairn Lodge
    Dalton Ponteland
    NE18 0AB Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    Director
    Cairn Lodge
    Dalton Ponteland
    NE18 0AB Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    United KingdomBritish30542180002
    CHRISTOPHER, Martin Graham
    Rose Villa Bridgend
    Carlton
    MK43 7LP Bedford
    Director
    Rose Villa Bridgend
    Carlton
    MK43 7LP Bedford
    EnglandBritish4387050001
    COLE, Christopher Michael
    Lucas Avenue
    HA2 9JU Harrow
    30
    Middlesex
    England
    Director
    Lucas Avenue
    HA2 9JU Harrow
    30
    Middlesex
    England
    United KingdomBritish133510510001
    DOBSON, Maurice John
    14 Haughton Terrace
    NE24 2HA Blyth
    Northumberland
    Director
    14 Haughton Terrace
    NE24 2HA Blyth
    Northumberland
    United KingdomBritish47946730001
    DUNNE, George Henry
    27 The Bridle
    Woodham Village
    DL5 4TH Newton Aycliffe
    County Durham
    Director
    27 The Bridle
    Woodham Village
    DL5 4TH Newton Aycliffe
    County Durham
    British72942820001
    ELLINGTON, Catherine
    2 The Woodlands
    Milbank Road
    DL3 9UB Darlington
    County Durham
    Director
    2 The Woodlands
    Milbank Road
    DL3 9UB Darlington
    County Durham
    British40793460002
    ELSDON, Kate
    51 Sackville Crescent
    Harold Wood
    RM3 0EH Romford
    Essex
    Director
    51 Sackville Crescent
    Harold Wood
    RM3 0EH Romford
    Essex
    British107227940002
    EMBLEY, Deborah Jayne
    Flat 1
    64 Cromwell Avenue Highgate
    N6 5HQ London
    Director
    Flat 1
    64 Cromwell Avenue Highgate
    N6 5HQ London
    EnglandBritish75933680001
    EYRE, Richard Anthony
    31 Croham Park Avenue
    CR2 7HN South Croydon
    Surrey
    Director
    31 Croham Park Avenue
    CR2 7HN South Croydon
    Surrey
    British5219910001
    EYRE TANNER, Peter Giles
    The Old Vicarage The Village
    NE65 9BL Acklington
    Morpeth Northumberland
    Director
    The Old Vicarage The Village
    NE65 9BL Acklington
    Morpeth Northumberland
    British50344640001
    GESTETNER, Emily Henrietta
    Hampstead Road
    NW1 7EJ London
    Greater London House
    United Kingdom
    Director
    Hampstead Road
    NW1 7EJ London
    Greater London House
    United Kingdom
    United KingdomBritish138386390001
    GRIGSON, David John
    Bainton Farmhouse
    Tallington Road, Bainton
    PE9 3AF Stamford
    Lincolnshire
    Director
    Bainton Farmhouse
    Tallington Road, Bainton
    PE9 3AF Stamford
    Lincolnshire
    British71511500001
    HINDLEY, Martyn John
    Hampstead Road
    NW1 7EJ London
    Greater London House
    United Kingdom
    Director
    Hampstead Road
    NW1 7EJ London
    Greater London House
    United Kingdom
    EnglandBritish134332760002
    HUNTER, Neil
    1 Kempton Close
    DH8 0UB Consett
    County Durham
    Director
    1 Kempton Close
    DH8 0UB Consett
    County Durham
    EnglandBritish69380910001
    HUNTINGFORD, Richard Norman Legh
    39 Amerland Road
    SW18 1QA London
    Director
    39 Amerland Road
    SW18 1QA London
    British3297910001
    JOHNSON, Michael
    144 Edge Hill
    Ponteland
    NE20 9JN Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    Director
    144 Edge Hill
    Ponteland
    NE20 9JN Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    British23322950001
    JOSEPHS, John Irving
    22 Osbaldeston Gardens
    NE3 4JE Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    Director
    22 Osbaldeston Gardens
    NE3 4JE Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    United KingdomBritish3830990001
    LAVELLI, John Stephen
    2 Nathans Close
    AL6 9QB Welwyn
    Hertfordshire
    Director
    2 Nathans Close
    AL6 9QB Welwyn
    Hertfordshire
    British56438160001
    LAWRENCE, Eric Alexander
    26 Foxhills Covert
    Whickham
    NE16 5TN Newcastle Upon Tyne
    Director
    26 Foxhills Covert
    Whickham
    NE16 5TN Newcastle Upon Tyne
    British4250810002
    LEDGER, Graham Arthur
    37 Brendon Grove
    Sober Hall Ingleby Barwick
    TS17 0PH Stockton On Tees
    Cleveland
    Director
    37 Brendon Grove
    Sober Hall Ingleby Barwick
    TS17 0PH Stockton On Tees
    Cleveland
    British50345060001

    ¿Tiene EMAP RADIO (NORTH EAST) LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Legal charge
    Creado el 28 feb 1992
    Entregado el 13 mar 1992
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee.pursuant to an agreement dated 9 august 1991.
    Breve descripción
    Land k/a zone I teesdale and greater teesdale thornaby,cleveland.
    Personas con derecho
    • Teesside Development Corporation
    Transacciones
    • 13 mar 1992Registro de un cargo (395)
    • 15 mar 2012Declaración de que parte o la totalidad de la propiedad gravada ha sido liberada (MG04)
    Charge
    Creado el 17 nov 1986
    Entregado el 04 dic 1986
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including bookdebts & uncalled capital.
    Personas con derecho
    • Midland Bank PLC
    Transacciones
    • 04 dic 1986Registro de una carga
    Mortgage
    Creado el 23 jun 1975
    Entregado el 01 jul 1975
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Floating charge. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Personas con derecho
    • Midland Bank PLC
    Transacciones
    • 01 jul 1975Registro de una carga
    • 09 sept 1992Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Mortgage
    Creado el 23 jun 1975
    Entregado el 01 jul 1975
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Hannington works, swapwell, newcastle upon tyne together with all fixtures.
    Personas con derecho
    • Midland Bank PLC
    Transacciones
    • 01 jul 1975Registro de una carga
    • 09 sept 1992Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0