CHRISDELL LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Cuentas
  • Declaración de confirmación
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaCHRISDELL LIMITED
    Estado de la empresaActiva
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 01150511
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de CHRISDELL LIMITED?

    • Compraventa de bienes inmobiliarios propios (68100) / Actividades inmobiliarias
    • Otro alquiler y explotación de bienes inmobiliarios propios o arrendados (68209) / Actividades inmobiliarias

    ¿Dónde se encuentra CHRISDELL LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Citygate
    Saint James Boulevard
    NE1 4JE Newcastle Upon Tyne
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de CHRISDELL LIMITED?

    VencidoNo
    Próximas cuentas
    Próximo período contable finaliza el30 sept 2024
    Próximas cuentas vencen el30 jun 2025
    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta30 sept 2023

    ¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para CHRISDELL LIMITED?

    Última declaración de confirmación cerrada hasta17 jul 2025
    Próxima declaración de confirmación vence31 jul 2025
    Última declaración de confirmación
    Próxima declaración de confirmación cerrada hasta17 jul 2024
    VencidoNo

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para CHRISDELL LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Nombramiento de Mrs Sapna Bedi Fitzgerald como director el 30 sept 2024

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Adam Mcghin como director el 27 sept 2024

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mrs Sapna Bedi Fitzgerald como secretario el 30 sept 2024

    2 páginasAP03

    Cese del nombramiento de Adam Mcghin como secretario el 27 sept 2024

    1 páginasTM02

    Declaración de confirmación presentada el 17 jul 2024 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 sept 2023

    6 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 13 jul 2023 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 sept 2022

    6 páginasAA

    Cese del nombramiento de Robert Jan Hudson como director el 05 dic 2022

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Helen Christine Gordon como director el 05 dic 2022

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Toby Edward Austin como director el 09 nov 2022

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Eliza Pattinson como director el 09 nov 2022

    1 páginasTM01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 sept 2021

    6 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 13 jul 2022 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Nombramiento de Mr Robert Jan Hudson como director el 25 mar 2022

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Mr Toby Edward Austin como director el 17 nov 2021

    2 páginasAP01

    Cambio de datos del director Ms Helen Christine Gordon el 27 may 2021

    2 páginasCH01

    Segunda presentación para la terminación de Vanessa Kate Simms como director

    3 páginasRP04TM01

    Declaración de confirmación presentada el 08 jul 2021 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 sept 2020

    6 páginasAA

    Cese del nombramiento de Vanessa Kate Simms como director el 23 abr 2021

    2 páginasTM01
    Anotaciones
    FechaAnotación
    28 jul 2021Clarification A second filed TM01 was registered on 28/07/2021.

    Declaración de confirmación presentada el 06 jul 2020 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 sept 2019

    6 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 05 jul 2019 con actualizaciones

    4 páginasCS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 sept 2018

    6 páginasAA

    ¿Quiénes son los directivos de CHRISDELL LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    FITZGERALD, Sapna Bedi
    Citygate
    Saint James Boulevard
    NE1 4JE Newcastle Upon Tyne
    Secretario
    Citygate
    Saint James Boulevard
    NE1 4JE Newcastle Upon Tyne
    328057670001
    FITZGERALD, Sapna Bedi
    Citygate
    Saint James Boulevard
    NE1 4JE Newcastle Upon Tyne
    Director
    Citygate
    Saint James Boulevard
    NE1 4JE Newcastle Upon Tyne
    United KingdomBritishSolicitor327770380001
    DAVIS, Geoffrey Joseph
    9 The Copse
    Burnopfield
    NE16 6HA Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    Secretario
    9 The Copse
    Burnopfield
    NE16 6HA Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    BritishCompany Secretary65421150001
    GLANVILLE, Marie Louise
    28 Bramhall Drive
    High Generals Wood Rickleton
    NE38 9DB Washington
    Tyne & Wear
    Secretario
    28 Bramhall Drive
    High Generals Wood Rickleton
    NE38 9DB Washington
    Tyne & Wear
    English86483290001
    HACKER, Max
    97 Bury Street
    N9 7JP London
    Secretario
    97 Bury Street
    N9 7JP London
    British3703230001
    MCGHIN, Adam
    St James' Boulevard
    NE1 4JE Newcastle
    Citygate
    United Kingdom
    Secretario
    St James' Boulevard
    NE1 4JE Newcastle
    Citygate
    United Kingdom
    206240830001
    WINDLE, Michael Patrick
    Stanton Townhead
    NE65 8PR Morpeth
    High Priar
    Northumberland
    Secretario
    Stanton Townhead
    NE65 8PR Morpeth
    High Priar
    Northumberland
    British135308530001
    AUSTIN, Toby Edward
    St James' Boulevard
    NE1 4JE Newcastle Upon Tyne
    Citygate
    United Kingdom
    Director
    St James' Boulevard
    NE1 4JE Newcastle Upon Tyne
    Citygate
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector248037200002
    BALDWIN, Christopher Robert
    Steps House Westfield Road
    CM23 2RE Bishops Stortford
    Hertfordshire
    Director
    Steps House Westfield Road
    CM23 2RE Bishops Stortford
    Hertfordshire
    EnglandBritishSolicitor237438160001
    COLEMAN, John Frederick
    54 Gordon Avenue
    HA7 3QH Stanmore
    Middlesex
    Director
    54 Gordon Avenue
    HA7 3QH Stanmore
    Middlesex
    BritishSolicitor9725930001
    COUCH, Peter Quentin Patrick
    Amberley
    GL5 5AG Gloucestershire
    Follifoot House
    Director
    Amberley
    GL5 5AG Gloucestershire
    Follifoot House
    UkBritishDirector Of Equity Release156117090001
    CRUMBLEY, Brian Aidan
    10 Westfield Grove
    Gosforth
    NE3 4YA Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    Director
    10 Westfield Grove
    Gosforth
    NE3 4YA Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    EnglandBritishChartered Surveyor8495220002
    CUNNINGHAM, Andrew Rolland
    St James' Boulevard
    NE1 4JE Newcastle Upon Tyne
    Citygate
    United Kingdom
    Director
    St James' Boulevard
    NE1 4JE Newcastle Upon Tyne
    Citygate
    United Kingdom
    EnglandBritishChartered Accountant74581390003
    DAVIS, Geoffrey Joseph
    17 Lintzford Road
    Hamsterley Mill Rowlands Gill
    NE39 1HA Newcastle Upon Tyne
    Director
    17 Lintzford Road
    Hamsterley Mill Rowlands Gill
    NE39 1HA Newcastle Upon Tyne
    EnglandBritishCompany Secretary65421150003
    DICKINSON, Rupert Jerome
    59 Albert Bridge Road
    SW11 4AQ London
    Director
    59 Albert Bridge Road
    SW11 4AQ London
    United KingdomBritishChartered Surveyor60267600001
    DICKINSON, Stephen
    Crow Hall
    NE47 7BJ Bardon Mill
    Northumberland
    Director
    Crow Hall
    NE47 7BJ Bardon Mill
    Northumberland
    United KingdomBritishChartered Accountant8256950001
    GORDON, Helen Christine
    St. James Boulevard
    NE1 4JE Newcastle Upon Tyne
    Citygate
    Tyne And Wear
    Director
    St. James Boulevard
    NE1 4JE Newcastle Upon Tyne
    Citygate
    Tyne And Wear
    United KingdomBritishCompany Director59902650002
    GREENWOOD, Mark
    Citygate
    Saint James Boulevard
    NE1 4JE Newcastle Upon Tyne
    Director
    Citygate
    Saint James Boulevard
    NE1 4JE Newcastle Upon Tyne
    United KingdomBritishCompany Director154194730002
    HACKER, Manfred
    23 Pretoria Crescent
    E4 7HE London
    Director
    23 Pretoria Crescent
    E4 7HE London
    BolivianProperty Developer3703240001
    HACKER, Rosa
    Cassila 915
    Santa Cruz
    FOREIGN
    Bolivia
    Director
    Cassila 915
    Santa Cruz
    FOREIGN
    Bolivia
    BolivianHousewife3703250001
    HUDSON, Robert Jan
    Citygate
    Saint James Boulevard
    NE1 4JE Newcastle Upon Tyne
    Director
    Citygate
    Saint James Boulevard
    NE1 4JE Newcastle Upon Tyne
    United KingdomBritishCompany Director201533990002
    JOPLING, Nicholas Mark Fletcher
    Citygate
    Saint James Boulevard
    NE1 4JE Newcastle Upon Tyne
    Director
    Citygate
    Saint James Boulevard
    NE1 4JE Newcastle Upon Tyne
    EnglandBritishDirector60099210003
    MCGHIN, Adam
    St James' Boulevard
    NE1 4JE Newcastle
    Citygate
    United Kingdom
    Director
    St James' Boulevard
    NE1 4JE Newcastle
    Citygate
    United Kingdom
    United KingdomBritishSolicitor169082950001
    MILBURN, Peter Michael
    Derwent Lodge
    DH8 0TG Shotley Bridge
    County Durham
    Director
    Derwent Lodge
    DH8 0TG Shotley Bridge
    County Durham
    BritishDirector36406380001
    ON, Nicholas Peter
    Saint James' Boulevard
    NE1 4JE Newcastle Upon Tyne
    Citygate
    United Kingdom
    Director
    Saint James' Boulevard
    NE1 4JE Newcastle Upon Tyne
    Citygate
    United Kingdom
    United KingdomBritishLawyer135860930002
    PATTINSON, Eliza
    St James' Boulevard
    NE1 4JE Newcastle Upon Tyne
    Citygate
    United Kingdom
    Director
    St James' Boulevard
    NE1 4JE Newcastle Upon Tyne
    Citygate
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector257770240001
    PRATT, Andrew Michael
    Shadybrook, Beeches Drive
    Farnham Common
    SL2 3JT Slough
    Berkshire
    Director
    Shadybrook, Beeches Drive
    Farnham Common
    SL2 3JT Slough
    Berkshire
    EnglandBritishCompany Director123314130002
    ROBSON, Mark Jeremy
    Citygate
    Saint James Boulevard
    NE1 4JE Newcastle Upon Tyne
    Director
    Citygate
    Saint James Boulevard
    NE1 4JE Newcastle Upon Tyne
    United KingdomBritishChartered Surveyor97977930003
    SCHWERDT, Peter Christopher George
    Newtown House
    Alton Barnes
    SN8 4LB Marlborough
    Wiltshire
    Director
    Newtown House
    Alton Barnes
    SN8 4LB Marlborough
    Wiltshire
    United KingdomBritishCompany Director44923060004
    SIMMS, Vanessa Kate
    St James' Boulevard
    NE1 4JE Newcastle Upon Tyne
    Citygate
    United Kingdom
    Director
    St James' Boulevard
    NE1 4JE Newcastle Upon Tyne
    Citygate
    United Kingdom
    EnglandBritishCompany Director205191690001
    SLADE, Sean Anthony
    Idlewood
    Maidenhead Road
    SL6 9DF Cookham
    Berkshire
    Director
    Idlewood
    Maidenhead Road
    SL6 9DF Cookham
    Berkshire
    BritishChartered Surveyor94640230001
    YUDOLPH, Debra Rachel
    43 Netheravon Road
    W4 2AN London
    Director
    43 Netheravon Road
    W4 2AN London
    EnglandBritishProperty Manager105582680001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de CHRISDELL LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Saint. James' Boulevard
    NE1 4JE Newcastle Upon Tyne
    Citygate
    United Kingdom
    06 abr 2016
    Saint. James' Boulevard
    NE1 4JE Newcastle Upon Tyne
    Citygate
    United Kingdom
    No
    Forma jurídicaLimited By Shares
    País de registroEngland & Wales
    Autoridad legalUnited Kingdom (England & Wales)
    Lugar de registroCompanies House
    Número de registro3910945
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.
    • La persona tiene el derecho, directa o indirectamente, de nombrar o destituir a la mayoría de la junta directiva de la empresa.

    ¿Tiene CHRISDELL LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Security agreement
    Creado el 30 jun 2004
    Entregado el 17 jul 2004
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from each obligor to the beneficiaries (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    By way of a first floating charge all of the company's properties and all other assets both present and future.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC as Agent and Trustee for Itself and Each of the Beneficiaries
    Transacciones
    • 17 jul 2004Registro de un cargo (395)
    • 19 feb 2015Satisfacción de una carga (MR04)
    Supplemental mortgage
    Creado el 30 mar 2001
    Entregado el 06 abr 2001
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All present and future obligations and liabilities due or to become due from the company or any of the borrowers (as defined) and/or any other subsidiary gurarantor (as defined) to the agent and/or any of the lenders (as defined) under or in connection with the finance documents (as defined) or otherwise on any account whatsoever
    Breve descripción
    The mortgage dated 13 april 2000 (as defined) shall be read and construed as if the words "any borrower" was substituted for the words "the borrower" in the definition "the secured obligations" in clause 1.1 of the mortgage.. The mortgage shall read as if the following clause was inserted as a new clause numbered 1.2.7 of the mortgage.. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Bradford & Bingley PLC
    Transacciones
    • 06 abr 2001Registro de un cargo (395)
    • 21 ago 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Mortgage
    Creado el 13 abr 2000
    Entregado el 27 abr 2000
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All obligations and liabilities due or to become due from the company and/or grainger properties limited to the chargee under the loan agreement dated 31 march 2000, other related documents or on any account whatsoever
    Breve descripción
    117 tennyson road, newham. T/no. EGL259677, third floor flat, 68 redcliffe square, london SW10. T/no. EGL29534, basement flat, 68 redcliffe square, london SW10. T/no. BGL29533, 1 cumberland road, haringey. T/no. NGL487974 and the proceeds of sale thereof and all buildings and trade and other fixtures all plant machinery and other equipment. All rights and interest in the policies of insurance, the benefit of any leases. Floating charge the undertaking and all its property assets and rights present and future. For details of further properties charged please refer to form 395. see the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Bradford & Bingley Building Society as Agent and Trustee for Itself and the Other Lenders
    Transacciones
    • 27 abr 2000Registro de un cargo (395)
    • 21 ago 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 28 nov 1994
    Entregado el 03 dic 1994
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    5 melbourne grove, london. Together with all fixtures and fittings now or at any time hereafter on the property. The benefits of all rights licences and the goodwill of the mortgagor in relation to the business from time to time carried on at the property.
    Personas con derecho
    • Midland Bank PLC
    Transacciones
    • 03 dic 1994Registro de un cargo (395)
    • 27 may 1998Declaración de que parte o la totalidad de la propiedad de una carga flotante ha sido liberada (403b)
    • 16 mar 2000Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 28 nov 1994
    Entregado el 03 dic 1994
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    71 arnold road, tottenham, london. Together with all fixtures and fittings now or at any time hereafter on the property. The benefits of all rights licences and the goodwill of the mortgagor in relation to the business from time to time carried on at the property.
    Personas con derecho
    • Midland Bank PLC
    Transacciones
    • 03 dic 1994Registro de un cargo (395)
    • 21 jul 1998Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 28 nov 1994
    Entregado el 03 dic 1994
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    F/H property k/a 124 boundary road, plaistow, london. Together with all fixtures and fittings now or at any time hereafter on the property. The benefits of all rights licences and the goodwill of the mortgagor in relation to the business from time to time carried on at the property.
    Personas con derecho
    • Midland Bank PLC
    Transacciones
    • 03 dic 1994Registro de un cargo (395)
    • 21 jul 1998Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 28 nov 1994
    Entregado el 03 dic 1994
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    64 helena road, plaistow, london. Together with all fixtures and fittings now or at any time hereafter on the property. The benefits of all rights licences and the goodwill of the mortgagor in relation to the business from time to time carried on at the property.
    Personas con derecho
    • Midland Bank PLC
    Transacciones
    • 03 dic 1994Registro de un cargo (395)
    • 21 jul 1998Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 23 jul 1993
    Entregado el 27 jul 1993
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Leasehold upstairs flat 1104 harrow road london NW10. Together with all fixtures and fittings now or at any time hereafter on the property. The benefits of all rights licences and the goodwill of the mortgagor in relation to the business from time to time carried on at the property.
    Personas con derecho
    • Midland Bank PLC
    Transacciones
    • 27 jul 1993Registro de un cargo (395)
    • 27 may 1998Declaración de que parte o la totalidad de la propiedad de una carga flotante ha sido liberada (403b)
    • 16 mar 2000Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 02 mar 1992
    Entregado el 03 mar 1992
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Land at 16 populars rd, london E.17. together with all fixtures and fittings rights licences and the goodwill.
    Personas con derecho
    • Midland Bank PLC
    Transacciones
    • 03 mar 1992Registro de un cargo (395)
    • 21 jul 1998Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 02 mar 1992
    Entregado el 03 mar 1992
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Land at 17 westbury rd, london E.7. together with all fixtures and fittings rights licences and the goodwill.
    Personas con derecho
    • Midland Bank PLC
    Transacciones
    • 03 mar 1992Registro de un cargo (395)
    • 21 jul 1998Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 18 jul 1991
    Entregado el 26 jul 1991
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    F/H 83 patrick road london e 13 9QE.
    Personas con derecho
    • Midland Bank PLC
    Transacciones
    • 26 jul 1991Registro de una carga
    • 27 may 1998Declaración de que parte o la totalidad de la propiedad de una carga flotante ha sido liberada (403b)
    • 16 mar 2000Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 18 dic 1990
    Entregado el 20 dic 1990
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    F/H 33, chirston avenue, upton park.
    Personas con derecho
    • Midland Bank PLC
    Transacciones
    • 20 dic 1990Registro de una carga
    • 21 jul 1998Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 18 dic 1990
    Entregado el 20 dic 1990
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    F/H 244 & 244A stone road manor park.
    Personas con derecho
    • Midland Bank PLC
    Transacciones
    • 20 dic 1990Registro de una carga
    • 27 may 1998Declaración de que parte o la totalidad de la propiedad de una carga flotante ha sido liberada (403b)
    • 16 mar 2000Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 18 dic 1990
    Entregado el 20 dic 1990
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    F/H 20 mafeking avenue, brentford.
    Personas con derecho
    • Midland Bank PLC
    Transacciones
    • 20 dic 1990Registro de una carga
    • 27 may 1998Declaración de que parte o la totalidad de la propiedad de una carga flotante ha sido liberada (403b)
    • 16 mar 2000Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 20 ago 1990
    Entregado el 28 ago 1990
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    F/H 62, chiswick lane hounslow title no mx 212484.
    Personas con derecho
    • Midland Bank PLC
    Transacciones
    • 28 ago 1990Registro de una carga
    • 27 may 1998Declaración de que parte o la totalidad de la propiedad de una carga flotante ha sido liberada (403b)
    • 16 mar 2000Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 09 ago 1990
    Entregado el 14 ago 1990
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    F/H 30 knox road forest gate.
    Personas con derecho
    • Midland Bank PLC
    Transacciones
    • 14 ago 1990Registro de una carga
    • 21 jul 1998Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 29 jun 1990
    Entregado el 06 jul 1990
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    107 norman road london E11.
    Personas con derecho
    • Midland Bank PLC
    Transacciones
    • 06 jul 1990Registro de una carga
    • 21 jul 1998Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 29 jun 1990
    Entregado el 06 jul 1990
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    45 hartfield crescent wimbledon.
    Personas con derecho
    • Midland Bank PLC
    Transacciones
    • 06 jul 1990Registro de una carga
    • 27 may 1998Declaración de que parte o la totalidad de la propiedad de una carga flotante ha sido liberada (403b)
    • 16 mar 2000Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 29 jun 1990
    Entregado el 06 jul 1990
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    12 plough lane wimbledon.
    Personas con derecho
    • Midland Bank PLC
    Transacciones
    • 06 jul 1990Registro de una carga
    • 27 may 1998Declaración de que parte o la totalidad de la propiedad de una carga flotante ha sido liberada (403b)
    • 16 mar 2000Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 29 jun 1990
    Entregado el 06 jul 1990
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    7 huddlestone road london E7.
    Personas con derecho
    • Midland Bank PLC
    Transacciones
    • 06 jul 1990Registro de una carga
    • 27 may 1998Declaración de que parte o la totalidad de la propiedad de una carga flotante ha sido liberada (403b)
    • 16 mar 2000Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 29 jun 1990
    Entregado el 06 jul 1990
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    30 east bournia avenue london N9.
    Personas con derecho
    • Midland Bank PLC
    Transacciones
    • 06 jul 1990Registro de una carga
    • 21 jul 1998Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 21 may 1990
    Entregado el 11 jun 1990
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    F/H 117 tennyson road stratford.
    Personas con derecho
    • Midland Bank PLC
    Transacciones
    • 11 jun 1990Registro de una carga
    • 21 jul 1998Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 11 ene 1990
    Entregado el 22 ene 1990
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    F/H 12, corporation street, london E15.
    Personas con derecho
    • Midland Bank PLC
    Transacciones
    • 22 ene 1990Registro de una carga
    • 21 jul 1998Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 11 ene 1990
    Entregado el 22 ene 1990
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    F/H 17, stock street, london E13.
    Personas con derecho
    • Midland Bank PLC
    Transacciones
    • 22 ene 1990Registro de una carga
    • 21 jul 1998Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 11 ene 1990
    Entregado el 22 ene 1990
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    F/H 36 & 38 caistor park road stratford E15.
    Personas con derecho
    • Midland Bank PLC
    Transacciones
    • 22 ene 1990Registro de una carga
    • 27 may 1998Declaración de que parte o la totalidad de la propiedad de una carga flotante ha sido liberada (403b)
    • 16 mar 2000Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0