01155247 LTD
Visión general
Nombre de la empresa | 01155247 LTD |
---|---|
Estado de la empresa | Disuelta |
Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
Número de empresa | 01155247 |
Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
Fecha de constitución | |
Fecha de cese |
Resumen
Tiene PSCs súper seguros | No |
---|---|
Tiene gravámenes | Sí |
Tiene historial de insolvencia | No |
La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de 01155247 LTD?
- Compañía no comercial (74990) / Actividades profesionales, científicas y técnicas
¿Dónde se encuentra 01155247 LTD?
Dirección de la sede social | c/o STORK TECHNICAL SERVICES Unit 21-24 Slaidburn Crescent PR9 9YF Southport Merseyside |
---|---|
Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de 01155247 LTD?
Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
---|---|---|
MORCEAU-AARONITE LIMITED | 22 abr 1987 | 22 abr 1987 |
MORCEAU (FIRE PROTECTION) LIMITED | 10 feb 1984 | 10 feb 1984 |
C.E.S. (PLUMBING & HEATING) LIMITED | 07 ene 1974 | 07 ene 1974 |
MORCEAU (FIRE PROTECTION) LIMITED | 07 ene 1974 | 07 ene 1974 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de 01155247 LTD?
Últimas cuentas | |
---|---|
Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2014 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para 01155247 LTD?
Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación obligatoria | 1 páginas | GAZ2 | ||||||||||||||
Se ha suspendido la acción de cancelación obligatoria | 1 páginas | DISS16(SOAS) | ||||||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación obligatoria | 1 páginas | GAZ1 | ||||||||||||||
Restauración por orden judicial | 3 páginas | AC92 | ||||||||||||||
Certificado de cambio de nombre Company name changed aaronite\certificate issued on 20/10/20 | páginas | CERTNM | ||||||||||||||
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Déclaration annuelle établie au 13 jun 2016 avec liste complète des actionnaires | 4 páginas | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
La dirección de inspección del registro se ha cambiado de Dundas & Wilson Llp North West Wing Bush House Aldwych London WC2B 4EZ a Stork Technical Services, Units 21-24 Slaidburn Industrial Estate Slaidburn Crescent Southport Merseyside PR9 9YF | 1 páginas | AD02 | ||||||||||||||
Nombramiento de Mr John Findlay como secretario el 01 ene 2016 | 2 páginas | AP03 | ||||||||||||||
Cese del nombramiento de Colin Carrick Watson como director el 31 dic 2015 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||
Cese del nombramiento de Colin Carrick Watson como secretario el 31 dic 2015 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 3 páginas | DS01 | ||||||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2014 | 10 páginas | AA | ||||||||||||||
Déclaration annuelle établie au 13 jun 2015 avec liste complète des actionnaires | 14 páginas | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Nombramiento de Mr David Andrew Stewart como director el 10 jul 2015 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de Dundas & Wilson Llp Northwest Wing, Bush House Aldwych London WC2B 4EZ a C/O Stork Technical Services Unit 21-24 Slaidburn Crescent Southport Merseyside PR9 9YF el 27 feb 2015 | 2 páginas | AD01 | ||||||||||||||
Déclaration annuelle établie au 13 jun 2014 avec liste complète des actionnaires | 5 páginas | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Estado de capital el 09 may 2014
| 4 páginas | SH19 | ||||||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2013 | 4 páginas | AA | ||||||||||||||
legacy | 1 páginas | CAP-SS | ||||||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Resoluciones Resolutions | 2 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Cese del nombramiento de David Workman como director | 2 páginas | TM01 | ||||||||||||||
Déclaration annuelle établie au 13 jun 2013 avec liste complète des actionnaires | 6 páginas | AR01 | ||||||||||||||
¿Quiénes son los directivos de 01155247 LTD?
Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FINDLAY, John | Secretario | c/o Stork Technical Services Slaidburn Crescent PR9 9YF Southport Unit 21-24 Merseyside | 205387880001 | |||||||
STEWART, David Andrew | Director | c/o Stork Technical Services Slaidburn Crescent PR9 9YF Southport Unit 21-24 Merseyside | United Kingdom | British | Finance Director | 193229060001 | ||||
BAIN, John Logie Cameron | Secretario | Upper Pitmunie Monymusk AB51 7HX Inverurie Aberdeenshire | British | Director | 76601180002 | |||||
BOWN, Julian Lemuel | Secretario | 19 Childsbridge Lane Kemsing TN15 6TJ Sevenoaks Kent | British | 105880001 | ||||||
CHISHOLM, Bruce | Secretario | Brooklinn House Den Of Cults AB15 9SJ Cults Aberdeenshire | British | 102208940001 | ||||||
FORBES, Robert Gordon | Secretario | 7 Woodville Place SG14 3NX Hertford Hertfordshire | British | Finance Director | 50248110002 | |||||
GLEN, Andrew Lundie | Secretario | 47 Cuthbert Court Bede Trading Estate NE32 3HG Jarrow Tyne & Wear | British | 161267440001 | ||||||
KIPPEN, Michael Leslie | Secretario | Flat 19a 42 Pulteney Street BA2 4DR Bath | British | Company Secretary | 12230900001 | |||||
KIPPEN, Michael Leslie | Secretario | 3 Camden Terrace BA1 5HZ Bath | British | 12230900002 | ||||||
WATSON, Colin Carrick | Secretario | Pitmedden Road Dyce AB21 0DP Aberdeen Norfolk House United Kingdom | British | 162894100001 | ||||||
ANTLIFF, Robert Francis | Director | The Court 22 Thornholme Road SR2 7QG Sunderland | British | Company Director | 44786400001 | |||||
ASHFIELD, David John, Dr | Director | 37 Nicholas Avenue Whitburn SR6 7DG Sunderland | Singapore | British | Director | 46822510001 | ||||
BAIN, John Logie Cameron | Director | Upper Pitmunie Monymusk AB51 7HX Inverurie Aberdeenshire | British | Director | 76601180002 | |||||
BOOTH, Paul Spencer | Director | 21 Windy Arbour CV8 2AT Kenilworth Warwickshire | British | Director | 105950002 | |||||
BRUCE, Andrew | Director | Strathnaver Station Road AB41 9AR Ellon Aberdeenshire | Scotland | British | Managing Director Uk | 45324080001 | ||||
CATT, David | Director | 25 Gleneagles Drive NG17 8NB Kirkby In Ashfield Nottinghamshire | British | Sales Director | 44786440001 | |||||
CLARK, Alexander | Director | 240 Queens Road AB1 8DN Aberdeen | United Kingdom | British | Director | 136094220002 | ||||
CLOUGH, Michael Anthony | Director | Apapa 2a Streetly Crescent Four Oaks B74 4PX Sutton Coldfield West Midlands | England | British | Company Director | 58508010001 | ||||
COOPER, Donald Alfred | Director | 22 Stanneylands Drive SK9 4ET Wilmslow Cheshire | British | Director | 108363160001 | |||||
CROOKES, Martin Andrew | Director | 1 The Drive Marcliffe Road S6 4AL Sheffield South Yorkshire | England | British | Commercial Director | 121488540001 | ||||
ELLIS, Richard John Muir | Director | Burnside Kingsford Mews AB33 8HN Alford Aberdeenshire Scotland | British | Chartered Engineer | 82194530001 | |||||
FORBES, Robert Gordon | Director | 7 Woodville Place SG14 3NX Hertford Hertfordshire | United Kingdom | British | Finance Director | 50248110002 | ||||
KING, Brian | Director | Oakleigh 4 Beaufort Gardens Burleigh Lane SL5 8PG Ascot Berks | British | Director | 710960001 | |||||
MCCANN, Edward Bryan | Director | Cherry Trees Uplands KT21 2TN Ashtead Surrey | British | Director | 36914880001 | |||||
RAY, John William | Director | Oakingham House Nuffield RG9 5TF Henley-On-Thames Oxfordshire | England | British | Anti Corrosion Engineer | 15648940002 | ||||
TURNER, Roger Alfred | Director | 62 Derwent Road WV6 9ES Wolverhampton West Midlands | British | Director | 64936840001 | |||||
TYEKIFF, Richard | Director | Maryland Horsegate Ride SL5 9LS Ascot Berkshire | British | Director | 43180820001 | |||||
WATSON, Colin Carrick | Director | Pitmedden Road Dyce AB21 0DP Aberdeen Norfolk House United Kingdom | Scotland | British | Lawyer & Company Director | 162886860001 | ||||
WATSON, David Twells | Director | Heathfield 6 Blakebrook DY11 6AP Kidderminster Worcestershire | England | British | Company Director | 79100950001 | ||||
WORKMAN, David Miller | Director | Northwest Wing, Bush House Aldwych WC2B 4EZ London Dundas & Wilson Llp United Kingdom | Scotland | British | Director | 64928850001 |
¿Tiene 01155247 LTD alguna carga?
Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
---|---|---|---|---|
Debenture | Creado el 02 may 1996 Entregado el 11 may 1996 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Legal charge | Creado el 02 may 1996 Entregado el 10 may 1996 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge | |
Breve descripción F/H property k/a and being land to the south east of wharf road pinxton t/no:- DY127424 and DY272694 fixed charge over all buildings and other structures fixed charge over any goodwill relating to the property fixed charge over all plant machinery and other chattels attached to the property floatining charge over all unattached plant machinery chattels goods present and future all rental sums and all insurances claims. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Debenture | Creado el 13 jul 1984 Entregado el 17 jul 1984 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company and/or morceau holdings PLC to the chargee on any account whatsoever. | |
Breve descripción (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0