CHAMPION PUBLICATIONS (HARROGATE) LIMITED
Visión general
Nombre de la empresa | CHAMPION PUBLICATIONS (HARROGATE) LIMITED |
---|---|
Estado de la empresa | Disuelta |
Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
Número de empresa | 01157888 |
Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
Fecha de constitución | |
Fecha de cese |
Resumen
Tiene PSCs súper seguros | No |
---|---|
Tiene gravámenes | Sí |
Tiene historial de insolvencia | No |
La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de CHAMPION PUBLICATIONS (HARROGATE) LIMITED?
- Edición de periódicos (58130) / Información y comunicación
¿Dónde se encuentra CHAMPION PUBLICATIONS (HARROGATE) LIMITED?
Dirección de la sede social | 26 Whitehall Road LS12 1BE Leeds |
---|---|
Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles son las últimas cuentas de CHAMPION PUBLICATIONS (HARROGATE) LIMITED?
Últimas cuentas | |
---|---|
Últimas cuentas cerradas hasta | 28 dic 2013 |
¿Cuál es el estado de la última declaración anual para CHAMPION PUBLICATIONS (HARROGATE) LIMITED?
Declaración anual |
|
---|
¿Cuáles son las últimas presentaciones para CHAMPION PUBLICATIONS (HARROGATE) LIMITED?
Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 3 páginas | DS01 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 04 may 2015 avec liste complète des actionnaires | 6 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 28 dic 2013 | 9 páginas | AA | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr David John King el 01 jul 2014 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cambio de datos del secretario Mr Peter Mccall el 01 jul 2014 | 1 páginas | CH03 | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr Ashley Gilroy Mark Highfield el 01 jul 2014 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 04 may 2014 avec liste complète des actionnaires | 6 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 29 dic 2012 | 9 páginas | AA | ||||||||||
Nombramiento de Mr David John King como director | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Grant Murray como director | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 04 may 2013 avec liste complète des actionnaires | 6 páginas | AR01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Ashley Gilroy Mark Highfield como director | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Daniel Cammiade como director | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de * P O Box 168 Wellington Street Leeds West Yorkshire LS1 1RF* el 06 dic 2012 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2011 | 8 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 04 may 2012 avec liste complète des actionnaires | 6 páginas | AR01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de John Fry como director | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 01 ene 2011 | 8 páginas | AA | ||||||||||
Nombramiento de Mr Grant Murray como director | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 04 may 2011 avec liste complète des actionnaires | 6 páginas | AR01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Daniel Cammiade como director | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Stuart Paterson como director | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 04 may 2010 avec liste complète des actionnaires | 5 páginas | AR01 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de CHAMPION PUBLICATIONS (HARROGATE) LIMITED?
Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCCALL, Peter | Secretario | Orchard Brae House, 30 Queensferry Road EH4 2HS Edinburgh 8th Floor Scotland | 146720860001 | |||||||
HIGHFIELD, Ashley Gilroy Mark | Director | Orchard Brae House, 30 Queensferry Road EH4 2HS Edinburgh 8th Floor Scotland | United Kingdom | British | Chief Executive Officer | 164400440001 | ||||
KING, David John | Director | Orchard Brae House, 30 Queensferry Road EH4 2HS Edinburgh 8th Floor Scotland | United Kingdom | British | Chief Financial Officer | 179020430001 | ||||
ALLY, Bibi Rahima | Secretario | 60 Harbury Road SM5 4LA Carshalton Beeches Surrey | British | 38963210003 | ||||||
COOPER, Philip Richard | Secretario | Grange Knowe EH49 7HX Linlithgow 14 West Lothian United Kingdom | British | 131295290001 | ||||||
HILL, Robert Christopher | Secretario | 9 Kingsley Close Sandal WF2 7EB Wakefield West Yorkshire | British | Company Secretary | 72684940002 | |||||
MILNES, Ann | Secretario | 5 Dawsons Meadow Farsley LS28 5TU Pudsey West Yorkshire | British | Company Secretary | 59652640002 | |||||
YEOMANS, Graham Arthur | Secretario | 13 Beagle Ridge Drive Acomb YO2 3JH York North Yorkshire | British | 602760001 | ||||||
CROSSWALL NOMINEES LIMITED | Secretario corporativo | 245 Blackfriars Road SE1 9UY London Ludgate House | 992770004 | |||||||
AUCKLAND, Stephen Andrew | Director | The Croft 12 Town End Lane HD8 0NA Lepton Huddersfield | British | Company Director | 81185280001 | |||||
BARRETT, John Andrew | Director | 5 Westwood Road HU17 8EN Beverley North Humberside | British | Director | 9295350001 | |||||
BOWDLER, Timothy John | Director | 2-11 St Vincent Place EH3 5BQ Edinburgh | United Kingdom | British | Company Director | 37521870002 | ||||
CAMMIADE, Danny | Director | Holyrood Road EH8 8AS Edinburgh 108 Scotland | England | British | Chief Operating Officer | 251394160001 | ||||
FRY, John Anthony | Director | Church Hill NR15 1TD Saxlingham Nethergate Old Rectory Norfolk Uk | England | British | Chief Executive | 136914890001 | ||||
LAVERICK, Susan Christine | Director | Sycamore Cottage Park Lane, Emley HD8 9SS Huddersfield West Yorkshire | United Kingdom | British | Company Director | 99591930001 | ||||
LAWLER, Thomas Philip | Director | Glenlair Cottage 15 Nab Lane BD18 4EH Shipley West Yorkshire | British | Director | 7475760001 | |||||
MURRAY, Grant | Director | Holyrood Road EH8 8AS Edinburgh 108 Scotland | United Kingdom | British | Chief Financial Officer | 159877110001 | ||||
OAKLEY, Christopher John | Director | Random Wood Ling Lane, Scarcroft LS14 3HY Leeds West Yorkshire | British | Director | 68410390001 | |||||
PATERSON, Stuart Randall | Director | 41 Fernielaw Avenue EH13 0EF Edinburgh Midlothian | Scotland | British | Company Director | 64281400001 | ||||
PLEWS, Alan Stephen | Director | 44 Syke Green Scarcroft LS14 3BS Leeds Yorkshire | British | Company Director | 47442270001 | |||||
TOULMIN, George Michael | Director | The West Wing Thorp Arch Hall LS23 7AW Wetherby West Yorkshire | British | Director | 9253330001 |
¿Tiene CHAMPION PUBLICATIONS (HARROGATE) LIMITED alguna carga?
Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
---|---|---|---|---|
Supplemental debenture | Creado el 04 mar 1999 Entregado el 17 mar 1999 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due by the obligors (as defined) to the chargee under the finance documents (or any of them) (including under the debenture dated 27TH february 1998) (all as defined) on any account whatsoever | |
Breve descripción .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Debenture | Creado el 27 feb 1998 Entregado el 11 mar 1998 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due by the obligors (as defined) to the chargee under the finance documents (or any of them) (including under the debenture) (all as therein defined) on any account whatsoever | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Debenture | Creado el 22 sept 1982 Entregado el 29 sept 1982 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Fixed & floating charge on undertaking and all property and assets present and future including goodwill book uncalled capital & other debts. (See doc M13). | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Debenture | Creado el 22 sept 1982 Entregado el 06 oct 1982 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Specific equitable charge over all f/h & l/h properties and/or the proceeds of the sale thereof fixed & floating charge over: undertaking and all property and assets present and future goodwill & book debts including uncalled capital. (See doc M12). | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0