CHAMPION PUBLICATIONS (HARROGATE) LIMITED

CHAMPION PUBLICATIONS (HARROGATE) LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Cuentas
  • Declaración anual
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaCHAMPION PUBLICATIONS (HARROGATE) LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 01157888
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de CHAMPION PUBLICATIONS (HARROGATE) LIMITED?

    • Edición de periódicos (58130) / Información y comunicación

    ¿Dónde se encuentra CHAMPION PUBLICATIONS (HARROGATE) LIMITED?

    Dirección de la sede social
    26 Whitehall Road
    LS12 1BE Leeds
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de CHAMPION PUBLICATIONS (HARROGATE) LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta28 dic 2013

    ¿Cuál es el estado de la última declaración anual para CHAMPION PUBLICATIONS (HARROGATE) LIMITED?

    Declaración anual
    Última declaración anual

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para CHAMPION PUBLICATIONS (HARROGATE) LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Déclaration annuelle établie au 04 may 2015 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital11 may 2015

    Estado de capital el 11 may 2015

    • Capital: GBP 200
    SH01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 28 dic 2013

    9 páginasAA

    Cambio de datos del director Mr David John King el 01 jul 2014

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del secretario Mr Peter Mccall el 01 jul 2014

    1 páginasCH03

    Cambio de datos del director Mr Ashley Gilroy Mark Highfield el 01 jul 2014

    2 páginasCH01

    Déclaration annuelle établie au 04 may 2014 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital12 may 2014

    Estado de capital el 12 may 2014

    • Capital: GBP 200
    SH01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 29 dic 2012

    9 páginasAA

    Nombramiento de Mr David John King como director

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Grant Murray como director

    1 páginasTM01

    Déclaration annuelle établie au 04 may 2013 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01

    Nombramiento de Mr Ashley Gilroy Mark Highfield como director

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Daniel Cammiade como director

    1 páginasTM01

    Domicilio social registrado cambiado de * P O Box 168 Wellington Street Leeds West Yorkshire LS1 1RF* el 06 dic 2012

    1 páginasAD01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2011

    8 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 04 may 2012 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01

    Cese del nombramiento de John Fry como director

    1 páginasTM01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 01 ene 2011

    8 páginasAA

    Nombramiento de Mr Grant Murray como director

    2 páginasAP01

    Déclaration annuelle établie au 04 may 2011 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01

    Nombramiento de Mr Daniel Cammiade como director

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Stuart Paterson como director

    1 páginasTM01

    Déclaration annuelle établie au 04 may 2010 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01

    ¿Quiénes son los directivos de CHAMPION PUBLICATIONS (HARROGATE) LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    MCCALL, Peter
    Orchard Brae House, 30 Queensferry Road
    EH4 2HS Edinburgh
    8th Floor
    Scotland
    Secretario
    Orchard Brae House, 30 Queensferry Road
    EH4 2HS Edinburgh
    8th Floor
    Scotland
    146720860001
    HIGHFIELD, Ashley Gilroy Mark
    Orchard Brae House, 30 Queensferry Road
    EH4 2HS Edinburgh
    8th Floor
    Scotland
    Director
    Orchard Brae House, 30 Queensferry Road
    EH4 2HS Edinburgh
    8th Floor
    Scotland
    United KingdomBritishChief Executive Officer164400440001
    KING, David John
    Orchard Brae House, 30 Queensferry Road
    EH4 2HS Edinburgh
    8th Floor
    Scotland
    Director
    Orchard Brae House, 30 Queensferry Road
    EH4 2HS Edinburgh
    8th Floor
    Scotland
    United KingdomBritishChief Financial Officer179020430001
    ALLY, Bibi Rahima
    60 Harbury Road
    SM5 4LA Carshalton Beeches
    Surrey
    Secretario
    60 Harbury Road
    SM5 4LA Carshalton Beeches
    Surrey
    British38963210003
    COOPER, Philip Richard
    Grange Knowe
    EH49 7HX Linlithgow
    14
    West Lothian
    United Kingdom
    Secretario
    Grange Knowe
    EH49 7HX Linlithgow
    14
    West Lothian
    United Kingdom
    British131295290001
    HILL, Robert Christopher
    9 Kingsley Close
    Sandal
    WF2 7EB Wakefield
    West Yorkshire
    Secretario
    9 Kingsley Close
    Sandal
    WF2 7EB Wakefield
    West Yorkshire
    BritishCompany Secretary72684940002
    MILNES, Ann
    5 Dawsons Meadow
    Farsley
    LS28 5TU Pudsey
    West Yorkshire
    Secretario
    5 Dawsons Meadow
    Farsley
    LS28 5TU Pudsey
    West Yorkshire
    BritishCompany Secretary59652640002
    YEOMANS, Graham Arthur
    13 Beagle Ridge Drive
    Acomb
    YO2 3JH York
    North Yorkshire
    Secretario
    13 Beagle Ridge Drive
    Acomb
    YO2 3JH York
    North Yorkshire
    British602760001
    CROSSWALL NOMINEES LIMITED
    245 Blackfriars Road
    SE1 9UY London
    Ludgate House
    Secretario corporativo
    245 Blackfriars Road
    SE1 9UY London
    Ludgate House
    992770004
    AUCKLAND, Stephen Andrew
    The Croft 12 Town End Lane
    HD8 0NA Lepton
    Huddersfield
    Director
    The Croft 12 Town End Lane
    HD8 0NA Lepton
    Huddersfield
    BritishCompany Director81185280001
    BARRETT, John Andrew
    5 Westwood Road
    HU17 8EN Beverley
    North Humberside
    Director
    5 Westwood Road
    HU17 8EN Beverley
    North Humberside
    BritishDirector9295350001
    BOWDLER, Timothy John
    2-11 St Vincent Place
    EH3 5BQ Edinburgh
    Director
    2-11 St Vincent Place
    EH3 5BQ Edinburgh
    United KingdomBritishCompany Director37521870002
    CAMMIADE, Danny
    Holyrood Road
    EH8 8AS Edinburgh
    108
    Scotland
    Director
    Holyrood Road
    EH8 8AS Edinburgh
    108
    Scotland
    EnglandBritishChief Operating Officer251394160001
    FRY, John Anthony
    Church Hill
    NR15 1TD Saxlingham Nethergate
    Old Rectory
    Norfolk
    Uk
    Director
    Church Hill
    NR15 1TD Saxlingham Nethergate
    Old Rectory
    Norfolk
    Uk
    EnglandBritishChief Executive136914890001
    LAVERICK, Susan Christine
    Sycamore Cottage
    Park Lane, Emley
    HD8 9SS Huddersfield
    West Yorkshire
    Director
    Sycamore Cottage
    Park Lane, Emley
    HD8 9SS Huddersfield
    West Yorkshire
    United KingdomBritishCompany Director99591930001
    LAWLER, Thomas Philip
    Glenlair Cottage 15 Nab Lane
    BD18 4EH Shipley
    West Yorkshire
    Director
    Glenlair Cottage 15 Nab Lane
    BD18 4EH Shipley
    West Yorkshire
    BritishDirector7475760001
    MURRAY, Grant
    Holyrood Road
    EH8 8AS Edinburgh
    108
    Scotland
    Director
    Holyrood Road
    EH8 8AS Edinburgh
    108
    Scotland
    United KingdomBritishChief Financial Officer159877110001
    OAKLEY, Christopher John
    Random Wood
    Ling Lane, Scarcroft
    LS14 3HY Leeds
    West Yorkshire
    Director
    Random Wood
    Ling Lane, Scarcroft
    LS14 3HY Leeds
    West Yorkshire
    BritishDirector68410390001
    PATERSON, Stuart Randall
    41 Fernielaw Avenue
    EH13 0EF Edinburgh
    Midlothian
    Director
    41 Fernielaw Avenue
    EH13 0EF Edinburgh
    Midlothian
    ScotlandBritishCompany Director64281400001
    PLEWS, Alan Stephen
    44 Syke Green
    Scarcroft
    LS14 3BS Leeds
    Yorkshire
    Director
    44 Syke Green
    Scarcroft
    LS14 3BS Leeds
    Yorkshire
    BritishCompany Director47442270001
    TOULMIN, George Michael
    The West Wing
    Thorp Arch Hall
    LS23 7AW Wetherby
    West Yorkshire
    Director
    The West Wing
    Thorp Arch Hall
    LS23 7AW Wetherby
    West Yorkshire
    BritishDirector9253330001

    ¿Tiene CHAMPION PUBLICATIONS (HARROGATE) LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Supplemental debenture
    Creado el 04 mar 1999
    Entregado el 17 mar 1999
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due by the obligors (as defined) to the chargee under the finance documents (or any of them) (including under the debenture dated 27TH february 1998) (all as defined) on any account whatsoever
    Breve descripción
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Lloyds Bank PLC Capital Markets(As Security Agent for the Secured Parties)
    Transacciones
    • 17 mar 1999Registro de un cargo (395)
    • 09 may 2002Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 27 feb 1998
    Entregado el 11 mar 1998
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due by the obligors (as defined) to the chargee under the finance documents (or any of them) (including under the debenture) (all as therein defined) on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Goldman Sachs International (As Security Agent for the Secured Parties)
    Transacciones
    • 11 mar 1998Registro de un cargo (395)
    • 09 may 2002Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 22 sept 1982
    Entregado el 29 sept 1982
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed & floating charge on undertaking and all property and assets present and future including goodwill book uncalled capital & other debts. (See doc M13).
    Personas con derecho
    • Citicorp International Bank Limited
    Transacciones
    • 29 sept 1982Registro de una carga
    Debenture
    Creado el 22 sept 1982
    Entregado el 06 oct 1982
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Specific equitable charge over all f/h & l/h properties and/or the proceeds of the sale thereof fixed & floating charge over: undertaking and all property and assets present and future goodwill & book debts including uncalled capital. (See doc M12).
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 06 oct 1982Registro de una carga

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0