ALBANY LIFE ASSURANCE COMPANY LIMITED

ALBANY LIFE ASSURANCE COMPANY LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaALBANY LIFE ASSURANCE COMPANY LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 01164317
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de ALBANY LIFE ASSURANCE COMPANY LIMITED?

    • Seguros de vida (65110) / Actividades financieras y de seguros

    ¿Dónde se encuentra ALBANY LIFE ASSURANCE COMPANY LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Canada Life Place
    Potters Bar
    EN6 5BA Hertfordshire
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de ALBANY LIFE ASSURANCE COMPANY LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2019

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para ALBANY LIFE ASSURANCE COMPANY LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Cese del nombramiento de Kathryn Louise Bateman como director el 29 abr 2022

    1 páginasTM01

    La acción de exclusión voluntaria ha sido suspendida

    1 páginasSOAS(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    1 páginasDS01

    Declaración de confirmación presentada el 07 sept 2021 con actualizaciones

    4 páginasCS01

    Cessation de Canada Life (U.K.) Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 03 sept 2021

    1 páginasPSC07

    Notification de Clfis (U.K.) Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 03 sept 2021

    2 páginasPSC02

    Declaración de confirmación presentada el 01 jul 2021 con actualizaciones

    4 páginasCS01

    Cese del nombramiento de Douglas Allan Brown como director el 18 dic 2020

    1 páginasTM01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2019

    8 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 01 jul 2020 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2018

    9 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 01 jul 2019 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Nombramiento de Mr Ashleigh Martin Kewney como director el 05 feb 2019

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Harold Charles Snow como director el 01 feb 2019

    1 páginasTM01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2017

    9 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 01 jul 2018 con actualizaciones

    4 páginasCS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2016

    9 páginasAA

    Notification de Canada Life (U.K.) Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 06 abr 2016

    2 páginasPSC02

    Declaración de confirmación presentada el 01 jul 2017 con actualizaciones

    4 páginasCS01

    Nombramiento de Mrs Kathryn Louise Bateman como director el 26 jul 2016

    2 páginasAP01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2015

    9 páginasAA

    Cancelación total de la carga 3

    1 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 4

    1 páginasMR04

    ¿Quiénes son los directivos de ALBANY LIFE ASSURANCE COMPANY LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    KEWNEY, Ashleigh Martin
    Canada Life Place
    Potters Bar
    EN6 5BA Hertfordshire
    Director
    Canada Life Place
    Potters Bar
    EN6 5BA Hertfordshire
    EnglandBritish110858490001
    CRANSTON, Kareen
    2 Mount Pleasant
    AL3 4QJ St. Albans
    Hertfordshire
    Secretario
    2 Mount Pleasant
    AL3 4QJ St. Albans
    Hertfordshire
    British69895760003
    ELLIS, Lindsay
    35b Piggottshill Lane
    AL5 1LR Harpenden
    Hertfordshire
    Secretario
    35b Piggottshill Lane
    AL5 1LR Harpenden
    Hertfordshire
    British57723320001
    GEIRINGER, Bruno Marcel David
    83 Westbury Road
    KT3 5AL New Malden
    Surrey
    Secretario
    83 Westbury Road
    KT3 5AL New Malden
    Surrey
    British35563990001
    GEIRINGER, Bruno Marcel David
    83 Westbury Road
    KT3 5AL New Malden
    Surrey
    Secretario
    83 Westbury Road
    KT3 5AL New Malden
    Surrey
    British35563990001
    MUIR, Christopher William
    150 De Beauvoir Road
    N1 4DJ London
    Secretario
    150 De Beauvoir Road
    N1 4DJ London
    British89033740001
    REEVE, Andrew Howard
    7 Greenhills
    SG12 0XG Ware
    Hertfordshire
    Secretario
    7 Greenhills
    SG12 0XG Ware
    Hertfordshire
    British10571570001
    TEMPLE, John Nicholas
    Windfalls Highfield Road
    West Moors
    BH22 0NA Ferndown
    Dorset
    Secretario
    Windfalls Highfield Road
    West Moors
    BH22 0NA Ferndown
    Dorset
    British84493950001
    WISEMAN, Robin Harold
    Carlton Cottage
    Fulling Mill Lane
    AL6 9NS Welwyn
    Hertfordshire
    Secretario
    Carlton Cottage
    Fulling Mill Lane
    AL6 9NS Welwyn
    Hertfordshire
    British12789370001
    ABERDARE, Morys George Lyndhurst, The Rt Hon Lord
    32 Elthiron Road
    SW6 4BN London
    Director
    32 Elthiron Road
    SW6 4BN London
    British45953780001
    ATHANASSIADES, Theodossios
    4436 Province Line Road
    FOREIGN Princeton
    New Jersey 08540
    Usa
    Director
    4436 Province Line Road
    FOREIGN Princeton
    New Jersey 08540
    Usa
    American4378020001
    BATEMAN, Kathryn Louise
    Canada Life Place
    Potters Bar
    EN6 5BA Hertfordshire
    Director
    Canada Life Place
    Potters Bar
    EN6 5BA Hertfordshire
    United KingdomBritish211153360001
    BELLRINGER, Charles Albert John
    Itchingwood Common
    RS8 0RL Limpsfield
    Tenchleys Manor
    Surrey
    Director
    Itchingwood Common
    RS8 0RL Limpsfield
    Tenchleys Manor
    Surrey
    United KingdomBritish132720300001
    BLACKWELL, Richard Manning
    267 Holly Hill
    07092 Mountainside
    New Jersey
    Usa
    Director
    267 Holly Hill
    07092 Mountainside
    New Jersey
    Usa
    Usa33587810001
    BROWN, Douglas Allan
    High Street
    EN6 5BA Potters Bar
    Canada Life Place
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Director
    High Street
    EN6 5BA Potters Bar
    Canada Life Place
    Hertfordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish172793780002
    BRUNINI, Alexander Deene
    126 East 16th Street
    NY10003 New York
    Usa
    Director
    126 East 16th Street
    NY10003 New York
    Usa
    Usa26371140003
    CHAPPEL JNR, Robert Earl
    70 Glen Ridge Parkway
    Glen Ridge
    New Jersey 07028
    Usa
    Director
    70 Glen Ridge Parkway
    Glen Ridge
    New Jersey 07028
    Usa
    American30869380001
    CLARK, Gerald
    2 Harwood Drive
    Madison New Jersey 07940
    United States Of America
    Director
    2 Harwood Drive
    Madison New Jersey 07940
    United States Of America
    American44616590001
    DEAN, Derek James
    Gable House Stock Road
    Stock
    CM4 9PH Ingatestone
    Essex
    Director
    Gable House Stock Road
    Stock
    CM4 9PH Ingatestone
    Essex
    British14651800001
    FLEMING, Richard Stephen
    40 Broadwalk
    Winchmore Hill
    N21 3BY London
    Director
    40 Broadwalk
    Winchmore Hill
    N21 3BY London
    American45207950001
    GILLESPIE, John Francis
    12 Westcott
    AL7 2PP Welwyn Garden City
    Hertfordshire
    Director
    12 Westcott
    AL7 2PP Welwyn Garden City
    Hertfordshire
    Irish26253320001
    GILMOUR, Ian
    Canada Life Place
    Potters Bar
    EN6 5BA Hertfordshire
    Director
    Canada Life Place
    Potters Bar
    EN6 5BA Hertfordshire
    United KingdomBritish55683610001
    GLOVER, Neil Jonathan
    Canada Life Place
    Potters Bar
    EN6 5BA Hertfordshire
    Director
    Canada Life Place
    Potters Bar
    EN6 5BA Hertfordshire
    United KingdomBritish180441810001
    HARWOOD, Judith Margaret
    40 Kidbrooke Gardens
    Blackheath
    SE3 0PD London
    Director
    40 Kidbrooke Gardens
    Blackheath
    SE3 0PD London
    British73873830002
    KERR, Malcolm James Bowes
    15 Chiswick Quay
    W4 3UR London
    Director
    15 Chiswick Quay
    W4 3UR London
    United KingdomBritish3574930001
    MCEGAN, Michael Paul
    Woodlands East Common
    AL5 1DG Harpenden
    Hertfordshire
    Director
    Woodlands East Common
    AL5 1DG Harpenden
    Hertfordshire
    British50082050002
    MCLEOD, Charles
    Flat B 17 Crescent East
    Hadley Wood
    EN4 0EY Barnet
    Hertfordshire
    Director
    Flat B 17 Crescent East
    Hadley Wood
    EN4 0EY Barnet
    Hertfordshire
    British53804380001
    MERRY, Ernest George Thomas
    Greyfield Farm
    High Littleton
    BS18 5YQ Bristol
    Avon
    Director
    Greyfield Farm
    High Littleton
    BS18 5YQ Bristol
    Avon
    British14651820001
    MEYERS, Steven Donald
    3 Goodyers Gardens
    Hendon
    NW4 2HD London
    Director
    3 Goodyers Gardens
    Hendon
    NW4 2HD London
    Usa57361080001
    MYNOTT, David
    22 Shephall Green
    SG2 9XS Stevenage
    Hertfordshire
    Director
    22 Shephall Green
    SG2 9XS Stevenage
    Hertfordshire
    British30749350001
    POORTVILET, William George
    420 East 23rd Street
    FOREIGN New York Ny 10010
    Usa
    Director
    420 East 23rd Street
    FOREIGN New York Ny 10010
    Usa
    American14651830001
    PRUETER, William Robert
    17 Norrice Lea
    Hampstead Garden Suburb
    N2 0RD London
    Director
    17 Norrice Lea
    Hampstead Garden Suburb
    N2 0RD London
    Canadian37536850002
    RICHARDS, William Jeffrey
    2 Sacombe Mews
    SG2 8SB Stevenage
    Hertfordshire
    Director
    2 Sacombe Mews
    SG2 8SB Stevenage
    Hertfordshire
    British4929350002
    RITCHIE, Robert John
    Lombard Street
    EC3V 9JU London
    1-6
    United Kingdom
    Director
    Lombard Street
    EC3V 9JU London
    1-6
    United Kingdom
    United KingdomCanadian131881720002
    RYAN, Mark Hopkins
    4 Queensmead
    St Johns Wood Park St Johns Wood
    NW8 6RE London
    Director
    4 Queensmead
    St Johns Wood Park St Johns Wood
    NW8 6RE London
    American50062370001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de ALBANY LIFE ASSURANCE COMPANY LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    High Street
    EN6 5BA Potters Bar
    Canada Life Place
    England
    03 sept 2021
    High Street
    EN6 5BA Potters Bar
    Canada Life Place
    England
    No
    Forma jurídicaPrivate Limited Company
    País de registroEngland
    Autoridad legalCompanies Act 2006
    Lugar de registroCompanies House
    Número de registro04356028
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.
    • La persona tiene el derecho, directa o indirectamente, de nombrar o destituir a la mayoría de la junta directiva de la empresa.
    Canada Life (U.K.) Limited
    High Street
    EN6 5BA Potters Bar
    Canada Life Place
    Hertfordshire
    England
    06 abr 2016
    High Street
    EN6 5BA Potters Bar
    Canada Life Place
    Hertfordshire
    England
    Forma jurídicaPrivate Limited Company
    País de registroUnited Kingdom
    Autoridad legalCompanies Act 2006
    Lugar de registroCompanies House Register (England & Wales)
    Número de registro01165737
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.
    • La persona tiene el derecho, directa o indirectamente, de nombrar o destituir a la mayoría de la junta directiva de la empresa.

    ¿Tiene ALBANY LIFE ASSURANCE COMPANY LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Rent free period security deed
    Creado el 16 ago 1996
    Entregado el 04 sept 1996
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £49,669.00 due or to become due from the company to the chargee
    Breve descripción
    The deposited sum of £49,669.00.
    Personas con derecho
    • Hammond & Champness Limited
    Transacciones
    • 04 sept 1996Registro de un cargo (395)
    • 25 jul 2016Satisfacción de una carga (MR04)
    Rent free period security deed
    Creado el 16 ago 1996
    Entregado el 04 sept 1996
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £43,647.00 due or to become due from the company to the chargee
    Breve descripción
    The deposited sum of £43,647.00.
    Personas con derecho
    • Hammond & Champness Limited
    Transacciones
    • 04 sept 1996Registro de un cargo (395)
    • 25 jul 2016Satisfacción de una carga (MR04)
    Legal mortgage
    Creado el 12 ago 1991
    Entregado el 19 ago 1991
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    5 victoria road gorleston gt yarmouth norfolk tn:- nk 63888 assigns goodwill (if any). Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personas con derecho
    • Lloyds Bank PLC
    Transacciones
    • 19 ago 1991Registro de una carga
    Legal charge
    Creado el 09 abr 1991
    Entregado el 18 abr 1991
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a facility agreement dated 30/9/87
    Breve descripción
    All right, title & interest under any optson, lease agreement for tenanly or licence to occupy the property.
    Personas con derecho
    • Amsterdam Rottbrdam Bank N.V.
    Transacciones
    • 18 abr 1991Registro de una carga
    • 07 mar 1996Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Sub-mortgage
    Creado el 05 abr 1991
    Entregado el 11 abr 1991
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Breve descripción
    The mortgage dated 6/9/90 over all that f/h land at nidd hall ripley nr harrogate nth yorks and all principal interest & other money now and on the future secured by the mortgage.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 11 abr 1991Registro de una carga
    • 07 mar 1996Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 12 mar 1991
    Entregado el 14 mar 1991
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Breve descripción
    All that l/hold ground floor shop k/a unit 3 110 hutton road sherfield brentwood essex t/no:- ex 394153 fixed charge over all plant machnery implements utensils furniture and equipment.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 14 mar 1991Registro de una carga
    • 07 mar 1996Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 12 mar 1991
    Entregado el 14 mar 1991
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Breve descripción
    All that l/hold ground floor shop k/a unit 1 106 hutton road, shenfield brentwood essex t/no ex 319580 fixed charge over all plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 14 mar 1991Registro de una carga
    • 07 mar 1996Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 12 mar 1991
    Entregado el 14 mar 1991
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Breve descripción
    All those l/hold first floor offices of teh property k/a 104-110 (even nos only) hutton road sherfield brentwood essex t/no:- ex 277562 fixed charge over all plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC.
    Transacciones
    • 14 mar 1991Registro de una carga
    • 07 mar 1996Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 12 mar 1991
    Entregado el 14 mar 1991
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Breve descripción
    All that l/hold ground floor shop k/a unit 2 108 hutton road sherfield brentwood essex t/no ex O63057 fixed charge over all plant machinery implements utensils furniture and euipment.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 14 mar 1991Registro de una carga
    • 07 mar 1996Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 12 mar 1991
    Entregado el 14 mar 1991
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Breve descripción
    All those l/hold second floor offices of the property k/a 104-110 (even nos only) hutton road suerfield brentwood essex t/no ex 294270. fixed charge over all plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 14 mar 1991Registro de una carga
    • 07 mar 1996Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Stardard security
    Creado el 04 feb 1991
    Entregado el 08 feb 1991
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under th terms of a personal bond dated 10/12/90
    Breve descripción
    Those office premises consisting of ten rooms on the 6TH floor 14 mitchell lane glasgow.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC.
    Transacciones
    • 08 feb 1991Registro de una carga
    • 07 mar 1996Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Sub-mortgage
    Creado el 09 ene 1991
    Entregado el 16 ene 1991
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Breve descripción
    The mortgage dated 16-11-90 over all that f/hold land & buildings k/a unit j dunkeswell airfield dunkeswell honiton east devon devon & all fixtures fittings plant & machinery.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 16 ene 1991Registro de una carga
    • 07 mar 1996Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Sub-mortgage
    Creado el 13 dic 1990
    Entregado el 19 dic 1990
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    A mortgage dated 7/11/90 over f/h gomersal park hotel gormersal cleckheaton kirklees t/n wyk 459019.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 19 dic 1990Registro de una carga
    • 07 mar 1996Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Sub-mortgage
    Creado el 10 dic 1990
    Entregado el 18 dic 1990
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    A mortgage dated 20/9/90 over f/h the feathers public house feathers lane hythe and wooysbury buckinghamshire t/n bm 41485.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 18 dic 1990Registro de una carga
    • 07 mar 1996Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Sub-mortgage
    Creado el 10 dic 1990
    Entregado el 18 dic 1990
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    A mortgage dated 9/11/90 over l/h land & buildings on north east side of west bawtry road rotherham t/n syk 270398.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 18 dic 1990Registro de una carga
    • 07 mar 1996Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Sub-mortgage
    Creado el 25 oct 1990
    Entregado el 31 oct 1990
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Breve descripción
    L/H roseberry avenue tottenham. L/b maringey and 17 wadsworth road perivale l/b ealing. T/no mx 87593.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 31 oct 1990Registro de una carga
    • 07 mar 1996Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Sub-mortgage
    Creado el 17 oct 1990
    Entregado el 23 oct 1990
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Breve descripción
    The mortgage dated 19/9/90 over all that f/n land & buildings lying to the north west of cowlersley lane lintnwaite huddesfield kirkless west yorks k/a grove garage hazel grove linthwaite t/no wyk 151961.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC.
    Transacciones
    • 23 oct 1990Registro de una carga
    • 07 mar 1996Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Sub-mortgage
    Creado el 15 oct 1990
    Entregado el 23 oct 1990
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Breve descripción
    The mortgage dated 31/8/90 over all that f/hold lane & buildigns k/a unit 4 metro centre tolpits lane watford three rivers herts & all fixtures fittings plant & machinery.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 23 oct 1990Registro de una carga
    • 07 mar 1996Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Sub-mortgage
    Creado el 11 oct 1990
    Entregado el 13 oct 1990
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a mortgage of even date
    Breve descripción
    Teh gatwick wana hotel (formerly russ hill hotel, the lodge laurel wreatn and land on the south side of russ hill) charlwood surrey.
    Personas con derecho
    • Charlerhouse Bank Limited.
    Transacciones
    • 13 oct 1990Registro de una carga
    • 07 mar 1996Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Sub-mortgage
    Creado el 14 sept 1990
    Entregado el 20 sept 1990
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge.
    Breve descripción
    Mortgage dated 18 july 1990 granted by mackerzie tools and productions LTD to the co. Over all f/h land and buildings on the north side of anthony road, saltley, birmingham, W. midlands t/no. Wk 15959. see form 395 ref. 174C for further details.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 20 sept 1990Registro de una carga
    • 07 mar 1996Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 28 ago 1990
    Entregado el 05 sept 1990
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Breve descripción
    The mortgage dated 10/8/90 granted by berwick limited to the company over all that f/h land & buildings 16-18 anne road smithwick sandwell west midlands t/no wm 95557 & all fixtures fittings plant & machinery.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 05 sept 1990Registro de una carga
    • 07 mar 1996Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creado el 23 ago 1990
    Entregado el 31 ago 1990
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Breve descripción
    The mortgage dated 15/8/90 granted by farcrown properties limited to the company over firstly all that f/h land & property at caroline street birmingham west midlands secondly all that l/n land & property at caroline street aforesaid.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 31 ago 1990Registro de una carga
    • 07 mar 1996Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Sub-mortgage
    Creado el 10 ago 1990
    Entregado el 17 ago 1990
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    The mortgage dated 26/7/90 granted by relcy properties limited to the company over all that f/h land and buildigns k/a 12 greenwich street and 9 turnpin lane, greenwich london and 14 and 23 and 25 greenwich church street t/no's ln 143130 266572, sgl 212118 and sgl 205191 (please see doc 395/ m/ 54/c/ 20/8 for complete details).
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 17 ago 1990Registro de una carga
    • 07 mar 1996Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Sub-mortgage
    Creado el 31 jul 1990
    Entregado el 09 ago 1990
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the chargee
    Breve descripción
    Mortgage dated, 12.7.90 granted by elite up holstery manufacturing company over all f/h land and buildings an the W. side of rothwell road desborough kettering northants t/no:- nn 109365. (please see odc 395/m/89/C0 10/8 for full details).
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC.
    Transacciones
    • 09 ago 1990Registro de una carga
    • 07 mar 1996Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Sub-mortgage
    Creado el 12 jul 1990
    Entregado el 18 jul 1990
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Breve descripción
    The mortgage dated 12/7/90 granted by cute upholstery manufacturing company limited over all that f/h land & buildings on the west side of rothwell road desborough kettring northamptonshire t/no nn 109365.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 18 jul 1990Registro de una carga
    • 07 mar 1996Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0