IMPACT MARCOM LTD
Visión general
| Nombre de la empresa | IMPACT MARCOM LTD |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 01166286 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | Sí |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de IMPACT MARCOM LTD?
- Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.p. (74909) / Actividades profesionales, científicas y técnicas
¿Dónde se encuentra IMPACT MARCOM LTD?
| Dirección de la sede social | 55 Baker Street W1U 7EU London |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de IMPACT MARCOM LTD?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| MAR-COM SYSTEMS LIMITED | 03 may 1985 | 03 may 1985 |
| VISUAL MAR-COM SYSTEMS LIMITED | 31 dic 1976 | 31 dic 1976 |
| COPYWRITE METHODS LIMITED | 09 abr 1974 | 09 abr 1974 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de IMPACT MARCOM LTD?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 30 jun 2017 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para IMPACT MARCOM LTD?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gaceta final disuelta tras la liquidación | 1 páginas | GAZ2 | ||||||||||
Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 02 may 2019 | 11 páginas | LIQ03 | ||||||||||
Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros | 11 páginas | LIQ13 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de Europe House 170 Windmill Road West Sunbury on Thames Middlesex TW16 7HB a 55 Baker Street London W1U 7EU el 22 ago 2018 | 2 páginas | AD01 | ||||||||||
Declaración de solvencia | 5 páginas | LIQ01 | ||||||||||
Nombramiento de un liquidador voluntario | 3 páginas | 600 | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
legacy | 1 páginas | SH20 | ||||||||||
Estado de capital el 25 jun 2018
| 5 páginas | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 páginas | CAP-SS | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Cancelación total de la carga 7 | 1 páginas | MR04 | ||||||||||
Cancelación total de la carga 011662860009 | 1 páginas | MR04 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 30 jun 2017 | 21 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 03 sept 2017 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 30 jun 2016 | 21 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 03 sept 2016 con actualizaciones | 5 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 30 jun 2015 | 18 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 03 sept 2015 avec liste complète des actionnaires | 3 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Resoluciones Resolutions | RESOLUTIONS | |||||||||||
| ||||||||||||
Registro de la carga 011662860009, creada el 24 mar 2015 | 55 páginas | MR01 | ||||||||||
Cancelación total de la carga 8 | 1 páginas | MR04 | ||||||||||
Cancelación total de la carga 5 | 1 páginas | MR04 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 30 jun 2014 | 20 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 03 sept 2014 avec liste complète des actionnaires | 3 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
¿Quiénes son los directivos de IMPACT MARCOM LTD?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALLEN, John | Director | Baker Street W1U 7EU London 55 | England | British | 182527790001 | |||||
| COOK, Edward Charles Peregrine Phelps | Director | Baker Street W1U 7EU London 55 | England | British | 52906920005 | |||||
| KENNEDY, Ewan Campbell | Secretario | Flat 11 Crawley Rise 18 Portsmouth Road GU15 1JX Camberley Surrey | British | 33639840003 | ||||||
| PORTER, Simon Neil | Secretario | Europe House 170 Windmill Road West TW16 7HB Sunbury On Thames Middlesex | British | 174403180001 | ||||||
| SEYMOUR, Barry James | Secretario | 9 Fort Street GU1 3TB Guildford Surrey | British | 1306660001 | ||||||
| STEWARD, Charles David | Secretario | 17 Windrush Close Bramley GU5 0BB Guildford Surrey | British | 103109350002 | ||||||
| ALLIN, John Leslie | Director | 5 Elmbrook Vale RG11 Wokingham Berkshire | British | 16272300001 | ||||||
| AZAM, Mohammed | Director | Jenner Way KT19 7LJ Epsom 3 Surrey United Kingdom | England | British | 135689290001 | |||||
| BRAY, Myles Edward James | Director | Woodmancott SO21 3BN Winchester Woodmancott House Hampshire United Kingdom | England | British | 135690640001 | |||||
| CAUSEVIC, Fredd | Director | Bekkestua 9a Bekkestua N-1357 Norway | Norway | Norwegian | 75177110001 | |||||
| DEMPSTER, Brian Leigh Harding | Director | 14 Nutfield Gardens UB5 6LT Northolt Middlesex | British | 16272310001 | ||||||
| ELLIS, Kenneth Leonard | Director | Europe House 170 Windmill Road West TW16 7HB Sunbury On Thames Middlesex | England | British | 149204440001 | |||||
| GORTON, Robert David | Director | 55 Redhill Wood New Ash Green DA3 8QP Longfield Kent | England | British | 28341780002 | |||||
| HUDSON, Mark Alan | Director | Crawshay Drive Emmer Green RG4 8SY Reading 58 England | England | British | 180576890001 | |||||
| JEWITT, Anthony John | Director | 13 Pelling Hill Old Windsor SL4 2LL Windsor Berkshire | British | 785310001 | ||||||
| KENNEDY, Ewan Campbell | Director | Braybourne House Crawley Ridge GU15 2AD Camberley Surrey | British | 33639840004 | ||||||
| MORAN, Michael Owen | Director | Australind The Street West Clandon GU4 7TE Guildford Surrey | British | 1306650001 | ||||||
| PHILLIPS, Julian Brian | Director | Oakwood 15 Oxted Green, Milford GU8 5D Godalming Surrey | England | British | 122795570002 | |||||
| PORTER, Simon Neil | Director | Europe House 170 Windmill Road West TW16 7HB Sunbury On Thames Middlesex | England | United Kingdom | 55262300006 | |||||
| RAWLINGS, Timothy Paul | Director | 11 Lulworth Road DA16 3LQ Welling Kent | British | 20665210002 | ||||||
| ROBINSON, Mark Laurence | Director | 43 Worminghall Road Ickford HP18 9JB Aylesbury Buckinghamshire | England | British | 43184090002 | |||||
| SEYMOUR, Barry James | Director | 9 Fort Street GU1 3TB Guildford Surrey | England | British | 1306660001 | |||||
| SMITH, John | Director | Allenwood 161 London Road CM7 8PT Braintree Essex | British | 66391760001 | ||||||
| STEWARD, Charles David | Director | 17 Windrush Close Bramley GU5 0BB Guildford Surrey | United Kingdom | British | 103109350002 | |||||
| TITLER, Alec | Director | 11 Greenways Malt Hill TW20 9PA Egham Surrey | England | British | 48506930001 | |||||
| TITLER, Alec | Director | 11 Greenways Malt Hill TW20 9PA Egham Surrey | England | British | 48506930001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de IMPACT MARCOM LTD?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avm Impact Ltd | 06 abr 2016 | 170 Windmill Road West TW16 7HB Sunbury-On-Thames Europe House Middlesex England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
¿Tiene IMPACT MARCOM LTD alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Creado el 24 mar 2015 Entregado el 28 mar 2015 | Satisfecho en su totalidad | ||
La garantía flotante cubre todo: Sí Contiene una promesa negativa: Sí Contiene una garantía flotante: Sí Contiene una garantía fija: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| A supplemental deed to a debenture | Creado el 03 dic 2012 Entregado el 10 dic 2012 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from each obligor (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Debenture | Creado el 03 dic 2012 Entregado el 08 dic 2012 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Debenture | Creado el 22 abr 2010 Entregado el 11 may 2010 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Fixed & floating charge | Creado el 03 mar 2008 Entregado el 08 mar 2008 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Debenture | Creado el 14 ago 2007 Entregado el 24 ago 2007 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Mortgage pursuant to an order of court dated 16/7/91 | Creado el 26 sept 1990 Entregado el 18 jul 1991 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Unit 12 capitol park pearce way gloucester. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Guarantee & debenture | Creado el 06 oct 1981 Entregado el 12 oct 1981 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Fixed & floating charge over undertaking and all property and assets present and future including goodwill, book detbs uncalled captial, buildings, fixtures, fixed plant and machinery. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Debenture | Creado el 02 jun 1980 Entregado el 09 jun 1980 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Fixed and floating charge over undertaking and all property and assets present and future including goodwill, book debts uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant and machinery. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
¿Tiene IMPACT MARCOM LTD algún caso de insolvencia?
| Número de expediente | Fechas | Tipo | Profesionales | Otro | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Liquidación voluntaria de socios |
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0