IMPACT MARCOM LTD

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaIMPACT MARCOM LTD
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 01166286
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de IMPACT MARCOM LTD?

    • Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.p. (74909) / Actividades profesionales, científicas y técnicas

    ¿Dónde se encuentra IMPACT MARCOM LTD?

    Dirección de la sede social
    55 Baker Street
    W1U 7EU London
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de IMPACT MARCOM LTD?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    MAR-COM SYSTEMS LIMITED03 may 198503 may 1985
    VISUAL MAR-COM SYSTEMS LIMITED31 dic 197631 dic 1976
    COPYWRITE METHODS LIMITED09 abr 197409 abr 1974

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de IMPACT MARCOM LTD?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta30 jun 2017

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para IMPACT MARCOM LTD?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 02 may 2019

    11 páginasLIQ03

    Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros

    11 páginasLIQ13

    Domicilio social registrado cambiado de Europe House 170 Windmill Road West Sunbury on Thames Middlesex TW16 7HB a 55 Baker Street London W1U 7EU el 22 ago 2018

    2 páginasAD01

    Declaración de solvencia

    5 páginasLIQ01

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    3 páginas600

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    liquidation

    Acuerdo especial para la liquidación el 02 ago 2018

    LRESSP

    legacy

    1 páginasSH20

    Estado de capital el 25 jun 2018

    • Capital: GBP 1
    5 páginasSH19

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resolución de reducción del capital social emitido

    RES06

    Cancelación total de la carga 7

    1 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 011662860009

    1 páginasMR04

    Cuentas completas preparadas hasta el 30 jun 2017

    21 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 03 sept 2017 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas completas preparadas hasta el 30 jun 2016

    21 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 03 sept 2016 con actualizaciones

    5 páginasCS01

    Cuentas completas preparadas hasta el 30 jun 2015

    18 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 03 sept 2015 avec liste complète des actionnaires

    3 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital17 sept 2015

    Estado de capital el 17 sept 2015

    • Capital: GBP 667,000
    SH01

    Resoluciones

    Resolutions
    RESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    incorporation

    Resolución de adopción de los Artículos de Asociación

    RES01

    Registro de la carga 011662860009, creada el 24 mar 2015

    55 páginasMR01

    Cancelación total de la carga 8

    1 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 5

    1 páginasMR04

    Cuentas completas preparadas hasta el 30 jun 2014

    20 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 03 sept 2014 avec liste complète des actionnaires

    3 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital19 sept 2014

    Estado de capital el 19 sept 2014

    • Capital: GBP 667,000
    SH01

    ¿Quiénes son los directivos de IMPACT MARCOM LTD?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    ALLEN, John
    Baker Street
    W1U 7EU London
    55
    Director
    Baker Street
    W1U 7EU London
    55
    EnglandBritish182527790001
    COOK, Edward Charles Peregrine Phelps
    Baker Street
    W1U 7EU London
    55
    Director
    Baker Street
    W1U 7EU London
    55
    EnglandBritish52906920005
    KENNEDY, Ewan Campbell
    Flat 11 Crawley Rise
    18 Portsmouth Road
    GU15 1JX Camberley
    Surrey
    Secretario
    Flat 11 Crawley Rise
    18 Portsmouth Road
    GU15 1JX Camberley
    Surrey
    British33639840003
    PORTER, Simon Neil
    Europe House
    170 Windmill Road West
    TW16 7HB Sunbury On Thames
    Middlesex
    Secretario
    Europe House
    170 Windmill Road West
    TW16 7HB Sunbury On Thames
    Middlesex
    British174403180001
    SEYMOUR, Barry James
    9 Fort Street
    GU1 3TB Guildford
    Surrey
    Secretario
    9 Fort Street
    GU1 3TB Guildford
    Surrey
    British1306660001
    STEWARD, Charles David
    17 Windrush Close
    Bramley
    GU5 0BB Guildford
    Surrey
    Secretario
    17 Windrush Close
    Bramley
    GU5 0BB Guildford
    Surrey
    British103109350002
    ALLIN, John Leslie
    5 Elmbrook Vale
    RG11 Wokingham
    Berkshire
    Director
    5 Elmbrook Vale
    RG11 Wokingham
    Berkshire
    British16272300001
    AZAM, Mohammed
    Jenner Way
    KT19 7LJ Epsom
    3
    Surrey
    United Kingdom
    Director
    Jenner Way
    KT19 7LJ Epsom
    3
    Surrey
    United Kingdom
    EnglandBritish135689290001
    BRAY, Myles Edward James
    Woodmancott
    SO21 3BN Winchester
    Woodmancott House
    Hampshire
    United Kingdom
    Director
    Woodmancott
    SO21 3BN Winchester
    Woodmancott House
    Hampshire
    United Kingdom
    EnglandBritish135690640001
    CAUSEVIC, Fredd
    Bekkestua 9a
    Bekkestua
    N-1357
    Norway
    Director
    Bekkestua 9a
    Bekkestua
    N-1357
    Norway
    NorwayNorwegian75177110001
    DEMPSTER, Brian Leigh Harding
    14 Nutfield Gardens
    UB5 6LT Northolt
    Middlesex
    Director
    14 Nutfield Gardens
    UB5 6LT Northolt
    Middlesex
    British16272310001
    ELLIS, Kenneth Leonard
    Europe House
    170 Windmill Road West
    TW16 7HB Sunbury On Thames
    Middlesex
    Director
    Europe House
    170 Windmill Road West
    TW16 7HB Sunbury On Thames
    Middlesex
    EnglandBritish149204440001
    GORTON, Robert David
    55 Redhill Wood
    New Ash Green
    DA3 8QP Longfield
    Kent
    Director
    55 Redhill Wood
    New Ash Green
    DA3 8QP Longfield
    Kent
    EnglandBritish28341780002
    HUDSON, Mark Alan
    Crawshay Drive
    Emmer Green
    RG4 8SY Reading
    58
    England
    Director
    Crawshay Drive
    Emmer Green
    RG4 8SY Reading
    58
    England
    EnglandBritish180576890001
    JEWITT, Anthony John
    13 Pelling Hill
    Old Windsor
    SL4 2LL Windsor
    Berkshire
    Director
    13 Pelling Hill
    Old Windsor
    SL4 2LL Windsor
    Berkshire
    British785310001
    KENNEDY, Ewan Campbell
    Braybourne House
    Crawley Ridge
    GU15 2AD Camberley
    Surrey
    Director
    Braybourne House
    Crawley Ridge
    GU15 2AD Camberley
    Surrey
    British33639840004
    MORAN, Michael Owen
    Australind The Street
    West Clandon
    GU4 7TE Guildford
    Surrey
    Director
    Australind The Street
    West Clandon
    GU4 7TE Guildford
    Surrey
    British1306650001
    PHILLIPS, Julian Brian
    Oakwood
    15 Oxted Green, Milford
    GU8 5D Godalming
    Surrey
    Director
    Oakwood
    15 Oxted Green, Milford
    GU8 5D Godalming
    Surrey
    EnglandBritish122795570002
    PORTER, Simon Neil
    Europe House
    170 Windmill Road West
    TW16 7HB Sunbury On Thames
    Middlesex
    Director
    Europe House
    170 Windmill Road West
    TW16 7HB Sunbury On Thames
    Middlesex
    EnglandUnited Kingdom55262300006
    RAWLINGS, Timothy Paul
    11 Lulworth Road
    DA16 3LQ Welling
    Kent
    Director
    11 Lulworth Road
    DA16 3LQ Welling
    Kent
    British20665210002
    ROBINSON, Mark Laurence
    43 Worminghall Road
    Ickford
    HP18 9JB Aylesbury
    Buckinghamshire
    Director
    43 Worminghall Road
    Ickford
    HP18 9JB Aylesbury
    Buckinghamshire
    EnglandBritish43184090002
    SEYMOUR, Barry James
    9 Fort Street
    GU1 3TB Guildford
    Surrey
    Director
    9 Fort Street
    GU1 3TB Guildford
    Surrey
    EnglandBritish1306660001
    SMITH, John
    Allenwood
    161 London Road
    CM7 8PT Braintree
    Essex
    Director
    Allenwood
    161 London Road
    CM7 8PT Braintree
    Essex
    British66391760001
    STEWARD, Charles David
    17 Windrush Close
    Bramley
    GU5 0BB Guildford
    Surrey
    Director
    17 Windrush Close
    Bramley
    GU5 0BB Guildford
    Surrey
    United KingdomBritish103109350002
    TITLER, Alec
    11 Greenways
    Malt Hill
    TW20 9PA Egham
    Surrey
    Director
    11 Greenways
    Malt Hill
    TW20 9PA Egham
    Surrey
    EnglandBritish48506930001
    TITLER, Alec
    11 Greenways
    Malt Hill
    TW20 9PA Egham
    Surrey
    Director
    11 Greenways
    Malt Hill
    TW20 9PA Egham
    Surrey
    EnglandBritish48506930001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de IMPACT MARCOM LTD?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    170 Windmill Road West
    TW16 7HB Sunbury-On-Thames
    Europe House
    Middlesex
    England
    06 abr 2016
    170 Windmill Road West
    TW16 7HB Sunbury-On-Thames
    Europe House
    Middlesex
    England
    No
    Forma jurídicaLimited Company
    País de registroEngland
    Autoridad legalEnglish
    Lugar de registroCompanies House
    Número de registro02468436
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.

    ¿Tiene IMPACT MARCOM LTD alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    A registered charge
    Creado el 24 mar 2015
    Entregado el 28 mar 2015
    Satisfecho en su totalidad
    La garantía flotante cubre todo:
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía flotante:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Hsbc Bank PLC as Security Trustee for the Secured Parties (Security Agent)
    Transacciones
    • 28 mar 2015Registro de una carga (MR01)
    • 21 jun 2018Satisfacción de una carga (MR04)
    A supplemental deed to a debenture
    Creado el 03 dic 2012
    Entregado el 10 dic 2012
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from each obligor (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personas con derecho
    • Indigo Capital V Sarl
    Transacciones
    • 10 dic 2012Registro de un cargo (MG01)
    • 26 mar 2015Satisfacción de una carga (MR04)
    Debenture
    Creado el 03 dic 2012
    Entregado el 08 dic 2012
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Personas con derecho
    • Hsbc Bank PLC
    Transacciones
    • 08 dic 2012Registro de un cargo (MG01)
    • 21 jun 2018Satisfacción de una carga (MR04)
    Debenture
    Creado el 22 abr 2010
    Entregado el 11 may 2010
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 11 may 2010Registro de un cargo (MG01)
    • 28 nov 2012Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Fixed & floating charge
    Creado el 03 mar 2008
    Entregado el 08 mar 2008
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Personas con derecho
    • Rbs Invoice Finance Limited
    Transacciones
    • 08 mar 2008Registro de un cargo (395)
    • 12 mar 2015Satisfacción de una carga (MR04)
    Debenture
    Creado el 14 ago 2007
    Entregado el 24 ago 2007
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 24 ago 2007Registro de un cargo (395)
    • 06 mar 2009Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Mortgage pursuant to an order of court dated 16/7/91
    Creado el 26 sept 1990
    Entregado el 18 jul 1991
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Unit 12 capitol park pearce way gloucester.
    Personas con derecho
    • Lloyds Bank PLC
    Transacciones
    • 18 jul 1991Registro de una carga
    • 20 mar 2001Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Guarantee & debenture
    Creado el 06 oct 1981
    Entregado el 12 oct 1981
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed & floating charge over undertaking and all property and assets present and future including goodwill, book detbs uncalled captial, buildings, fixtures, fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 12 oct 1981Registro de una carga
    • 04 feb 1997Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 02 jun 1980
    Entregado el 09 jun 1980
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over undertaking and all property and assets present and future including goodwill, book debts uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 09 jun 1980Registro de una carga

    ¿Tiene IMPACT MARCOM LTD algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    30 ago 2019Fecha prevista de disolución
    02 ago 2018Inicio de la liquidación
    Liquidación voluntaria de socios
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Malcolm Cohen
    Bdo Llp 55 Baker Street
    W1U 7EU London
    Profesional
    Bdo Llp 55 Baker Street
    W1U 7EU London

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0