SHARK SPORTS LIMITED
Visión general
Nombre de la empresa | SHARK SPORTS LIMITED |
---|---|
Estado de la empresa | Disuelta |
Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
Número de empresa | 01166443 |
Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
Fecha de constitución | |
Fecha de cese |
Resumen
Tiene PSCs súper seguros | No |
---|---|
Tiene gravámenes | Sí |
Tiene historial de insolvencia | No |
La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de SHARK SPORTS LIMITED?
- Compañía no comercial (74990) / Actividades profesionales, científicas y técnicas
¿Dónde se encuentra SHARK SPORTS LIMITED?
Dirección de la sede social | Aviator Industrial Park Eric Fountain Road CH65 1AX Ellesmere Port England |
---|---|
Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles son las últimas cuentas de SHARK SPORTS LIMITED?
Últimas cuentas | |
---|---|
Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2022 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para SHARK SPORTS LIMITED?
Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 1 páginas | DS01 | ||||||||||||||
Estado de capital el 17 oct 2023
| 5 páginas | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 1 páginas | CAP-SS | ||||||||||||||
legacy | 1 páginas | SH20 | ||||||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de The Aspect, Fourth Floor 12 Finsbury Square London EC2A 1AS England a Aviator Industrial Park Eric Fountain Road Ellesmere Port CH65 1AX el 24 jul 2023 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||||||
Cese del nombramiento de Louise Ellen Mcclelland como director el 31 mar 2023 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||
Nombramiento de Jean-Francois Bayard Vingre como director el 31 mar 2023 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2022 | 7 páginas | AA | ||||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 31 dic 2022 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||||||
Nombramiento de Louise Ellen Mcclelland como director el 10 nov 2022 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||||||
Cese del nombramiento de Raymond Charles Alexandre Leclercq como director el 02 nov 2022 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2021 | 4 páginas | AA | ||||||||||||||
Modification des détails de Survitec Group Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 26 ago 2020 | 2 páginas | PSC05 | ||||||||||||||
Modification des détails de Survitec Group Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 07 jul 2022 | 2 páginas | PSC05 | ||||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 31 dic 2021 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2020 | 6 páginas | AA | ||||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 31 dic 2020 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2019 | 6 páginas | AA | ||||||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de 1-5 Beaufort Road Birkenhead Merseyside CH41 1HQ a The Aspect, Fourth Floor 12 Finsbury Square London EC2A 1AS el 26 ago 2020 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||||||
Nombramiento de Mr Julian Henley-Price como director el 01 jun 2020 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||||||
Cese del nombramiento de Philip Antony Swash como director el 22 abr 2020 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||
Cese del nombramiento de Neil William Gamble como director el 31 ene 2020 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||
¿Quiénes son los directivos de SHARK SPORTS LIMITED?
Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HENLEY-PRICE, Julian Kendall | Director | Eric Fountain Road CH65 1AX Ellesmere Port Aviator Industrial Park England | England | British | General Counsel | 270608310001 | ||||
VINGRE, Jean-Francois Bayard | Director | Eric Fountain Road CH65 1AX Ellesmere Port Aviator Industrial Park England | Belgium | French | Director | 307421140001 | ||||
LEWIS, Sally | Secretario | 1-5 Beaufort Road Birkenhead CH41 1HQ Merseyside | 170982760001 | |||||||
NOLAN, Jane Elizabeth | Secretario | 4 Eastfield Hall Warkworth NE65 0YE Morpeth Northumberland | British | 4022270002 | ||||||
WILMAN, David John | Secretario | Kylemore 4 The Cranagh Warren Road BT21 0ET Donaghadee | British | Director | 22174080002 | |||||
BATES, Christopher Ralph | Director | 1-5 Beaufort Road Birkenhead CH41 1HQ Merseyside | England | British | Chief Financial Officer | 51622580004 | ||||
BAXTER, Douglas James | Director | 40 Howard Drive Chelmer Village CM2 6PE Chelmsford Essex | England | British | Ceo | 12398280001 | ||||
BRAMHAM, Eric | Director | 6 Woodlands Warkworth NE65 0SY Morpeth Northumberland | British | Director | 4763970001 | |||||
BRAMHAM, Richard | Director | 6 Woodlands Warkworth NE65 0SY Morpeth Northumberland | British | Director | 5416370001 | |||||
DRUMMOND, James Edward Macgregor | Director | 1-5 Beaufort Road Birkenhead CH41 1HQ Merseyside | United Kingdom | British | Chief Executive Officer | 115365210001 | ||||
GAMBLE, Neil William | Director | 1-5 Beaufort Road Birkenhead CH41 1HQ Merseyside | United Kingdom | British | Group Financial Controller | 258723750001 | ||||
LECLERCQ, Raymond Charles Alexandre | Director | 12 Finsbury Square EC2A 1AS London The Aspect, Fourth Floor England | United Kingdom | French | Chief Financial Officer | 255289860001 | ||||
MCCHESNEY, William Samuel | Director | 3 Hampton Court BT38 9DT Carrickfergus County Antrim | United Kingdom | British | Director | 69155740001 | ||||
MCCLELLAND, Louise Ellen | Director | 12 Finsbury Square EC2A 1AS London The Aspect, Fourth Floor England | Northern Ireland | British | Deputy Cfo | 269324440002 | ||||
NOLAN, Jane Elizabeth | Director | 4 Eastfield Hall Warkworth NE65 0YE Morpeth Northumberland | England | British | Director/Secretary | 4022270002 | ||||
STOCKER, John Cyril George | Director | 1-5 Beaufort Road Birkenhead CH41 1HQ Merseyside | Northern Ireland | British | Chief Operations Officer | 200821740001 | ||||
STRINGER, Brian Mark | Director | 1-5 Beaufort Road Birkenhead CH41 1HQ Merseyside | England | British | Chief Operating Officer | 162771990001 | ||||
SWASH, Philip Antony | Director | 1-5 Beaufort Road Birkenhead CH41 1HQ Merseyside | England | British | Director | 130491030002 | ||||
WILMAN, David John | Director | Kylemore 4 The Cranagh Warren Road BT21 0ET Donaghadee | United Kingdom | British | Director | 22174080002 | ||||
WITHEY, Simon Benedict | Director | 1-5 Beaufort Road Birkenhead CH41 1HQ Merseyside | England | British | Chief Executive Officer | 166717510001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de SHARK SPORTS LIMITED?
Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Survitec Group Limited | 06 abr 2016 | 12 Finsbury Square EC2A 1AS London The Aspect, Fourth Floor England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
|
¿Tiene SHARK SPORTS LIMITED alguna carga?
Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
---|---|---|---|---|
Guarantee & debenture | Creado el 08 oct 1987 Entregado el 14 oct 1987 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company and/or eurobatex limited to the chargee on any account whatsoever. | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Legal charge | Creado el 19 dic 1985 Entregado el 07 ene 1986 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Factory & premises known as site bt 111/2 hadston industrial estate, northumberland. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Legal charge | Creado el 26 feb 1980 Entregado el 05 mar 1980 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Property being factory extension at broomhill colliery broomhill morpeth northumberland. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Deed of charge | Creado el 07 feb 1979 Entregado el 21 feb 1979 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada £11,295 and further advances | |
Breve descripción Land formerly known as broomhill colliery pithead baths situate at broom hill colliery broomhill northumberland. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Legal charge | Creado el 21 ene 1976 Entregado el 26 ene 1976 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Property at the broomhill northumberland (for further details see doc M9). | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Deed of charge | Creado el 10 nov 1975 Entregado el 24 nov 1975 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada £3988 and further advance of £23012 | |
Breve descripción Land and buildings at broomhill colliery broomhill northumberland. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Debenture | Creado el 22 abr 1975 Entregado el 28 abr 1975 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción By way of legal mortgage all the f/h and l/h property of the company together with plant machinery fixtures implements and utensils by way of 1ST fixed charge by way of 1ST floating charge undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital (see doc m/7). | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0