DATONG LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaDATONG LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 01169448
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de DATONG LIMITED?

    • fabricación de equipos de comunicación, excepto aparatos y equipos de telégrafo y teléfono (26309) / Industrias manufactureras

    ¿Dónde se encuentra DATONG LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Unit 3 Cliffe Park Bruntcliffe Road
    Morley
    LS27 0RY Leeds
    England
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de DATONG LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    DATONG PLC11 oct 200711 oct 2007
    DATONG ELECTRONICS PLC08 sept 200508 sept 2005
    DATONG ELECTRONICS LIMITED08 may 197408 may 1974

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de DATONG LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta30 sept 2020

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para DATONG LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación obligatoria

    1 páginasGAZ2

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación obligatoria

    1 páginasGAZ1

    Domicilio social registrado cambiado de 1 Low Hall Business Park Low Hall Road Horsforth Leeds West Yorkshire LS18 4EG a Unit 3 Cliffe Park Bruntcliffe Road Morley Leeds LS27 0RY el 02 nov 2022

    1 páginasAD01

    Exercice comptable précédent raccourci du 30 sept 2021 au 29 sept 2021

    1 páginasAA01

    Declaración de confirmación presentada el 05 abr 2022 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 sept 2020

    3 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 05 abr 2021 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Nombramiento de Mr Gavin Newport como director el 26 mar 2021

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Roland Barzegar como director el 12 mar 2021

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Michael John Howarth como director el 30 nov 2020

    1 páginasTM01

    Registro de la carga 011694480009, creada el 23 nov 2020

    44 páginasMR01

    Registro de la carga 011694480008, creada el 23 nov 2020

    43 páginasMR01

    Registro de la carga 011694480007, creada el 06 jul 2020

    57 páginasMR01

    Declaración de confirmación presentada el 05 abr 2020 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cancelación total de la carga 011694480005

    1 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 011694480006

    1 páginasMR04

    Cese del nombramiento de David Anderson como director el 21 abr 2020

    1 páginasTM01

    Todo el bien o empresa ha sido liberado de la carga 4

    2 páginasMR05

    Cancelación total de la carga 4

    1 páginasMR04

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 sept 2019

    3 páginasAA

    Nombramiento de Mr Michael John Howarth como director el 22 ene 2020

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Mr Roland Barzegar como director el 22 ene 2020

    2 páginasAP01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 sept 2018

    3 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 05 abr 2019 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 sept 2017

    3 páginasAA

    ¿Quiénes son los directivos de DATONG LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    NEWPORT, Gavin
    Bruntcliffe Road
    Morley
    LS27 0RY Leeds
    Unit 3 Cliffe Park
    England
    Director
    Bruntcliffe Road
    Morley
    LS27 0RY Leeds
    Unit 3 Cliffe Park
    England
    EnglandBritish281339300001
    AYRES, Stephen George
    1 Low Hall Business Park Low
    Hall Road Horsforth
    LS18 4EG Leeds
    West Yorkshire
    Secretario
    1 Low Hall Business Park Low
    Hall Road Horsforth
    LS18 4EG Leeds
    West Yorkshire
    British116077650002
    COOKE, James
    Flat 705 City View House
    463 Bethnal Green Road
    E2 9QY London
    Secretario
    Flat 705 City View House
    463 Bethnal Green Road
    E2 9QY London
    British63463180003
    DAVIES-RATCLIFF, Grant Ashley
    18 Priory Street
    BN7 1HH Lewes
    East Sussex
    Secretario
    18 Priory Street
    BN7 1HH Lewes
    East Sussex
    British68762490001
    GLASS, Colin
    The Fairway
    LS17 7PD Leeds
    66
    West Yorkshire
    Secretario
    The Fairway
    LS17 7PD Leeds
    66
    West Yorkshire
    British17429220001
    HARRINGTON, Christopher James Malcolm
    31 Marston Way
    LS22 6XZ Wetherby
    West Yorkshire
    Secretario
    31 Marston Way
    LS22 6XZ Wetherby
    West Yorkshire
    British61880310003
    MILLER, David
    23 Tillotson Close
    RH10 7WQ Maidenbower
    West Sussex
    Secretario
    23 Tillotson Close
    RH10 7WQ Maidenbower
    West Sussex
    British88052290001
    THOMAS, Kerry Anne Abigail
    65 St Martins Lane
    Langley Park
    BR3 3XU Beckenham
    Kent
    Secretario
    65 St Martins Lane
    Langley Park
    BR3 3XU Beckenham
    Kent
    British61457700003
    TONG, Gillian Kathleen
    6 Arncliffe Road
    LS16 5JE Leeds
    West Yorkshire
    Secretario
    6 Arncliffe Road
    LS16 5JE Leeds
    West Yorkshire
    British3020110001
    ANDERSON, David
    1 Low Hall Business Park Low
    Hall Road Horsforth
    LS18 4EG Leeds
    West Yorkshire
    Director
    1 Low Hall Business Park Low
    Hall Road Horsforth
    LS18 4EG Leeds
    West Yorkshire
    Northern IrelandBritish90445740004
    ASHLEY, Grant
    1 Low Hall Business Park Low
    Hall Road Horsforth
    LS18 4EG Leeds
    West Yorkshire
    Director
    1 Low Hall Business Park Low
    Hall Road Horsforth
    LS18 4EG Leeds
    West Yorkshire
    UsaUsa113819040002
    AYRES, Stephen George
    1 Low Hall Business Park Low
    Hall Road Horsforth
    LS18 4EG Leeds
    West Yorkshire
    Director
    1 Low Hall Business Park Low
    Hall Road Horsforth
    LS18 4EG Leeds
    West Yorkshire
    EnglandBritish116077650002
    BARZEGAR, Roland
    1 Low Hall Business Park Low
    Hall Road Horsforth
    LS18 4EG Leeds
    West Yorkshire
    Director
    1 Low Hall Business Park Low
    Hall Road Horsforth
    LS18 4EG Leeds
    West Yorkshire
    EnglandBritish266377570001
    BLOOD, Dean
    1 Low Hall Business Park Low
    Hall Road Horsforth
    LS18 4EG Leeds
    West Yorkshire
    Director
    1 Low Hall Business Park Low
    Hall Road Horsforth
    LS18 4EG Leeds
    West Yorkshire
    United KingdomBritish139902390001
    BREARLEY, Richard Gregg
    1 Low Hall Business Park Low
    Hall Road Horsforth
    LS18 4EG Leeds
    West Yorkshire
    Director
    1 Low Hall Business Park Low
    Hall Road Horsforth
    LS18 4EG Leeds
    West Yorkshire
    UkBritish288217710001
    COHEN, Robert Victor
    12a Ellington Road
    Muswell Hill
    N10 3DG London
    Director
    12a Ellington Road
    Muswell Hill
    N10 3DG London
    EnglandBritish63085200002
    COOK, Mark Andrew
    1 Low Hall Business Park Low
    Hall Road Horsforth
    LS18 4EG Leeds
    West Yorkshire
    Director
    1 Low Hall Business Park Low
    Hall Road Horsforth
    LS18 4EG Leeds
    West Yorkshire
    United KingdomBritish165905790001
    COOKE, James
    Flat 705 City View House
    463 Bethnal Green Road
    E2 9QY London
    Director
    Flat 705 City View House
    463 Bethnal Green Road
    E2 9QY London
    EnglandBritish63463180003
    COOKE, James
    Flat 705 City View House
    463 Bethnal Green Road
    E2 9QY London
    Director
    Flat 705 City View House
    463 Bethnal Green Road
    E2 9QY London
    EnglandBritish63463180003
    GLASS, Colin
    The Fairway
    LS17 7PD Leeds
    66
    West Yorkshire
    Director
    The Fairway
    LS17 7PD Leeds
    66
    West Yorkshire
    EnglandBritish17429220001
    HALL, Brian Leslie
    40 Leeds Road
    Bramhope
    LS16 9BQ Leeds
    Yorkshire
    Director
    40 Leeds Road
    Bramhope
    LS16 9BQ Leeds
    Yorkshire
    British34547780001
    HARRINGTON, Christopher James Malcolm
    31 Marston Way
    LS22 6XZ Wetherby
    West Yorkshire
    Director
    31 Marston Way
    LS22 6XZ Wetherby
    West Yorkshire
    EnglandBritish61880310003
    HARRINGTON, Christopher James Malcolm
    31 Marston Way
    LS22 6XZ Wetherby
    West Yorkshire
    Director
    31 Marston Way
    LS22 6XZ Wetherby
    West Yorkshire
    EnglandBritish61880310003
    HARRIS, Jocelin Montague St John
    21 Pembroke Square
    W8 6PB London
    Director
    21 Pembroke Square
    W8 6PB London
    United KingdomBritish3078360002
    HOHLER, Frederick Christopher Gerald
    The Court Lodge
    TN15 7PG Stansted
    Kent
    Director
    The Court Lodge
    TN15 7PG Stansted
    Kent
    United KingdomBritish4771470001
    HOWARTH, Michael John
    1 Low Hall Business Park Low
    Hall Road Horsforth
    LS18 4EG Leeds
    West Yorkshire
    Director
    1 Low Hall Business Park Low
    Hall Road Horsforth
    LS18 4EG Leeds
    West Yorkshire
    EnglandBritish280942220001
    HUDSON, Nicholas John
    1 Low Hall Business Park Low
    Hall Road Horsforth
    LS18 4EG Leeds
    West Yorkshire
    Director
    1 Low Hall Business Park Low
    Hall Road Horsforth
    LS18 4EG Leeds
    West Yorkshire
    United KingdomBritish202126040001
    JONES, Teresa Mary
    Dale End House Crayke Road
    Brandsby
    YO6 4RP York
    Yorkshire
    Director
    Dale End House Crayke Road
    Brandsby
    YO6 4RP York
    Yorkshire
    British53825740001
    KIRTLAND, John Philip
    1 Low Hall Business Park Low
    Hall Road Horsforth
    LS18 4EG Leeds
    West Yorkshire
    Director
    1 Low Hall Business Park Low
    Hall Road Horsforth
    LS18 4EG Leeds
    West Yorkshire
    EnglandBritish86087080001
    LEVER, Paul Ronald Scott
    1 Low Hall Business Park Low
    Hall Road Horsforth
    LS18 4EG Leeds
    West Yorkshire
    Director
    1 Low Hall Business Park Low
    Hall Road Horsforth
    LS18 4EG Leeds
    West Yorkshire
    United KingdomBritish106971650001
    ROUGHTON, Neil
    39 Abbeydale Oval
    LS5 3RF Leeds
    Yorkshire
    Director
    39 Abbeydale Oval
    LS5 3RF Leeds
    Yorkshire
    British64915580001
    SHIVTIEL, Dar
    4 St James Terrace
    Horsforth
    LS18 5QT Leeds
    West Yorkshire
    Director
    4 St James Terrace
    Horsforth
    LS18 5QT Leeds
    West Yorkshire
    British53494920001
    SMITH, Brian Mcqueen
    1 Low Hall Business Park Low
    Hall Road Horsforth
    LS18 4EG Leeds
    West Yorkshire
    Director
    1 Low Hall Business Park Low
    Hall Road Horsforth
    LS18 4EG Leeds
    West Yorkshire
    United KingdomBritish62283490005
    SMITH, Stuart Charles James
    12 Hilton Grange
    Bramhope
    LS16 9LE Leeds
    West Yorkshire
    Director
    12 Hilton Grange
    Bramhope
    LS16 9LE Leeds
    West Yorkshire
    British57784910002
    TONG, David Arthur
    6 Arncliffe Road
    LS16 5JE Leeds
    West Yorkshire
    Director
    6 Arncliffe Road
    LS16 5JE Leeds
    West Yorkshire
    British17429210001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de DATONG LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Mr David Anderson
    Bruntcliffe Road
    Morley
    LS27 0RY Leeds
    Unit 3 Cliffe Park
    England
    01 abr 2017
    Bruntcliffe Road
    Morley
    LS27 0RY Leeds
    Unit 3 Cliffe Park
    England
    No
    Nacionalidad: British
    País de residencia: Northern Ireland
    Naturaleza del control
    • La persona tiene el derecho de ejercer, o ejerce realmente, una influencia o control significativo sobre las actividades de una firma que, según la ley que la rige, no es una persona jurídica; y los miembros de esa firma (en su calidad como tales) tienen el derecho, directa o indirectamente, de nombrar o destituir a la mayoría de la junta directiva de la empresa.

    ¿Tiene DATONG LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    A registered charge
    Creado el 23 nov 2020
    Entregado el 14 dic 2020
    Pendiente
    Breve descripción
    Nil.
    La garantía flotante cubre todo:
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía flotante:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • NI Growth Loan Fund LP
    Transacciones
    • 14 dic 2020Registro de una carga (MR01)
    A registered charge
    Creado el 23 nov 2020
    Entregado el 25 nov 2020
    Pendiente
    La garantía flotante cubre todo:
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía flotante:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Yfm Private Equity Limited
    Transacciones
    • 25 nov 2020Registro de una carga (MR01)
    A registered charge
    Creado el 06 jul 2020
    Entregado el 08 jul 2020
    Pendiente
    La garantía flotante cubre todo:
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía flotante:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 08 jul 2020Registro de una carga (MR01)
    A registered charge
    Creado el 21 oct 2013
    Entregado el 08 nov 2013
    Satisfecho en su totalidad
    Breve descripción
    Notification of addition to or amendment of charge.
    La garantía flotante cubre todo:
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • Northern Bank Limited T/a Danske Bank
    Transacciones
    • 08 nov 2013Registro de una carga (MR01)
    • 04 may 2020Satisfacción de una carga (MR04)
    A registered charge
    Creado el 21 oct 2013
    Entregado el 08 nov 2013
    Satisfecho en su totalidad
    Breve descripción
    Notification of addition to or amendment of charge.
    La garantía flotante cubre todo:
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • Northern Bank Limited T/a Danske Bank
    Transacciones
    • 08 nov 2013Registro de una carga (MR01)
    • 07 may 2020Satisfacción de una carga (MR04)
    Debenture
    Creado el 15 nov 2007
    Entregado el 21 nov 2007
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Hsbc Bank PLC
    Transacciones
    • 21 nov 2007Registro de un cargo (395)
    • 21 abr 2020Todo el bien o empresa ha sido liberado de la carga (MR05)
    • 21 abr 2020Satisfacción de una carga (MR04)
    Legal charge
    Creado el 26 ene 2000
    Entregado el 11 feb 2000
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Land and buildings on the east side of clayton wood close west park leeds west yorkshire t/n YWE43029.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 11 feb 2000Registro de un cargo (395)
    • 03 may 2012Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Guarantee & debenture
    Creado el 13 ago 1999
    Entregado el 26 ago 1999
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 26 ago 1999Registro de un cargo (395)
    • 03 may 2012Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Mortgage debenture
    Creado el 20 oct 1998
    Entregado el 03 nov 1998
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 03 nov 1998Registro de un cargo (395)
    • 08 sept 1999Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0