CROWNFLIGHT LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Declaración anual
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaCROWNFLIGHT LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 01169725
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de CROWNFLIGHT LIMITED?

    • Compañía no comercial (74990) / Actividades profesionales, científicas y técnicas

    ¿Dónde se encuentra CROWNFLIGHT LIMITED?

    Dirección de la sede social
    c/o WELL
    Merchants Warehouse
    Castle Street
    M3 4LZ Manchester
    England
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de CROWNFLIGHT LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    E.R. PEAR LIMITED10 may 197410 may 1974

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de CROWNFLIGHT LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta11 ene 2014

    ¿Cuál es el estado de la última declaración anual para CROWNFLIGHT LIMITED?

    Declaración anual
    Última declaración anual

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para CROWNFLIGHT LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Domicilio social registrado cambiado de 1 Angel Square Manchester M60 0AG a C/O Well Merchants Warehouse Castle Street Manchester M3 4LZ el 14 sept 2015

    1 páginasAD01

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Déclaration annuelle établie au 31 jul 2015 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital05 ago 2015

    Estado de capital el 05 ago 2015

    • Capital: GBP 298
    SH01

    Los registros se han trasladado a la ubicación de inspección registrada C/O Tlt Llp One Redcliff Street Bristol BS1 6TP

    1 páginasAD03

    La dirección de inspección del registro se ha cambiado a C/O Tlt Llp One Redcliff Street Bristol BS1 6TP

    1 páginasAD02

    Exercice comptable en cours prolongé du 11 ene 2015 au 30 jun 2015

    1 páginasAA01

    Cese del nombramiento de Caroline Jane Sellers como secretario el 30 sept 2014

    1 páginasTM02

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resoluciones

    Company business 11/08/2014
    RES13

    Déclaration annuelle établie au 31 jul 2014 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital04 ago 2014

    Estado de capital el 04 ago 2014

    • Capital: GBP 298
    SH01

    Cancelación total de la carga 4

    4 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 3

    4 páginasMR04

    Comptes modifiés établis au 11 ene 2014

    5 páginasAAMD

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 11 ene 2014

    4 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 31 jul 2013 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01

    Cambio de datos del director Mr Anthony John Smith el 31 jul 2013

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del director Mr John Branson Nuttall el 31 jul 2013

    3 páginasCH01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 11 ene 2013

    4 páginasAA

    Domicilio social registrado cambiado de New Century House Corporation Street Manchester M60 4ES el 03 dic 2012

    1 páginasAD01

    Déclaration annuelle établie au 31 jul 2012 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 11 ene 2012

    4 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 31 jul 2011 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 11 ene 2011

    4 páginasAA

    Cambio de datos del director Mr Anthony John Smith el 31 jul 2010

    2 páginasCH01

    ¿Quiénes son los directivos de CROWNFLIGHT LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    NUTTALL, John Branson
    Angel Square
    M60 0AG Manchester
    1
    England
    Director
    Angel Square
    M60 0AG Manchester
    1
    England
    EnglandBritish44967060003
    SMITH, Anthony John
    Angel Square
    M60 0AG Manchester
    1
    England
    Director
    Angel Square
    M60 0AG Manchester
    1
    England
    EnglandBritish137558680002
    ELDRIDGE, Katherine Elizabeth
    5 Stanley Avenue
    Hazel Grove
    SK7 4ED Stockport
    Secretario
    5 Stanley Avenue
    Hazel Grove
    SK7 4ED Stockport
    British110230860001
    JONES, Philip Robert
    10 Crowhurst Drive
    Whitley
    WN1 2QH Wigan
    Lancashire
    Secretario
    10 Crowhurst Drive
    Whitley
    WN1 2QH Wigan
    Lancashire
    English43686960001
    MOULT, Stephen Phillip
    Clearview 5 Sutton Spring Wood
    Calow
    S44 5XF Chesterfield
    Derbyshire
    Secretario
    Clearview 5 Sutton Spring Wood
    Calow
    S44 5XF Chesterfield
    Derbyshire
    British45585030001
    PEAR, Doria
    Barncroft
    Church Lane
    NG13 0JD Plungar
    Notts
    Secretario
    Barncroft
    Church Lane
    NG13 0JD Plungar
    Notts
    British24996800001
    SELLERS, Caroline Jane
    Angel Square
    M60 0AG Manchester
    1
    United Kingdom
    Secretario
    Angel Square
    M60 0AG Manchester
    1
    United Kingdom
    150071860001
    UCL SECRETARY LIMITED
    United Co-Operatives Ltd
    Sandbrook House Sandbrook Way
    Rochdale
    Lancashire
    Secretario corporativo
    United Co-Operatives Ltd
    Sandbrook House Sandbrook Way
    Rochdale
    Lancashire
    110375350001
    BATTY, Peter David
    Church Hill
    Ingham
    LN1 2YE Lincoln
    2
    Lincolnshire
    United Kingdom
    Director
    Church Hill
    Ingham
    LN1 2YE Lincoln
    2
    Lincolnshire
    United Kingdom
    EnglandBritish140380300001
    BROCKLEHURST, Jonathan David
    Larch House
    29 Keele Road
    ST5 2JT Newcastle Under Lyme
    Staffordshire
    Director
    Larch House
    29 Keele Road
    ST5 2JT Newcastle Under Lyme
    Staffordshire
    British49108820004
    CROFT, Kenneth Michael
    152 Melton Road
    Stanton On The Wolds Keyworth
    NG12 5BQ Nottingham
    Nottinghamshire
    Director
    152 Melton Road
    Stanton On The Wolds Keyworth
    NG12 5BQ Nottingham
    Nottinghamshire
    British5859440001
    FARQUHAR, Gordon Hillocks
    3 Apsley Grove
    Dorridge
    B93 8QP Solihull
    Director
    3 Apsley Grove
    Dorridge
    B93 8QP Solihull
    United KingdomBritish125645380001
    JONES, Philip Robert
    10 Crowhurst Drive
    Whitley
    WN1 2QH Wigan
    Lancashire
    Director
    10 Crowhurst Drive
    Whitley
    WN1 2QH Wigan
    Lancashire
    United KingdomEnglish43686960001
    MARKS, Peter Vincent
    The Old Barn Low House Farm
    Otley Road Eldwick
    BD16 3AZ Bingley
    West Yorkshire
    Director
    The Old Barn Low House Farm
    Otley Road Eldwick
    BD16 3AZ Bingley
    West Yorkshire
    United KingdomBritish87486470001
    MOULT, Stephen Phillip
    Clearview 5 Sutton Spring Wood
    Calow
    S44 5XF Chesterfield
    Derbyshire
    Director
    Clearview 5 Sutton Spring Wood
    Calow
    S44 5XF Chesterfield
    Derbyshire
    British45585030001
    NUTTALL, John Branson
    The Old Post Office Whitchurch Road
    Broomhall
    CW5 8BZ Nantwich
    Cheshire
    Director
    The Old Post Office Whitchurch Road
    Broomhall
    CW5 8BZ Nantwich
    Cheshire
    British44967060001
    PEAR, Aubrey Edmund
    Barncroft
    Church Lane
    NG13 0JD Plungar
    Notts
    Director
    Barncroft
    Church Lane
    NG13 0JD Plungar
    Notts
    British25080400001
    PEAR, Doria
    Barncroft
    Church Lane
    NG13 0JD Plungar
    Notts
    Director
    Barncroft
    Church Lane
    NG13 0JD Plungar
    Notts
    British24996800001
    SILVER, Steven Russell
    Farr Royd House
    72 Sun Lane
    LS29 7LT Burley In Wharfedale
    West Yorkshire
    Director
    Farr Royd House
    72 Sun Lane
    LS29 7LT Burley In Wharfedale
    West Yorkshire
    EnglandBritish182256460001
    WATES, Martyn James
    3 Aylesby Close
    WA16 8AE Knutsford
    Cheshire
    Director
    3 Aylesby Close
    WA16 8AE Knutsford
    Cheshire
    United KingdomBritish60114700001
    UCL DIRECTOR 1 LIMITED
    United Co-Operatives Ltd
    Sandbrook House Sandbrook Way
    Rochdale
    Lancashire
    Director corporativo
    United Co-Operatives Ltd
    Sandbrook House Sandbrook Way
    Rochdale
    Lancashire
    110375270001

    ¿Tiene CROWNFLIGHT LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Legal charge
    Creado el 12 jul 1994
    Entregado el 13 jul 1994
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    414 broxtowe lane aspley nottingham. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and the plant machinery fixtures and fittings furniture equipment implements and utensils.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 13 jul 1994Registro de un cargo (395)
    • 02 jul 2014Satisfacción de una carga (MR04)
    Debenture
    Creado el 11 ene 1991
    Entregado el 22 ene 1991
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    See 395 for details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 22 ene 1991Registro de una carga
    • 02 jul 2014Satisfacción de una carga (MR04)
    Debenture
    Creado el 02 jun 1987
    Entregado el 10 jun 1987
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 10 jun 1987Registro de una carga
    • 29 jul 1991Registro de una carga
    Legal charge
    Creado el 05 nov 1980
    Entregado el 26 nov 1980
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    F/H 414 broxtowe lane, nottingham, nottinghamshire nt 114158.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 26 nov 1980Registro de una carga

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0