KEP (PREDECESSORS) LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | KEP (PREDECESSORS) LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 01175613 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de KEP (PREDECESSORS) LIMITED?
- Compañía no comercial (74990) / Actividades profesionales, científicas y técnicas
¿Dónde se encuentra KEP (PREDECESSORS) LIMITED?
| Dirección de la sede social | c/o COATS GROUP PLC 1 The Square Stockley Park UB11 1TD Uxbridge Middlesex |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de KEP (PREDECESSORS) LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| KASS ENGINEERING AND PIPEWORK LIMITED | 27 feb 1991 | 27 feb 1991 |
| KASS ENGINEERING & STEELSTOCK LIMITED | 22 jun 1990 | 22 jun 1990 |
| KASS ENGINEERING & PIPEWORK LIMITED | 31 dic 1981 | 31 dic 1981 |
| KASS PIPEWORK SERVICES LIMITED | 31 dic 1979 | 31 dic 1979 |
| KASS MACHINERY LIMITED | 28 jun 1974 | 28 jun 1974 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de KEP (PREDECESSORS) LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2016 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para KEP (PREDECESSORS) LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Estado de capital el 23 ene 2018
| 3 páginas | SH19 | ||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 3 páginas | DS01 | ||||||||||
legacy | 1 páginas | SH20 | ||||||||||
legacy | 1 páginas | CAP-SS | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 11 dic 2017 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2016 | 10 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 11 dic 2016 con actualizaciones | 5 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2015 | 10 páginas | AA | ||||||||||
Cese del nombramiento de Allied Mutual Insurance Services Ltd como director el 23 sept 2016 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Charles Frederick Barlow como director el 23 sept 2016 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Arif Kermalli como director el 23 sept 2016 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Andrew James Stockwell como director el 23 sept 2016 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Kevin Rohan Taylor como director el 23 sept 2016 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Kevin Rohan Taylor como director el 06 abr 2016 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Richard David Howes como director el 06 abr 2016 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 11 dic 2015 avec liste complète des actionnaires | 4 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cambio de datos del director Allied Mutual Insurance Services Ltd el 03 mar 2015 | 1 páginas | CH02 | ||||||||||
Cambio de datos del secretario Allied Mutual Insurance Services Limited el 03 mar 2015 | 1 páginas | CH04 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2014 | 9 páginas | AA | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de C/O Prism Cosec Limited 10 Margaret Street London W1W 8RL a C/O Coats Group Plc 1 the Square Stockley Park Uxbridge Middlesex UB11 1TD el 03 mar 2015 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 11 dic 2014 avec liste complète des actionnaires | 4 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cambio de datos del director Allied Mutual Insurance Services Ltd el 01 jul 2014 | 1 páginas | CH02 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de KEP (PREDECESSORS) LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALLIED MUTUAL INSURANCE SERVICES LIMITED | Secretario corporativo | c/o Coats Group Plc The Square Stockley Park UB11 1TD Uxbridge 1 Middlesex England |
| 126889420001 | ||||||||||
| BARLOW, Charles Frederick | Director | c/o Coats Group Plc The Square Stockley Park UB11 1TD Uxbridge 1 Middlesex | United Kingdom | British | 151336790001 | |||||||||
| KERMALLI, Arif | Director | c/o Coats Group Plc The Square Stockley Park UB11 1TD Uxbridge 1 Middlesex | England | British | 203519190001 | |||||||||
| STOCKWELL, Andrew James | Director | c/o Coats Group Plc The Square Stockley Park UB11 1TD Uxbridge 1 Middlesex | England | British | 79587890002 | |||||||||
| HEALY, Christopher William | Secretario | c/o Prism Cosec Limited Margaret Street W1W 8RL London 10 England | 187613890001 | |||||||||||
| HUGHES, David Robson | Secretario | Madavia 4 Fairfax Crescent Tockwith YO5 8QX York North Yorkshire | British | 32628110001 | ||||||||||
| KING, John Alan Gibbs | Secretario | 10 Ashvale Close Nailsea BS48 1QH Bristol | British | 9313920001 | ||||||||||
| ADAMSON, Michael George | Director | Woodbury Cheniston Grove SL6 4LN Maidenhead Berkshire | British | 56044570001 | ||||||||||
| AINSWORTH, Ian | Director | 78 Throckmorton Road B49 6QJ Alcester Warwickshire | British | 28063480001 | ||||||||||
| BARRETT, Barrie Michael | Director | The Firs Spetchley Road WR5 2NL Worcester Worcestershire | British | 4061200002 | ||||||||||
| BLACKBURN, Peter Edward | Director | 20 Church Lane Downend BS16 6TB Bristol Avon | British | 5531260001 | ||||||||||
| GLEAVE, Clinton John Raymond | Director | 14 Kenneth Crescent Willesden Green NW2 4PT London | England | British | 48349150003 | |||||||||
| HOWES, Richard David | Director | c/o Coats Group Plc The Square Stockley Park UB11 1TD Uxbridge 1 Middlesex England | England | British | 265695690001 | |||||||||
| HUGHES, David Robson | Director | Madavia 4 Fairfax Crescent Tockwith YO5 8QX York North Yorkshire | British | 32628110001 | ||||||||||
| KING, John Alan Gibbs | Director | 10 Ashvale Close Nailsea BS48 1QH Bristol | United Kingdom | British | 9313920001 | |||||||||
| LOFTUS, David John | Director | 48 Oakdale Road Downend BS16 6EA Bristol | England | British | 34443080001 | |||||||||
| MAY, Michael David | Director | 6 St James Road Scawby DN20 8DU Brigg South Humberside | British | 32628120001 | ||||||||||
| PETERSEN, Ronald John | Director | Picket Piece Hale Lane Wendover HP22 6NQ Aylesbury Buckinghamshire | England | American | 59083320001 | |||||||||
| RUSSELL, James Richard | Director | The Old Stables Empingham Road PE9 3RP Ketton Rutland | England | British | 904390002 | |||||||||
| TARN, Nicholas James | Director | c/o Prism Cosec Limited Margaret Street W1W 8RL London 10 England | England | British | 113629970001 | |||||||||
| TAYLOR, Kevin Rohan | Director | c/o Coats Group Plc The Square Stockley Park UB11 1TD Uxbridge 1 Middlesex | England | British | 197540030001 | |||||||||
| WALKER, Tom Clifford | Director | Hepburn House Frankleigh BA15 2PF Bradford On Avon Wiltshire | British | 34992860002 | ||||||||||
| ALLIED MUTUAL INSURANCE SERVICES LTD | Director corporativo | c/o Coats Group Plc The Square Stockley Park UB11 1TD Uxbridge 1 Middlesex England |
| 187613620001 | ||||||||||
| BRUNEL HOLDINGS PLC | Director corporativo | Brunel House 14 Avon Reach SN15 1EE Chippenham Wiltshire | 42533420001 | |||||||||||
| CLAYHILL NOMINEES LIMITED | Director corporativo | Brunel House 14 Avon Reach SN15 1EE Chippenham Wiltshire | 42533440001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de KEP (PREDECESSORS) LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bmm (Predecessors) Limited | 06 abr 2016 | The Square Stockley Park UB11 1TD Uxbridge 1 England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
¿Tiene KEP (PREDECESSORS) LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| Supplemental agreement | Creado el 29 nov 1994 Entregado el 06 dic 1994 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from each obligor (as defined) to the chargee under the terms of each finance document (as defined) | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Composite debenture | Creado el 27 sept 1993 Entregado el 14 oct 1993 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from each obligor (as defined) to the finance parties and to the inter company chargor lenders (each as defined) under the finance documents and under the assigned inter company loans | |
Breve descripción Legal mortgage over certain of the company's real property and over certain of the shares held by it assignment of companys rights under certain intercompany loans made by it as lender. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0