GE INSPECTION AND REPAIR SERVICES LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | GE INSPECTION AND REPAIR SERVICES LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 01182449 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de GE INSPECTION AND REPAIR SERVICES LIMITED?
- Reparación de equipos eléctricos (33140) / Industrias manufactureras
¿Dónde se encuentra GE INSPECTION AND REPAIR SERVICES LIMITED?
| Dirección de la sede social | 3rd Floor 1 Ashley Road WA14 2DT Altrincham Cheshire United Kingdom |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de GE INSPECTION AND REPAIR SERVICES LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| TURBINE BLADING GROUP LIMITED | 18 nov 1987 | 18 nov 1987 |
| MITCHCREST LIMITED | 30 ago 1974 | 30 ago 1974 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de GE INSPECTION AND REPAIR SERVICES LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2020 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para GE INSPECTION AND REPAIR SERVICES LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 3 páginas | DS01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 15 oct 2022 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||||||||||
Cancelación total de la carga 3 | 1 páginas | MR04 | ||||||||||
Cancelación total de la carga 4 | 1 páginas | MR04 | ||||||||||
Estado de capital el 18 ago 2022
| 3 páginas | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 páginas | CAP-SS | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
legacy | 1 páginas | SH20 | ||||||||||
Exercice comptable précédent prolongé du 31 dic 2021 au 30 jun 2022 | 1 páginas | AA01 | ||||||||||
Nombramiento de Shona Clare Searle como director el 01 jul 2022 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de James Edward Dennison como director el 01 jul 2022 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 15 oct 2021 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2020 | 135 páginas | AA | ||||||||||
Nombramiento de James Edward Dennison como director el 18 may 2021 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Achraf Zouaoui como director el 15 may 2021 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2019 | 20 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 15 oct 2020 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2018 | 20 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 15 oct 2019 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Nombramiento de Marc Kenneth Barber como director el 30 sept 2019 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Stephen Thomas Downey como director el 30 sept 2019 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Peter Daryl Everett como director el 30 sept 2019 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Achraf Zouaoui como director el 30 sept 2019 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de GE INSPECTION AND REPAIR SERVICES LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OAKWOOD CORPORATE SECRETARY LIMITED | Secretario corporativo | Floor 1 Ashley Road WA14 2DT Altrincham 3rd Cheshire United Kingdom |
| 146358090001 | ||||||||||
| BARBER, Marc Kenneth | Director | 1 Ashley Road WA14 2DT Altrincham 3rd Floor Cheshire United Kingdom | Switzerland | British | 263050480001 | |||||||||
| SEARLE, Shona Clare | Director | 1 Ashley Road WA14 2DT Altrincham 3rd Floor Cheshire United Kingdom | United Kingdom | British | 203330870002 | |||||||||
| DANIELL, Paul Nigel | Secretario | 7 Lucerne Drive Stadhampton OX44 7QT Oxford Oxfordshire | British | 62463920001 | ||||||||||
| GREEN, Pamela Anne | Secretario | 7 Belgravia Road St Johns WF1 3JP Wakefield West Yorkshire | British | 38435990009 | ||||||||||
| JAFFA, Richard Henry | Secretario | 32 Malcolmson Close Edgbaston B15 3LS Birmingham West Midlands | English | 9163880001 | ||||||||||
| A G SECRETARIAL LIMITED | Secretario corporativo | 100 Barbirolli Square M2 3AB Manchester | 90084920001 | |||||||||||
| CLIFFORD CHANCE SECRETARIES LIMITED | Secretario corporativo | 10 Upper Bank Street E14 5JJ London | 38508390004 | |||||||||||
| BREMNER, Ian Miller | Director | 1 Melford Hall Road B91 2ES Solihull West Midlands | England | British | 29995610001 | |||||||||
| CARTLEDGE, Andrew | Director | 30 Trailside Road MA 02493 Weston United States | British | 70072110003 | ||||||||||
| CHRISTIE, Roderick Angus | Director | 14 Oakfield Road SL8 5QN Bourne End Buckinghamshire | British | 82543780001 | ||||||||||
| CLARK, Alyson Margaret | Director | Downshire Way RG12 1PU Bracknell The Arena Berkshire United Kingdom | United Kingdom | British | 56868460002 | |||||||||
| COYLE, Feilim Malachy | Director | 24 Saint Davids Drive TW20 0BA Englefield Green Surrey | Irish | 70072140002 | ||||||||||
| DANIELL, Paul Nigel | Director | 7 Lucerne Drive Stadhampton OX44 7QT Oxford Oxfordshire | British | 62463920001 | ||||||||||
| DENNISON, James Edward | Director | 1 Ashley Road WA14 2DT Altrincham 3rd Floor Cheshire United Kingdom | United Kingdom | British | 250786800001 | |||||||||
| DIGBY, Mark Damien | Director | Calle Valle Del Roncal 71, Las Lomas 28660 Boadilla Del Monte Madrid Spain | Irish | 103125610001 | ||||||||||
| DOWNEY, Stephen Thomas | Director | Downshire Way RG12 1PU Bracknell The Arena Berkshire United Kingdom | United Kingdom | British | 184747430001 | |||||||||
| EVERETT, Peter Daryl | Director | Downshire Way RG12 1PU Bracknell The Arena Berkshire United Kingdom | England | British | 127244240001 | |||||||||
| FENECH, Lindy Frances | Director | Littlebrook Busines Centre Manor Way DA1 5PZ Dartford Ge Energy Dartford Service Centre Kent United Kingdom | United Kingdom | British | 172863970001 | |||||||||
| FRASER, Gillian Annette | Director | Badgeworth Manor Badgeworth GL51 5UL Cheltenham Gloucestershire | British | 30720040001 | ||||||||||
| FRASER, Michael James | Director | Badgeworth Manor Badgeworth GL51 5UL Cheltenham Gloucestershire | British | 35575120001 | ||||||||||
| GAULT, Ernest Harold | Director | 520 Fawn Glenn Court Roswell Georgia 30075 Usa | American | 62463900001 | ||||||||||
| GRIFFITHS, Kyle | Director | Downshire Way RG12 1PU Bracknell The Arena Berkshire United Kingdom | United Kingdom | Us Citizen | 172602560001 | |||||||||
| JORDAN, Stephen John | Director | 1 Pike Corner Willersey WR12 7PZ Broadway Worcestershire | British | 32376290001 | ||||||||||
| KEENAN, John Joseph | Director | 5 Gresham Road CM14 4HN Brentwood Essex | British | 106985300001 | ||||||||||
| MULHOLLAND, Diarmaid Patrick | Director | Downshire Way RG12 1PU Bracknell The Arena Berkshire United Kingdom | Italy | Irish | 116288460001 | |||||||||
| ROBERTSON, Moria Ann | Director | Downshire Way RG12 1PU Bracknell The Arena Berkshire | United Kingdom | British | 203364460001 | |||||||||
| TON, Gwaine William | Director | Beech Hill Lodge Ridgemead Road, Englefield Green TW20 0YD Egham Surrey | American | 93302530001 | ||||||||||
| WAKE, Hilary Anne, Mrs. | Director | Downshire Way RG12 1PU Bracknell The Arena Berkshire United Kingdom | United Kingdom | British | 96648390001 | |||||||||
| WARDLE, John Malcolm | Director | Norton Grange Norton Grange Lane Knowle Solihull West Midlands | British | 5096040001 | ||||||||||
| WHITE, Andrew Christopher | Director | 4050 Keswick Drive Ga 30339 Atlanta FOREIGN Usa | British | 62466070001 | ||||||||||
| ZOUAOUI, Achraf | Director | 1 Ashley Road WA14 2DT Altrincham 3rd Floor Cheshire United Kingdom | United Arab Emirates | Tunisian | 263000110001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de GE INSPECTION AND REPAIR SERVICES LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ge Uk Group | 06 abr 2016 | 1 Ashley Road WA14 2DT Altrincham 3rd Floor Cheshire United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
¿Cuáles son las últimas declaraciones sobre personas con control significativo para GE INSPECTION AND REPAIR SERVICES LIMITED?
| Notificado el | Cesado el | Declaración |
|---|---|---|
| 15 oct 2016 | 01 dic 2017 | La empresa aún no ha completado las medidas razonables para determinar si existe alguna persona que sea una persona registrable o una entidad jurídica relevante registrable en relación con la empresa. |
¿Tiene GE INSPECTION AND REPAIR SERVICES LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Creado el 26 feb 1998 Entregado el 04 mar 1998 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Fixed and floating charge | Creado el 03 dic 1996 Entregado el 07 dic 1996 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital goodwill bookdebts and patents. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Debenture | Creado el 08 abr 1988 Entregado el 19 abr 1988 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Charge | Creado el 26 may 1982 Entregado el 01 jun 1982 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción All book debts & other debts. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0