SANCTUARY LAND COMPANY LIMITED

SANCTUARY LAND COMPANY LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Cuentas
  • Declaración anual
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaSANCTUARY LAND COMPANY LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 01192287
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de SANCTUARY LAND COMPANY LIMITED?

    • Alquiler y explotación de bienes inmobiliarios de entidades de vivienda (68201) / Actividades inmobiliarias

    ¿Dónde se encuentra SANCTUARY LAND COMPANY LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Chamber Court
    Castle Street
    WR1 3ZQ Worcester
    Worcestershire
    England
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de SANCTUARY LAND COMPANY LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 mar 2015

    ¿Cuál es el estado de la última declaración anual para SANCTUARY LAND COMPANY LIMITED?

    Declaración anual
    Última declaración anual

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para SANCTUARY LAND COMPANY LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    La acción de exclusión voluntaria ha sido suspendida

    1 páginasSOAS(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Domicilio social registrado cambiado de Chamber Court Castle Street Worcester WR1 3ZQ a Chamber Court Castle Street Worcester Worcestershire WR1 3ZQ el 03 feb 2016

    1 páginasAD01

    Déclaration annuelle établie au 30 oct 2015 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital04 nov 2015

    Estado de capital el 04 nov 2015

    • Capital: GBP 5
    SH01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2015

    11 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 30 oct 2014 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital06 nov 2014

    Estado de capital el 06 nov 2014

    • Capital: GBP 6
    SH01

    Renuncia del auditor

    3 páginasAUD

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2014

    13 páginasAA

    Nombramiento de Ms Sophie Atkinson como secretario el 21 jul 2014

    2 páginasAP03

    Cese del nombramiento de Craig Jon Moule como secretario el 21 jul 2014

    1 páginasTM02

    Cambio de datos del director Mr Anthony Neil King el 27 jun 2014

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del director Mr Craig Jon Moule el 05 mar 2014

    2 páginasCH01

    Déclaration annuelle établie au 30 oct 2013 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital14 nov 2013

    Estado de capital el 14 nov 2013

    • Capital: GBP 6
    SH01

    Cambio de datos del director Mr Ian Jeffrey Mcdermott el 08 nov 2013

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del director Mr Craig Jon Moule el 08 nov 2013

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del director Mr Anthony Neil King el 08 nov 2013

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del secretario Mr Craig Jon Moule el 08 nov 2013

    1 páginasCH03

    Cambio de datos del director Mr David John Bennett el 08 nov 2013

    2 páginasCH01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2013

    11 páginasAA

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2012

    12 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 30 oct 2012 avec liste complète des actionnaires

    7 páginasAR01

    Déclaration annuelle établie au 30 oct 2011 avec liste complète des actionnaires

    7 páginasAR01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2011

    12 páginasAA

    ¿Quiénes son los directivos de SANCTUARY LAND COMPANY LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    ATKINSON, Sophie
    Castle Street
    WR1 3ZQ Worcester
    Chamber Court
    Worcestershire
    England
    Secretario
    Castle Street
    WR1 3ZQ Worcester
    Chamber Court
    Worcestershire
    England
    189782000001
    BENNETT, David John
    Castle Street
    WR1 3ZQ Worcester
    Chamber Court
    Worcestershire
    England
    Director
    Castle Street
    WR1 3ZQ Worcester
    Chamber Court
    Worcestershire
    England
    United KingdomBritish86724350001
    KING, Anthony Neil
    Castle Street
    WR1 3ZQ Worcester
    Chamber Court
    Worcestershire
    England
    Director
    Castle Street
    WR1 3ZQ Worcester
    Chamber Court
    Worcestershire
    England
    EnglandBritish9255540009
    MCDERMOTT, Ian Jeffrey
    Castle Street
    WR1 3ZQ Worcester
    Chamber Court
    Worcestershire
    England
    Director
    Castle Street
    WR1 3ZQ Worcester
    Chamber Court
    Worcestershire
    England
    EnglandBritish101774900001
    MOULE, Craig Jon
    Castle Street
    WR1 3ZQ Worcester
    Chamber Court
    Worcestershire
    England
    Director
    Castle Street
    WR1 3ZQ Worcester
    Chamber Court
    Worcestershire
    England
    EnglandBritish135984850004
    BENNETT, David John
    Timberlea House
    HR4 8DQ Moreton-On-Lugg
    Herefordshire
    Secretario
    Timberlea House
    HR4 8DQ Moreton-On-Lugg
    Herefordshire
    British86724350001
    BOYLES, Lynette
    104 Huntingdon Road
    N2 9DU London
    Secretario
    104 Huntingdon Road
    N2 9DU London
    British53764040001
    MOULE, Craig Jon
    Chamber Court
    Castle Street
    WR1 3ZQ Worcester
    Secretario
    Chamber Court
    Castle Street
    WR1 3ZQ Worcester
    British135984850002
    TOULE, John Philip
    2 Oakrits
    Meldreth
    SG8 6JH Royston
    Hertfordshire
    Secretario
    2 Oakrits
    Meldreth
    SG8 6JH Royston
    Hertfordshire
    British78482060001
    ASH, Herbert John
    Cedar Lodge 39 Church Road
    Newick
    BN8 4JX Lewes
    East Sussex
    Director
    Cedar Lodge 39 Church Road
    Newick
    BN8 4JX Lewes
    East Sussex
    British50771830001
    ASHRAF BISMIL, Mohammad
    22 Hill Park Avenue
    Hebble Lane Wheatley
    HX3 5JJ Halifax
    West Yorkshire
    Director
    22 Hill Park Avenue
    Hebble Lane Wheatley
    HX3 5JJ Halifax
    West Yorkshire
    British48655670001
    BARTON, Donald Carroll
    33 Galahad Way
    DY13 8SQ Stourport On Severn
    Worcestershire
    Director
    33 Galahad Way
    DY13 8SQ Stourport On Severn
    Worcestershire
    British55901690001
    BENTLEY, Laurence
    45 Sefton Avenue
    NW7 3QE London
    Director
    45 Sefton Avenue
    NW7 3QE London
    British56352370001
    CLEGG, Derek Peter
    Ridgeway 34 Hambleton Grove
    HG5 0DB Knaresborough
    North Yorkshire
    Director
    Ridgeway 34 Hambleton Grove
    HG5 0DB Knaresborough
    North Yorkshire
    British45227230001
    COATHAM, Veronica Mary
    5 Southam Drive
    Wylde Green
    B73 5PD Birmingham
    West Midlands
    Director
    5 Southam Drive
    Wylde Green
    B73 5PD Birmingham
    West Midlands
    EnglandBritish122358020001
    COLLIER, Joseph Anthony
    7 College Mews
    CV37 6FF Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    Director
    7 College Mews
    CV37 6FF Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    British18604760001
    EVANS, Gilean Mary Rohilla
    8 Broadlands Close
    Calcot Park
    RG31 7RP Reading
    Berkshire
    Director
    8 Broadlands Close
    Calcot Park
    RG31 7RP Reading
    Berkshire
    United KingdomBritish55899670001
    GARDNER, Hilary
    7 Chancellor Close
    Grange Park
    SN5 6HH Swindon
    Wiltshire
    Director
    7 Chancellor Close
    Grange Park
    SN5 6HH Swindon
    Wiltshire
    EnglandBritish73791660001
    GRIFFITHS, Mary Megan
    15 Copthorne Road
    WV3 0AB Wolverhampton
    West Midlands
    Director
    15 Copthorne Road
    WV3 0AB Wolverhampton
    West Midlands
    United KingdomBritish113045000001
    HAWKINS, Richard John
    85 Castle Street
    IP12 1HL Woodbridge
    Suffolk
    Director
    85 Castle Street
    IP12 1HL Woodbridge
    Suffolk
    EnglandBritish45899770002
    HAWKINS, Richard John
    104 Constable Road
    IP4 2XA Ipswich
    Suffolk
    Director
    104 Constable Road
    IP4 2XA Ipswich
    Suffolk
    British45899770001
    HAWKINS, Richard
    C/O Carter Jones
    25 Princes Street
    IP1 Ipswich
    Suffolk
    Director
    C/O Carter Jones
    25 Princes Street
    IP1 Ipswich
    Suffolk
    British29000930002
    HEAD, Roy
    3 Florence Drive
    EN2 8DG Enfield
    Middlesex
    Director
    3 Florence Drive
    EN2 8DG Enfield
    Middlesex
    British18604730001
    HILTON, Christopher Graham
    Arundale Old London Road
    Coldwatham
    RH20 1LF Pulborough
    West Sussex
    Director
    Arundale Old London Road
    Coldwatham
    RH20 1LF Pulborough
    West Sussex
    British82668680001
    HODGSON, Frederick John Warmingham
    Rock House
    PL20 6BS Yelverton
    Devon
    Director
    Rock House
    PL20 6BS Yelverton
    Devon
    British6357950001
    HOLT, Robert George
    59 Weetwood Lane
    LS16 5NP Leeds
    Director
    59 Weetwood Lane
    LS16 5NP Leeds
    EnglandBritish35400070001
    JACKSON, David John
    95 West Ella Road
    HU10 7QR Kirk Ella
    East Riding
    Director
    95 West Ella Road
    HU10 7QR Kirk Ella
    East Riding
    British98790720001
    LIMER, Frederick William
    The Coach House
    Thornwood Road
    CM16 6SX Epping
    Essex
    Director
    The Coach House
    Thornwood Road
    CM16 6SX Epping
    Essex
    British18604740001
    MOORE, Roger
    39 Arundel Road
    BN10 8RS Peacehaven
    East Sussex
    Director
    39 Arundel Road
    BN10 8RS Peacehaven
    East Sussex
    British55900170001
    NASH, Joan Isabel
    Holcombe Farm
    Painswick
    GL6 6RG Stroud
    Gloucestershire
    Director
    Holcombe Farm
    Painswick
    GL6 6RG Stroud
    Gloucestershire
    United KingdomBritish55901730001
    STACY, Graham Henry
    31 Fordington Road
    N6 4TD London
    Director
    31 Fordington Road
    N6 4TD London
    United KingdomBritish45227350001
    STACY, Graham Henry
    31 Fordington Road
    N6 4TD London
    Director
    31 Fordington Road
    N6 4TD London
    United KingdomBritish45227350001
    WILLIAMS, Ronald Peter
    Longlands 8 St Werburgh Close
    Wembury
    PL9 0AP Plymouth
    Devon
    Director
    Longlands 8 St Werburgh Close
    Wembury
    PL9 0AP Plymouth
    Devon
    British26339420001

    ¿Tiene SANCTUARY LAND COMPANY LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Legal charge
    Creado el 30 sept 1988
    Entregado el 19 oct 1988
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    F/H & l/h properties at phase ii iii & iv shadwell basin wapping london.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 19 oct 1988Registro de una carga
    • 11 jun 1996Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    First legal charge
    Creado el 26 jun 1987
    Entregado el 09 jul 1987
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee and the banks (as defined in the loan agreement) under the terms of a loan agreement dated 11/6/87
    Breve descripción
    L/Hold land situate at shadwell basin wapping t/no egl 173650 together with the fixed machinery buildings erections & other fixtures & fittings.
    Personas con derecho
    • N M Rothschild & Sons Limited
    Transacciones
    • 09 jul 1987Registro de una carga
    Floating charge
    Creado el 26 jun 1987
    Entregado el 01 jul 1987
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee as agent for the banks (as defined) under the terms of a loan agreement dated 11-6-87
    Breve descripción
    Floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill and uncalled capital.
    Personas con derecho
    • N.M. Rothschild & Sons Limited
    Transacciones
    • 01 jul 1987Registro de una carga
    Charge over deposit
    Creado el 26 jun 1987
    Entregado el 01 jul 1987
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee as agent for the banks (as defined) under the terms of a loan agreement dated 11-6-87
    Breve descripción
    Fixed charge over all the company's estate right title & interest in all monies from time to time held in a deposit account opened in the name of the company at n m rothschild & sons limited.
    Personas con derecho
    • N M Rothschild & Sons Limited
    Transacciones
    • 01 jul 1987Registro de una carga
    Mortgage deed
    Creado el 04 mar 1986
    Entregado el 20 mar 1986
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    Securing £5,000.000 and all other moneys due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge.
    Breve descripción
    Whereby land at shadwell basin wapping in the l/b of tower hamlets (see doc M36 for full details).
    Personas con derecho
    • Halifax Building Society
    Transacciones
    • 20 mar 1986Registro de una carga

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0