UK PORTFOLIO MANAGEMENT LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | UK PORTFOLIO MANAGEMENT LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 01195031 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de UK PORTFOLIO MANAGEMENT LIMITED?
- Empresa inactiva (99999) / Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales
¿Dónde se encuentra UK PORTFOLIO MANAGEMENT LIMITED?
| Dirección de la sede social | The Observatory Western Road RG12 1TL Bracknell United Kingdom |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de UK PORTFOLIO MANAGEMENT LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| TILNEY DISCRETIONARY INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED | 29 nov 2016 | 29 nov 2016 |
| PLAN INVEST GROUP LIMITED | 31 dic 1976 | 31 dic 1976 |
| PIHC (HOLDINGS) LIMITED | 30 dic 1974 | 30 dic 1974 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de UK PORTFOLIO MANAGEMENT LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2019 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para UK PORTFOLIO MANAGEMENT LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 3 páginas | DS01 | ||||||||||||||
Cese del nombramiento de Deborah Ann Saunders como secretario el 01 sept 2021 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||||||
Nombramiento de Mr Gavin Raymond White como secretario el 01 sept 2021 | 2 páginas | AP03 | ||||||||||||||
Estado de capital el 07 sept 2021
| 5 páginas | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 1 páginas | SH20 | ||||||||||||||
legacy | 1 páginas | CAP-SS | ||||||||||||||
Resoluciones Resolutions | 2 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 04 may 2021 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||||||||||||||
Modification des détails de Tilney Smith & Williamson Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 01 sept 2020 | 2 páginas | PSC05 | ||||||||||||||
Modification des détails de Towry Nominees Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 27 ago 2019 | 2 páginas | PSC05 | ||||||||||||||
Cese del nombramiento de Nicola Claire Mitford-Slade como director el 18 dic 2020 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||
Cese del nombramiento de Christopher Woodhouse como director el 18 dic 2020 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||
Nombramiento de Nicola Claire Mitford-Slade como director el 22 oct 2020 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||||||
Cese del nombramiento de Donald William Sherret Reid como director el 22 oct 2020 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||
Cese del nombramiento de Rehana Hasan como secretario el 22 oct 2020 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||||||
Nombramiento de Deborah Ann Saunders como secretario el 22 oct 2020 | 2 páginas | AP03 | ||||||||||||||
La dirección de inspección del registro se ha cambiado de 6 Chesterfield Gardens London England W1J 5BQ England a 25 Moorgate London EC2R 6AY | 1 páginas | AD02 | ||||||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2019 | 9 páginas | AA | ||||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 04 may 2020 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||||||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2018 | 15 páginas | AA | ||||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 04 may 2019 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||||||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de C/O Rehana Hasan, Company Secretary Towry House Western Road Bracknell Berkshire RG12 1TL England a The Observatory Western Road Bracknell RG12 1TL el 28 ene 2019 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||||||
Nombramiento de Mr Andrew Martin Baddeley como director el 01 oct 2018 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||||||
¿Quiénes son los directivos de UK PORTFOLIO MANAGEMENT LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WHITE, Gavin Raymond | Secretario | Moorgate EC2R 6AY London 25 England | 287112200001 | |||||||
| BADDELEY, Andrew Martin | Director | Chesterfield Gardens W1J 5BQ London 6 England England | United Kingdom | British | 82469460001 | |||||
| BELLAMY, Martin William | Secretario | Queen Victoria Street EC4N 4TR London 60 England | 173971990001 | |||||||
| GREGORY, Jacqueline Anne | Secretario | c/o C/O Jacqui Gregory Western Road RG12 1TL Bracknell Towry House Berkshire England | 197490510001 | |||||||
| HASAN, Rehana | Secretario | Western Road RG12 1TL Bracknell The Observatory United Kingdom | 217672230001 | |||||||
| KAY, Kevin Joseph | Secretario | 15 Melbourne Road Bramhall SK7 1LR Stockport Cheshire | British | 9290220001 | ||||||
| NICHOLS, Sarah | Secretario | Lisbon Square LS1 4LY Leeds 8 West Yorkshire | British | 157133330001 | ||||||
| OWEN, Michael Sibberin | Secretario | 19 Amersham Close SK10 2LF Macclesfield Cheshire | British | 37087430001 | ||||||
| PEACOCK, Natasha Valerie | Secretario | Pear Tree Drive SK15 2PY Stalybridge 7 Cheshire | British | 129803720001 | ||||||
| SAUNDERS, Deborah Ann | Secretario | Moorgate EC2R 6AY London 25 England | 276008280001 | |||||||
| BRADSHAW, Phillip Gordon | Director | Plan Invest House 9 King Edward Street SK10 1AQ Macclesfield Cheshire | United Kingdom | British | 26428400002 | |||||
| BRIGHT, Kevin Robert | Director | 32 Amberley Road SK11 8LX Macclesfield Cheshire | England | British | 9569040001 | |||||
| BUSSEY, Michael Adrian | Director | Plan Invest House 9 King Edward Street SK10 1AQ Macclesfield Cheshire | United Kingdom | British | 52554700003 | |||||
| COLEMAN, Lynn Rose | Director | Plan Invest House 9 King Edward Street SK10 1AQ Macclesfield Cheshire | United Kingdom | British | 149721950001 | |||||
| CRESWELL-TURNER, Miles Marius | Director | Plan Invest House 9 King Edward Street SK10 1AQ Macclesfield Cheshire | England | British | 160087860001 | |||||
| DEVEY, Robert Alan | Director | c/o C/O Jacqui Gregory Western Road RG12 1TL Bracknell Towry House Berkshire England | United Kingdom | British | 146956760001 | |||||
| DOWNING, Wadham St. John | Director | c/o Rehana Hasan, Company Secretary Western Road RG12 1TL Bracknell Towry House Berkshire England | England | British | 203301710001 | |||||
| FITZPATRICK, James Bernard | Director | 57 Hilbre Road West Kirby L48 3HB Wirral Merseyside | British | 67167690001 | ||||||
| FLOWER, Gordon Mark | Director | Queen Victoria Street EC4N 4TR London 60 England | England | British | 133025980001 | |||||
| FOX, Chay Munro | Director | Plan Invest House 9 King Edward Street SK10 1AQ Macclesfield Cheshire | United Kingdom | British | 172112550001 | |||||
| HAINES, Stephen Paul | Director | Queen Victoria Street EC4N 4TR London 60 England | England | British | 185462290001 | |||||
| HALL, Peter Lindop | Director | c/o Rehana Hasan, Company Secretary Western Road RG12 1TL Bracknell Towry House Berkshire England | England | British | 212005290001 | |||||
| HAYES, Peter Richard Downham | Director | Herons Brook Chelford Road Prestbury SK10 4AW Macclesfield Cheshire | British | 9290230001 | ||||||
| JACOBS, Andrew Stephen | Director | Plan Invest House 9 King Edward Street SK10 1AQ Macclesfield Cheshire | United Kingdom | British | 183659460001 | |||||
| JONES, Gaius Trefor Griffith | Director | Queen Victoria Street EC4N 4TR London 60 England | England | British | 57884740001 | |||||
| JONES, Peter Francis | Director | 15 Wigton Park Close LS17 8UH Leeds West Yorkshire | United Kingdom | British | 33965180002 | |||||
| KAY, Kevin Joseph | Director | 15 Melbourne Road Bramhall SK7 1LR Stockport Cheshire | British | 9290220001 | ||||||
| LAWSON, Frank Sydney | Director | 79 Ack Lane East Bramhall SK7 2BH Stockport Cheshire | British | 9569030001 | ||||||
| MIDGLEY, Steven Richard | Director | Queen Victoria Street EC4N 4TR London 60 England | England | British | 186658380001 | |||||
| MITCHELL, Malcolm Jeremy | Director | Yacht House Broad Lane Lower Heswall CH60 9JY Wirral | United Kingdom | British | 9639890004 | |||||
| MITFORD-SLADE, Nicola Claire | Director | Moorgate EC2R 6AY London 25 England | United Kingdom | British | 276051890001 | |||||
| MULLORD, Kathleen Francis | Director | Plan Invest House 9 King Edward Street SK10 1AQ Macclesfield Cheshire | United Kingdom | South African | 160087800001 | |||||
| NICHOLS, Sarah Elizabeth | Director | 1 Home Farm Square Birstwith HG3 2WA Harrogate North Yorkshire | England | British | 93464600001 | |||||
| OWEN, Michael Sibberin | Director | 19 Amersham Close SK10 2LF Macclesfield Cheshire | United Kingdom | British | 37087430001 | |||||
| PEACOCK, Natasha Valerie | Director | Pear Tree Drive SK15 2PY Stalybridge 7 Cheshire | England | British | 129803720001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de UK PORTFOLIO MANAGEMENT LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tilney Group Limited | 06 abr 2016 | Western Road RG12 1TL Bracknell The Observatory United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
¿Tiene UK PORTFOLIO MANAGEMENT LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| Second legal charge | Creado el 16 oct 2000 Entregado el 19 oct 2000 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada £240105 and all moneys due or to become due from the company or by plan invest limited to the chargee | |
Breve descripción By way of second legal charge the f/h property k/a 9 king edward street macclesfield cheshire t/no CH180289. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Legal mortgage | Creado el 17 ago 1992 Entregado el 24 ago 1992 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción 9 king edward street, macclesfield, cheshire, title number CH180289, and/or the proceeds of sale thereof.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Legal mortgage | Creado el 22 sept 1981 Entregado el 28 sept 1981 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción F/H land formerly site of 9 king edward street. Macclesfield cheshire. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0