DD PRODUCTS AND SERVICES LTD
Visión general
| Nombre de la empresa | DD PRODUCTS AND SERVICES LTD |
|---|---|
| Estado de la empresa | Activa |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 01196676 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | No |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de DD PRODUCTS AND SERVICES LTD?
- Comercio al por mayor no especializado (46900) / Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas
¿Dónde se encuentra DD PRODUCTS AND SERVICES LTD?
| Dirección de la sede social | 6 Perry Way CM8 3SX Witham England |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de DD PRODUCTS AND SERVICES LTD?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| BILLERICAY DENTAL SUPPLY CO. LIMITED | 16 ene 1975 | 16 ene 1975 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de DD PRODUCTS AND SERVICES LTD?
| Vencido | No |
|---|---|
| Próximas cuentas | |
| Próximo período contable finaliza el | 30 jun 2026 |
| Próximas cuentas vencen el | 31 mar 2027 |
| Últimas cuentas | |
| Últimas cuentas cerradas hasta | 30 jun 2025 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para DD PRODUCTS AND SERVICES LTD?
| Última declaración de confirmación cerrada hasta | 17 mar 2026 |
|---|---|
| Próxima declaración de confirmación vence | 31 mar 2026 |
| Última declaración de confirmación | |
| Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 17 mar 2025 |
| Vencido | No |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para DD PRODUCTS AND SERVICES LTD?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Cese del nombramiento de Simon Peter Clegg como secretario el 11 feb 2026 | 1 páginas | TM02 | ||
Cese del nombramiento de Samantha Tyrer como director el 11 feb 2026 | 1 páginas | TM01 | ||
Nombramiento de Mr Adam Parkins como secretario el 11 feb 2026 | 2 páginas | AP03 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 30 jun 2025 | 41 páginas | AA | ||
Nombramiento de Mr Simon Peter Clegg como secretario el 01 ago 2025 | 2 páginas | AP03 | ||
Cese del nombramiento de Johanna Elizabeth Deason como secretario el 01 ago 2025 | 1 páginas | TM02 | ||
Nombramiento de Mr Peter Keegans como director el 17 sept 2025 | 2 páginas | AP01 | ||
Nombramiento de Mr Dean Leighton Taylor Hallows como director el 17 sept 2025 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de Andrew James Gawman como director el 10 jul 2025 | 1 páginas | TM01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 17 mar 2025 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 30 jun 2024 | 36 páginas | AA | ||
Cambio de datos del director Mr Nilesh Kundanlal Pandya el 12 oct 2021 | 2 páginas | CH01 | ||
Cambio de datos del director Mrs Samantha Tyrer el 26 ago 2024 | 2 páginas | CH01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2023 | 34 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 17 mar 2024 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||
Nombramiento de Mr Andrew James Gawman como director el 05 feb 2024 | 2 páginas | AP01 | ||
Exercice comptable en cours prolongé du 31 mar 2024 au 30 jun 2024 | 1 páginas | AA01 | ||
Cese del nombramiento de Benjamin William Goodger como director el 29 sept 2023 | 1 páginas | TM01 | ||
Cese del nombramiento de Jamie Nicholas Murray Wells como director el 06 abr 2023 | 1 páginas | TM01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 17 mar 2023 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||
Nombramiento de Mrs Samantha Tyrer como director el 06 mar 2023 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de Gervase Paul Adams como director el 01 mar 2023 | 1 páginas | TM01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2022 | 30 páginas | AA | ||
Registro de la carga 011966760011, creada el 21 oct 2022 | 56 páginas | MR01 | ||
Cancelación total de la carga 011966760008 | 1 páginas | MR04 | ||
¿Quiénes son los directivos de DD PRODUCTS AND SERVICES LTD?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PARKINS, Adam | Secretario | Perry Way CM8 3SX Witham 6 England | 345278960001 | |||||||
| HALLOWS, Dean Leighton Taylor | Director | Perry Way CM8 3SX Witham 6 England | England | British | 205227160002 | |||||
| KEEGANS, Peter | Director | Perry Way CM8 3SX Witham 6 England | England | British | 340357180001 | |||||
| CARROLL, Leo Damian | Secretario | Europa Trading Estate, Stoneclough Road Kearsley M26 1GG Manchester Europa House | 236618180001 | |||||||
| CLEGG, Simon Peter | Secretario | Perry Way CM8 3SX Witham 6 England | 340358000001 | |||||||
| COOK, Ashley John | Secretario | 33 Derwent Road IP3 0QR Ipswich Suffolk | British | 54423310001 | ||||||
| DEASON, Johanna Elizabeth | Secretario | Perry Way CM8 3SX Witham 6 England | 269049700001 | |||||||
| MCDONALD, Elizabeth | Secretario | Europa Trading Estate, Stoneclough Road Kearsley M26 1GG Manchester Integrated Dental Holdings, Europa House England | 187136360001 | |||||||
| MILLS, Odette Nancy | Secretario | 97 Chapel Street CM12 9LR Billericay Essex | British | 6744660001 | ||||||
| O'LEARY, Paul Vincent | Secretario | 6 Perry Way Witham CM8 3SX Essex | British | 92854950005 | ||||||
| ROBSON, William Henry Mark | Secretario | Europa Trading Estate, Stoneclough Road Kearsley M26 1GG Manchester Europa House | 192568690001 | |||||||
| ADAMS, Gervase Paul | Director | Europa Trading Estate Stoneclough Road M26 1GG Kearsley Europa House Manchester United Kingdom | United Kingdom | British | 251246070001 | |||||
| BONNAVION, Jean Michel Claude | Director | Europa Trading Estate, Stoneclough Road Kearsley M26 1GG Manchester Integrated Dental Holdings, Europa House England | England | French | 177007640001 | |||||
| COOK, Ashley John | Director | 33 Derwent Road IP3 0QR Ipswich Suffolk | British | 54423310001 | ||||||
| GAWMAN, Andrew James | Director | Perry Way CM8 3SX Witham 6 England | United Kingdom | British | 157660080002 | |||||
| GOODGER, Benjamin William | Director | Europa Trading Estate Stoneclough Road M26 1GG Kearsley Europa House Manchester United Kingdom | England | British | 261463160001 | |||||
| KUMP, Eric John | Director | Europa Trading Estate, Stoneclough Road Kearsley M26 1GG Manchester Integrated Dental Holdings, Europa House England | United Kingdom | British | 186087470001 | |||||
| MILLS, Gordon Arthur | Director | 6 Perry Way Witham CM8 3SX Essex | England | British | 6744670001 | |||||
| MILLS, Martin Arthur | Director | Europa Trading Estate, Stoneclough Road Kearsley M26 1GG Manchester Europa House England | England | British | 42578630003 | |||||
| MILLS, Odette Nancy | Director | 97 Chapel Street CM12 9LR Billericay Essex | British | 6744660001 | ||||||
| MURRAY WELLS, Jamie Nicholas | Director | Perry Way CM8 3SX Witham 6 England | United Kingdom | British | 78844810001 | |||||
| NICHOLLS, Derek | Director | 6 Perry Way Witham CM8 3SX Essex | England | British | 123433010001 | |||||
| O'LEARY, Paul Vincent | Director | Europa Trading Estate, Stoneclough Road Kearsley M26 1GG Manchester Europa House England | England | British | 92854950005 | |||||
| PANDYA, Nilesh Kundanlal | Director | Europa Trading Estate Stoneclough Road M26 1GG Kearsley Europa House Manchester United Kingdom | United Kingdom | British | 277038750003 | |||||
| RIALL, Tom | Director | Stoncclough Road M26 1GG Kearsley Europa House Eurpoa Trading Estate Manchester United Kingdom | England | British | 177307320003 | |||||
| ROBSON, William Henry Mark | Director | Europa Trading Estate, Stoneclough Road Kearsley M26 1GG Manchester Integrated Dental Holdings, Europa House England | England | British | 57803420002 | |||||
| SCICLUNA, Terence Joseph | Director | Europa Trading Estate, Stoneclough Road Kearsley M26 1GG Manchester Integrated Dental Holdings, Europa House England | England | British | 185155550001 | |||||
| SHAFI KHAN, Mohammed Omar | Director | Europa Trading Estate, Stoneclough Road Kearsley M26 1GG Manchester Europa House | United Kingdom | British | 239506860001 | |||||
| STEPHENSON, Robert Mark | Director | Europa Trading Estate, Stoneclough Road Kearsley M26 1GG Manchester Europa House | England | British | 134638650001 | |||||
| STIRLING, Alex George | Director | Europa Trading Estate, Stoneclough Road Kearsley M26 1GG Manchester Integrated Dental Holdings, Europa House England | United Kingdom | British | 160039370001 | |||||
| TYRER, Samantha | Director | Perry Way CM8 3SX Witham 6 England | England | British | 306343130002 | |||||
| VOLK, Michael David | Director | Europa Trading Estate, Stoneclough Road Kearsley M26 1GG Manchester Europa House England | United Kingdom | British | 123433170001 | |||||
| WHEATSTONE, Mark | Director | Europa Trading Estate, Stoneclough Road Kearsley M26 1GG Manchester Europa House England | United Kingdom | British | 123433220002 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de DD PRODUCTS AND SERVICES LTD?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turnstone Equityco 1 Limited | 06 abr 2016 | Europa Trading Estate, Stoneclough Road Kearsley M26 1GG Manchester Europa House England | Sí | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
| Dd Group Holdings Ltd | 06 abr 2016 | Perry Way CM8 3SX Witham 6 England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso p úblico a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0