PROCON ENGINEERING LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | PROCON ENGINEERING LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 01201645 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de PROCON ENGINEERING LIMITED?
- Empresa inactiva (99999) / Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales
¿Dónde se encuentra PROCON ENGINEERING LIMITED?
| Dirección de la sede social | Stonedale Road Oldends Lane Industrial Estate GL10 3RQ Stonehouse Gloucestershire |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de PROCON ENGINEERING LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| DEFIANT WEIGHING LIMITED | 26 feb 1975 | 26 feb 1975 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de PROCON ENGINEERING LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 30 jun 2019 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para PROCON ENGINEERING LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 3 páginas | DS01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 jun 2019 | 5 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 25 ene 2019 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 jun 2018 | 5 páginas | AA | ||||||||||
Cese del nombramiento de Alastair James Fleming como director el 31 ago 2018 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Simon Scott Reid como director el 09 jul 2018 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 25 ene 2018 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 jun 2017 | 5 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 25 ene 2017 con actualizaciones | 5 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 jun 2016 | 6 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 25 ene 2016 avec liste complète des actionnaires | 5 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Nombramiento de Mr Robbert Oudendijk como director el 30 sept 2015 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Christopher Paul O'neil como director el 30 sept 2015 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 jun 2015 | 4 páginas | AA | ||||||||||
Cambio de datos del director Christopher Paul O'neil el 22 jul 2015 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 jun 2014 | 4 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 25 ene 2015 avec liste complète des actionnaires | 5 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de Vestry Estate Otford Road Sevenoaks Kent TN14 5EL a Stonedale Road Oldends Lane Industrial Estate Stonehouse Gloucestershire GL10 3RQ el 30 oct 2014 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 25 ene 2014 avec liste complète des actionnaires | 5 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cambio de datos del director Christopher Paul O'neil el 07 nov 2013 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Alastair James Fleming el 07 nov 2013 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Nombramiento de Alastair James Fleming como director | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Steven Valentine como director | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de PROCON ENGINEERING LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLOAN, Alison May | Secretario | Badentoy Crescent, Badentoy Industrial Park Portlethen AB12 4YD Aberdeen C/O National Oilwell Varco United Kingdom | 180812090001 | |||||||
| OUDENDIJK, Robbert | Director | 2806 Hh Gouda Tobias Asserstraat 1 Netherlands | Netherlands | Dutch | 201609020001 | |||||
| REID, Simon Scott | Director | Badentoy Crescent, Badentoy Industrial Park Portlethen AB12 4YD Aberdeen C/O National Oilwell Varco United Kingdom | Scotland | British | 248254430001 | |||||
| FLEMING, Alastair James | Secretario | Badentoy Crescent, Badentoy Industrial Park Portlethen AB12 4YD Aberdeen C/O National Oilwell Varco United Kingdom | 163576240001 | |||||||
| O'NEIL, Christopher Paul | Secretario | Forest Park AB39 2GF Stonehaven 69 Kincardineshire | British | 140841820001 | ||||||
| ROBINSON, Keith Marshall | Secretario | 15 Green Lane Oxhey WD19 4NL Watford | British | 8282250001 | ||||||
| STEVENS, Michael Graham | Secretario | The Old Bungalow Routs Green HP14 4BB Bledlow Ridge Buckinghamshire | British | 24187010001 | ||||||
| STEVENS, Michael Graham | Secretario | The Old Bungalow Routs Green HP14 4BB Bledlow Ridge Buckinghamshire | British | 24187010001 | ||||||
| AUSTREID, Arne | Director | Pilehagen 1 4250 Kopervik Norway | Norwegian | 64646880001 | ||||||
| BADHAM, Philip Michael | Director | Yew Tree Cottage Tin Tern Gwent NP6 6SL Gwent | British | 24187020001 | ||||||
| BAKKE, Knut Artur | Director | Andrenbakken 29 1392 Vettre FOREIGN Norway | Norwegian | 41654480001 | ||||||
| BERGSVIK, Eirik | Director | Ringveien 4 Asker 1386 Norway | Norwegian | 70953110001 | ||||||
| BOYLE, Thomas Douglas | Director | Lanark Old Inn Road, Findon Portlethen AB12 3RT Aberdeen | Uk | British | 61611910001 | |||||
| CHRISTIANSEN, Stig | Director | 9b Brattliu FOREIGN Stavanger 4020 Norway | Norwegian | 71135890001 | ||||||
| EIDE, Svein Inge | Director | Gamle Austrattvei 43 4300 Sandnes Norway | Norwegian | 49784670001 | ||||||
| FEILDEN, Michael Oswald | Director | Lubborn House Baltonsborough BA6 8QP Glastonbury Somerset | British | 11004750001 | ||||||
| FLEMING, Alastair James | Director | Badentoy Crescent, Badentoy Industrial Park Portlethen AB12 4YD Aberdeen C/O National Oilwell Varco United Kingdom | Scotland | British | 180854890001 | |||||
| FOLVIK, Anne Marie | Director | Kirkeveien 175a Asker 1370 Norway | Norwegian | 75305350001 | ||||||
| FORWARD, Peter John | Director | 12 Windmill Drive BR2 6BT Keston Kent | British | 24187000001 | ||||||
| HALLAS, Roy Olav | Director | Madlaforen 60 Hafrsfjord, N-4042 FOREIGN Norway | Norwegian | 67101840001 | ||||||
| HENRIKSEN, Bjorn Eie | Director | Austioattbanen 8 4300 Sandnes Norway | Norweigian | 68672310001 | ||||||
| HJORT, Erik | Director | P O Box 36 N 0321 FOREIGN Oslo Norway | Norweigan | 55612920002 | ||||||
| KEENER, David James | Director | 4819 Xp Rijsbergen Oranjestraat 33 Netherlands | Netherlands | Usa | 161469350001 | |||||
| KELLY, John Peter | Director | Rushcliffe Camp Road CR3 7LH Woldingham Surrey | British | 29155190001 | ||||||
| LUND, Reidar | Director | Melingsiden 26 N-4056 N-4056 Tananger Norway | Norweigian | 5325810001 | ||||||
| MALCOLM, Bryan Andrew | Director | Woodland Cottage St Johns Road TN6 1RT Crowborough East Sussex | British | 6112110001 | ||||||
| MAXWELL-SCOTT, Ian | Director | Pondtail House West Hill Bank RH8 9JD Oxted Surrey | United Kingdom | British | 34876790001 | |||||
| MELSTVEIT, Jan Erik | Director | Mvklabergveien 11 Sandnes Rogaland 4314 Norway | Norwegian | 118250360001 | ||||||
| O'NEIL, Christopher Paul | Director | Forest Park AB39 2GF Stonehaven 69 Kincardineshire United Kingdom | United Kingdom | British | 162062160001 | |||||
| ROOTS, Roy Alan | Director | 25 Southridge Road TN6 1NG Crowborough East Sussex | England | British | 44704570001 | |||||
| SKEIE, Birger | Director | Hvetevein 1 4635 Kristiansand | Norwegian | 3206040001 | ||||||
| SKRETTING, Hakon | Director | Meiseveien 20 4360 Varhaug FOREIGN Norway | Norwegian | 40153840001 | ||||||
| STEVENS, Michael Graham | Director | The Old Bungalow Routs Green HP14 4BB Bledlow Ridge Buckinghamshire | United Kingdom | British | 24187010001 | |||||
| STEVENS, Michael Graham | Director | The Old Bungalow Routs Green HP14 4BB Bledlow Ridge Buckinghamshire | United Kingdom | British | 24187010001 | |||||
| VALENTINE, Steven Grenville | Director | 4 Barnes Close Haslington CW1 5ZG Crewe | England | British | 92773870002 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de PROCON ENGINEERING LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hydralift Holdings Uk Limited | 06 abr 2016 | Oldends Lane Industrial Estate GL10 3RQ Stonehouse Stonedale Road Gloucestershire United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
¿Tiene PROCON ENGINEERING LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| Single debenture | Creado el 20 jun 1990 Entregado el 22 jun 1990 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Debenture | Creado el 21 jun 1989 Entregado el 29 jun 1989 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Debenture | Creado el 09 ene 1985 Entregado el 21 ene 1985 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Legal charge | Creado el 09 dic 1981 Entregado el 17 dic 1981 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada £10,000 & all other monies due or to become due from the company to the charge | |
Breve descripción Block 1, units 1, 2 & 3 vestry estate, oxford, kent. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0