PROCON ENGINEERING LIMITED

PROCON ENGINEERING LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaPROCON ENGINEERING LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 01201645
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de PROCON ENGINEERING LIMITED?

    • Empresa inactiva (99999) / Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales

    ¿Dónde se encuentra PROCON ENGINEERING LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Stonedale Road
    Oldends Lane Industrial Estate
    GL10 3RQ Stonehouse
    Gloucestershire
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de PROCON ENGINEERING LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    DEFIANT WEIGHING LIMITED26 feb 197526 feb 1975

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de PROCON ENGINEERING LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta30 jun 2019

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para PROCON ENGINEERING LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 jun 2019

    5 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 25 ene 2019 con actualizaciones

    4 páginasCS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 jun 2018

    5 páginasAA

    Cese del nombramiento de Alastair James Fleming como director el 31 ago 2018

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mr Simon Scott Reid como director el 09 jul 2018

    2 páginasAP01

    Declaración de confirmación presentada el 25 ene 2018 con actualizaciones

    4 páginasCS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 jun 2017

    5 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 25 ene 2017 con actualizaciones

    5 páginasCS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 jun 2016

    6 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 25 ene 2016 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital26 ene 2016

    Estado de capital el 26 ene 2016

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Nombramiento de Mr Robbert Oudendijk como director el 30 sept 2015

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Christopher Paul O'neil como director el 30 sept 2015

    1 páginasTM01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 jun 2015

    4 páginasAA

    Cambio de datos del director Christopher Paul O'neil el 22 jul 2015

    2 páginasCH01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 jun 2014

    4 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 25 ene 2015 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital04 feb 2015

    Estado de capital el 04 feb 2015

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Domicilio social registrado cambiado de Vestry Estate Otford Road Sevenoaks Kent TN14 5EL a Stonedale Road Oldends Lane Industrial Estate Stonehouse Gloucestershire GL10 3RQ el 30 oct 2014

    1 páginasAD01

    Déclaration annuelle établie au 25 ene 2014 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital28 ene 2014

    Estado de capital el 28 ene 2014

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Cambio de datos del director Christopher Paul O'neil el 07 nov 2013

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del director Alastair James Fleming el 07 nov 2013

    2 páginasCH01

    Nombramiento de Alastair James Fleming como director

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Steven Valentine como director

    1 páginasTM01

    ¿Quiénes son los directivos de PROCON ENGINEERING LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    SLOAN, Alison May
    Badentoy Crescent, Badentoy Industrial Park
    Portlethen
    AB12 4YD Aberdeen
    C/O National Oilwell Varco
    United Kingdom
    Secretario
    Badentoy Crescent, Badentoy Industrial Park
    Portlethen
    AB12 4YD Aberdeen
    C/O National Oilwell Varco
    United Kingdom
    180812090001
    OUDENDIJK, Robbert
    2806 Hh Gouda
    Tobias Asserstraat 1
    Netherlands
    Director
    2806 Hh Gouda
    Tobias Asserstraat 1
    Netherlands
    NetherlandsDutch201609020001
    REID, Simon Scott
    Badentoy Crescent, Badentoy Industrial Park
    Portlethen
    AB12 4YD Aberdeen
    C/O National Oilwell Varco
    United Kingdom
    Director
    Badentoy Crescent, Badentoy Industrial Park
    Portlethen
    AB12 4YD Aberdeen
    C/O National Oilwell Varco
    United Kingdom
    ScotlandBritish248254430001
    FLEMING, Alastair James
    Badentoy Crescent, Badentoy Industrial Park
    Portlethen
    AB12 4YD Aberdeen
    C/O National Oilwell Varco
    United Kingdom
    Secretario
    Badentoy Crescent, Badentoy Industrial Park
    Portlethen
    AB12 4YD Aberdeen
    C/O National Oilwell Varco
    United Kingdom
    163576240001
    O'NEIL, Christopher Paul
    Forest Park
    AB39 2GF Stonehaven
    69
    Kincardineshire
    Secretario
    Forest Park
    AB39 2GF Stonehaven
    69
    Kincardineshire
    British140841820001
    ROBINSON, Keith Marshall
    15 Green Lane
    Oxhey
    WD19 4NL Watford
    Secretario
    15 Green Lane
    Oxhey
    WD19 4NL Watford
    British8282250001
    STEVENS, Michael Graham
    The Old Bungalow
    Routs Green
    HP14 4BB Bledlow Ridge
    Buckinghamshire
    Secretario
    The Old Bungalow
    Routs Green
    HP14 4BB Bledlow Ridge
    Buckinghamshire
    British24187010001
    STEVENS, Michael Graham
    The Old Bungalow
    Routs Green
    HP14 4BB Bledlow Ridge
    Buckinghamshire
    Secretario
    The Old Bungalow
    Routs Green
    HP14 4BB Bledlow Ridge
    Buckinghamshire
    British24187010001
    AUSTREID, Arne
    Pilehagen 1
    4250 Kopervik
    Norway
    Director
    Pilehagen 1
    4250 Kopervik
    Norway
    Norwegian64646880001
    BADHAM, Philip Michael
    Yew Tree Cottage
    Tin Tern Gwent
    NP6 6SL
    Gwent
    Director
    Yew Tree Cottage
    Tin Tern Gwent
    NP6 6SL
    Gwent
    British24187020001
    BAKKE, Knut Artur
    Andrenbakken 29
    1392 Vettre
    FOREIGN Norway
    Director
    Andrenbakken 29
    1392 Vettre
    FOREIGN Norway
    Norwegian41654480001
    BERGSVIK, Eirik
    Ringveien 4
    Asker
    1386
    Norway
    Director
    Ringveien 4
    Asker
    1386
    Norway
    Norwegian70953110001
    BOYLE, Thomas Douglas
    Lanark
    Old Inn Road, Findon Portlethen
    AB12 3RT Aberdeen
    Director
    Lanark
    Old Inn Road, Findon Portlethen
    AB12 3RT Aberdeen
    UkBritish61611910001
    CHRISTIANSEN, Stig
    9b Brattliu
    FOREIGN Stavanger
    4020
    Norway
    Director
    9b Brattliu
    FOREIGN Stavanger
    4020
    Norway
    Norwegian71135890001
    EIDE, Svein Inge
    Gamle Austrattvei 43
    4300 Sandnes
    Norway
    Director
    Gamle Austrattvei 43
    4300 Sandnes
    Norway
    Norwegian49784670001
    FEILDEN, Michael Oswald
    Lubborn House
    Baltonsborough
    BA6 8QP Glastonbury
    Somerset
    Director
    Lubborn House
    Baltonsborough
    BA6 8QP Glastonbury
    Somerset
    British11004750001
    FLEMING, Alastair James
    Badentoy Crescent, Badentoy Industrial Park
    Portlethen
    AB12 4YD Aberdeen
    C/O National Oilwell Varco
    United Kingdom
    Director
    Badentoy Crescent, Badentoy Industrial Park
    Portlethen
    AB12 4YD Aberdeen
    C/O National Oilwell Varco
    United Kingdom
    ScotlandBritish180854890001
    FOLVIK, Anne Marie
    Kirkeveien 175a
    Asker
    1370
    Norway
    Director
    Kirkeveien 175a
    Asker
    1370
    Norway
    Norwegian75305350001
    FORWARD, Peter John
    12 Windmill Drive
    BR2 6BT Keston
    Kent
    Director
    12 Windmill Drive
    BR2 6BT Keston
    Kent
    British24187000001
    HALLAS, Roy Olav
    Madlaforen 60
    Hafrsfjord, N-4042
    FOREIGN Norway
    Director
    Madlaforen 60
    Hafrsfjord, N-4042
    FOREIGN Norway
    Norwegian67101840001
    HENRIKSEN, Bjorn Eie
    Austioattbanen 8
    4300 Sandnes
    Norway
    Director
    Austioattbanen 8
    4300 Sandnes
    Norway
    Norweigian68672310001
    HJORT, Erik
    P O Box 36
    N 0321
    FOREIGN Oslo
    Norway
    Director
    P O Box 36
    N 0321
    FOREIGN Oslo
    Norway
    Norweigan55612920002
    KEENER, David James
    4819 Xp
    Rijsbergen
    Oranjestraat 33
    Netherlands
    Director
    4819 Xp
    Rijsbergen
    Oranjestraat 33
    Netherlands
    NetherlandsUsa161469350001
    KELLY, John Peter
    Rushcliffe
    Camp Road
    CR3 7LH Woldingham
    Surrey
    Director
    Rushcliffe
    Camp Road
    CR3 7LH Woldingham
    Surrey
    British29155190001
    LUND, Reidar
    Melingsiden 26
    N-4056
    N-4056 Tananger
    Norway
    Director
    Melingsiden 26
    N-4056
    N-4056 Tananger
    Norway
    Norweigian5325810001
    MALCOLM, Bryan Andrew
    Woodland Cottage St Johns Road
    TN6 1RT Crowborough
    East Sussex
    Director
    Woodland Cottage St Johns Road
    TN6 1RT Crowborough
    East Sussex
    British6112110001
    MAXWELL-SCOTT, Ian
    Pondtail House
    West Hill Bank
    RH8 9JD Oxted
    Surrey
    Director
    Pondtail House
    West Hill Bank
    RH8 9JD Oxted
    Surrey
    United KingdomBritish34876790001
    MELSTVEIT, Jan Erik
    Mvklabergveien 11
    Sandnes
    Rogaland 4314
    Norway
    Director
    Mvklabergveien 11
    Sandnes
    Rogaland 4314
    Norway
    Norwegian118250360001
    O'NEIL, Christopher Paul
    Forest Park
    AB39 2GF Stonehaven
    69
    Kincardineshire
    United Kingdom
    Director
    Forest Park
    AB39 2GF Stonehaven
    69
    Kincardineshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish162062160001
    ROOTS, Roy Alan
    25 Southridge Road
    TN6 1NG Crowborough
    East Sussex
    Director
    25 Southridge Road
    TN6 1NG Crowborough
    East Sussex
    EnglandBritish44704570001
    SKEIE, Birger
    Hvetevein 1
    4635 Kristiansand
    Director
    Hvetevein 1
    4635 Kristiansand
    Norwegian3206040001
    SKRETTING, Hakon
    Meiseveien 20
    4360 Varhaug
    FOREIGN Norway
    Director
    Meiseveien 20
    4360 Varhaug
    FOREIGN Norway
    Norwegian40153840001
    STEVENS, Michael Graham
    The Old Bungalow
    Routs Green
    HP14 4BB Bledlow Ridge
    Buckinghamshire
    Director
    The Old Bungalow
    Routs Green
    HP14 4BB Bledlow Ridge
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish24187010001
    STEVENS, Michael Graham
    The Old Bungalow
    Routs Green
    HP14 4BB Bledlow Ridge
    Buckinghamshire
    Director
    The Old Bungalow
    Routs Green
    HP14 4BB Bledlow Ridge
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish24187010001
    VALENTINE, Steven Grenville
    4 Barnes Close
    Haslington
    CW1 5ZG Crewe
    Director
    4 Barnes Close
    Haslington
    CW1 5ZG Crewe
    EnglandBritish92773870002

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de PROCON ENGINEERING LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Oldends Lane Industrial Estate
    GL10 3RQ Stonehouse
    Stonedale Road
    Gloucestershire
    United Kingdom
    06 abr 2016
    Oldends Lane Industrial Estate
    GL10 3RQ Stonehouse
    Stonedale Road
    Gloucestershire
    United Kingdom
    No
    Forma jurídicaLimited By Shares
    País de registroEngland And Wales
    Autoridad legalUnited Kingdom (England And Wales)
    Lugar de registroCompanies House
    Número de registro03121604
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.
    • La persona tiene el derecho, directa o indirectamente, de nombrar o destituir a la mayoría de la junta directiva de la empresa.

    ¿Tiene PROCON ENGINEERING LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Single debenture
    Creado el 20 jun 1990
    Entregado el 22 jun 1990
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Lloyds Bank PLC
    Transacciones
    • 22 jun 1990Registro de una carga
    • 18 feb 1997Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 21 jun 1989
    Entregado el 29 jun 1989
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Banque Arabe Et International D'investissement
    Transacciones
    • 29 jun 1989Registro de una carga
    • 16 jul 1992Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 09 ene 1985
    Entregado el 21 ene 1985
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 21 ene 1985Registro de una carga
    Legal charge
    Creado el 09 dic 1981
    Entregado el 17 dic 1981
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £10,000 & all other monies due or to become due from the company to the charge
    Breve descripción
    Block 1, units 1, 2 & 3 vestry estate, oxford, kent.
    Personas con derecho
    • Jermyn Group Services LTD.
    Transacciones
    • 17 dic 1981Registro de una carga

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0