CHARNWOOD FOODS LIMITED

CHARNWOOD FOODS LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaCHARNWOOD FOODS LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 01205129
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de CHARNWOOD FOODS LIMITED?

    • Fabricación de otros productos alimenticios, n.c.o.p. (10890) / Industrias manufactureras

    ¿Dónde se encuentra CHARNWOOD FOODS LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Premier House
    Centrium Business Park
    AL1 2RE Griffiths Way, St. Albans
    Hertfordshire
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de CHARNWOOD FOODS LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    BUTTERKUP FOODS LIMITED28 ago 198628 ago 1986
    SAMAC FOOD SERVICES LIMITED26 mar 197526 mar 1975

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de CHARNWOOD FOODS LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2011

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para CHARNWOOD FOODS LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Déclaration annuelle établie au 15 sept 2012 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital25 sept 2012

    Estado de capital el 25 sept 2012

    • Capital: GBP 1,500,000
    SH01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2011

    7 páginasAA

    Nombramiento de Emmett Mcevoy como director el 20 abr 2012

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Antony David Smith como director el 20 abr 2012

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Andrew Mcdonald como director el 15 nov 2011

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Suzanne Elizabeth Wise como director el 15 nov 2011

    1 páginasTM01

    Declaración de los objetos de la sociedad

    2 páginasCC04

    Aviso de eliminación de la restricción sobre los estatutos de la sociedad

    2 páginasCC02

    Resoluciones

    Resolutions
    34 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    incorporation

    Resolución de adopción de los Artículos de Asociación

    RES01
    capital

    Resolución de asignación de valores

    RES10

    Déclaration annuelle établie au 15 sept 2011 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01

    Nombramiento de Mr Antony David Smith como director

    3 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Andrew Peeler como director

    2 páginasTM01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2010

    7 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 05 jun 2011 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01

    Cambio de datos del director Mr Andrew Michael Peeler el 05 jun 2011

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del director Ms Suzanne Elizabeth Wise el 05 jun 2011

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del secretario Mr Simon Nicholas Wilbraham el 05 jun 2011

    1 páginasCH03

    Nombramiento de Mr Simon Nicholas Wilbraham como director

    2 páginasAP01

    Déclaration annuelle établie au 15 sept 2010 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2009

    7 páginasAA

    legacy

    3 páginas363a

    legacy

    1 páginas288b

    ¿Quiénes son los directivos de CHARNWOOD FOODS LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    WILBRAHAM, Simon Nicholas
    Premier House
    Centrium Business Park
    AL1 2RE Griffiths Way, St. Albans
    Hertfordshire
    Secretario
    Premier House
    Centrium Business Park
    AL1 2RE Griffiths Way, St. Albans
    Hertfordshire
    British125719290002
    MCDONALD, Andrew John
    Centrium Business Park
    Griffiths Way
    AL1 2RE St Albans
    Premier House
    Hertfordshire
    Director
    Centrium Business Park
    Griffiths Way
    AL1 2RE St Albans
    Premier House
    Hertfordshire
    EnglandBritish164670820001
    MCEVOY, Emmett
    Centrium Business Park
    Griffiths Way
    AL1 2RE St Albans
    Premier House
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Director
    Centrium Business Park
    Griffiths Way
    AL1 2RE St Albans
    Premier House
    Hertfordshire
    United Kingdom
    United KingdomIrish168590540001
    WILBRAHAM, Simon Nicholas
    Premier House
    Centrium Business Park
    AL1 2RE Griffiths Way, St. Albans
    Hertfordshire
    Director
    Premier House
    Centrium Business Park
    AL1 2RE Griffiths Way, St. Albans
    Hertfordshire
    EnglandBritish125719290002
    BURTON, Denise Patricia
    55 Kingston Hill Place
    Kingston Hill
    KT2 7QY Kingston Upon Thames
    Surrey
    Secretario
    55 Kingston Hill Place
    Kingston Hill
    KT2 7QY Kingston Upon Thames
    Surrey
    British47432570002
    HARTREY, Patrick Mark
    30 Colham Road
    UB8 3WQ Hillingdon
    Middlesex
    Secretario
    30 Colham Road
    UB8 3WQ Hillingdon
    Middlesex
    British50340730004
    HINES, Christine Anne
    33 Sandhills Road
    Barnt Green
    B45 8NP Birmingham
    Secretario
    33 Sandhills Road
    Barnt Green
    B45 8NP Birmingham
    British27217290001
    MILLER, Roger Keith
    Hatters Barn
    Stockwell Lane Little Meadle
    HP17 9UG Aylesbury
    Buckinghamshire
    Secretario
    Hatters Barn
    Stockwell Lane Little Meadle
    HP17 9UG Aylesbury
    Buckinghamshire
    British120645920001
    WATERS, Paul Christopher
    Avenue Road
    CV37 6UW Stratford-Upon-Avon
    37
    Warwickshire
    United Kingdom
    Secretario
    Avenue Road
    CV37 6UW Stratford-Upon-Avon
    37
    Warwickshire
    United Kingdom
    British126327110002
    WILBRAHAM, Simon Nicholas
    Queens Crescent
    AL4 9QG St. Albans
    19
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Secretario
    Queens Crescent
    AL4 9QG St. Albans
    19
    Hertfordshire
    United Kingdom
    British125719290002
    WOODMORE, Michael Brian
    59 Terrington Hill
    SL7 2RE Marlow
    Buckinghamshire
    Secretario
    59 Terrington Hill
    SL7 2RE Marlow
    Buckinghamshire
    British37177620001
    ALLNER, Andrew James
    9 The Crescent
    Barnes
    SW13 0NN London
    Director
    9 The Crescent
    Barnes
    SW13 0NN London
    British73003300001
    CLARKE, Jonathan Michael Rushton
    1 Newalls Rise
    RG10 8AY Wargrave
    Berkshire
    Director
    1 Newalls Rise
    RG10 8AY Wargrave
    Berkshire
    United KingdomBritish98818450001
    CROSSLEY, Nigel
    HP9
    Director
    HP9
    EnglandBritish145901880001
    DUNCAN, Ian Alexander
    Durham House
    Durham Place
    SW3 4ET London
    Director
    Durham House
    Durham Place
    SW3 4ET London
    United KingdomBritish27300002
    GRANT, Brian John
    The Light House
    North Street Winkfield
    SL4 4SY Windsor
    Berkshire
    Director
    The Light House
    North Street Winkfield
    SL4 4SY Windsor
    Berkshire
    United KingdomBritish64875090001
    HARGREAVES, Stephen John
    Stable House
    Smeeton Road
    LE8 0QT Saddington
    Leicestershire
    Director
    Stable House
    Smeeton Road
    LE8 0QT Saddington
    Leicestershire
    Great BritainBritish99437380001
    HODSON, Mark Anthony
    Orchard Barn
    Bulby
    PE10 0RU Bourne
    Lincolnshire
    Director
    Orchard Barn
    Bulby
    PE10 0RU Bourne
    Lincolnshire
    EnglandBritish142364940001
    KELLY, Timothy Geoffrey
    The Mansion House
    Abbotts Inn
    SP11 7AU Andover
    Hampshire
    Director
    The Mansion House
    Abbotts Inn
    SP11 7AU Andover
    Hampshire
    EnglandBritish92817300001
    LAWSON, Robert
    36 Exeter Road
    NW2 4SB London
    Director
    36 Exeter Road
    NW2 4SB London
    EnglandBritish99991140001
    MARCHANT, Richard Norman
    60 The Mount
    Curdworth
    B76 9HR Sutton Coldfield
    West Midlands
    Director
    60 The Mount
    Curdworth
    B76 9HR Sutton Coldfield
    West Midlands
    British26880001
    MCMAHON, Ian Reid
    The Gate House
    Burfield Road
    SL4 2LH Old Windsor
    Berkshire
    Director
    The Gate House
    Burfield Road
    SL4 2LH Old Windsor
    Berkshire
    British84644240002
    MURPHY, Thomas Jerome Peter
    9 One Tree Lane
    HP9 2BU Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Director
    9 One Tree Lane
    HP9 2BU Beaconsfield
    Buckinghamshire
    British76945730001
    OAKLEY, Christopher Richard
    26 Long Park
    Chesham Bois
    HP6 5LA Amersham
    Buckinghamshire
    Director
    26 Long Park
    Chesham Bois
    HP6 5LA Amersham
    Buckinghamshire
    EnglandBritish124625030001
    PANTER, Alan James, Mr.
    14 Thornhill Bridge Wharf
    N1 0RU London
    Director
    14 Thornhill Bridge Wharf
    N1 0RU London
    British114414690002
    PEELER, Andrew Michael
    Premier House
    Centrium Business Park
    AL1 2RE Griffiths Way, St. Albans
    Hertfordshire
    Director
    Premier House
    Centrium Business Park
    AL1 2RE Griffiths Way, St. Albans
    Hertfordshire
    United KingdomBritish87359710001
    PICKERING, Alistair Neil
    13 Upper Cranbrook Road
    Redland
    BS6 7UW Bristol
    Director
    13 Upper Cranbrook Road
    Redland
    BS6 7UW Bristol
    United KingdomBritish83785410002
    QUICK, Nigel Robert
    Autumn Cottage
    8 Gladstone Street
    LE8 0HL Kibworth Beauchamp
    Leicestershire
    Director
    Autumn Cottage
    8 Gladstone Street
    LE8 0HL Kibworth Beauchamp
    Leicestershire
    British36629900001
    RUDDICK, Ian William
    32 Woodend Drive
    SL5 9BG Ascot
    Berkshire
    Director
    32 Woodend Drive
    SL5 9BG Ascot
    Berkshire
    United KingdomBritish98350001
    SCHURCH, Michael John
    1 Aldersey Road
    GU1 2ER Guildford
    Surrey
    Director
    1 Aldersey Road
    GU1 2ER Guildford
    Surrey
    United KingdomBritish42065200002
    SIMMONS, Alex Thomas
    39 Pedmore Lane
    Pedmore
    DY9 0SY Stourbridge
    West Midlands
    Director
    39 Pedmore Lane
    Pedmore
    DY9 0SY Stourbridge
    West Midlands
    United KingdomBritish105865430001
    SMITH, Antony David
    Centrium Business Park
    Griffiths Way
    AL1 2RE St Albans
    Premier House
    Hertfordshire
    Director
    Centrium Business Park
    Griffiths Way
    AL1 2RE St Albans
    Premier House
    Hertfordshire
    United KingdomBritish147725160001
    SWEENEY, Brendan John
    Long Owl Barn
    Coed Y Paen
    NP4 0TB Pontypool
    Gwent
    Director
    Long Owl Barn
    Coed Y Paen
    NP4 0TB Pontypool
    Gwent
    British Irish79007350001
    WHITING, Timothy James
    57 Beauchamp Avenue
    CV32 5TB Leamington Spa
    Warwickshire
    Director
    57 Beauchamp Avenue
    CV32 5TB Leamington Spa
    Warwickshire
    British44028500002
    WIGNALL, Howard Ernest Edwin
    62 Garland
    Rothley
    LE7 7RG Leicester
    Leicestershire
    Director
    62 Garland
    Rothley
    LE7 7RG Leicester
    Leicestershire
    British32234150001

    ¿Tiene CHARNWOOD FOODS LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Debenture
    Creado el 26 jul 2004
    Entregado el 06 ago 2004
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from each obligor to the lenders (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Loweth woods magna road south wigston leicester f/h, de montford (garage) magna road south wigston leicester f/H. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Jpmorgan Chase Bank as Agent and Trustee for Itself and Each of the Lenders
    Transacciones
    • 06 ago 2004Registro de un cargo (395)
    • 28 jul 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture between rhm group one limited, the chargors and the chargees (all as defined)
    Creado el 11 sept 2000
    Entregado el 23 sept 2000
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All present and future obligations and liabilities (whether actual or contingent and whether owed jointly or severally or in any other capacity whatsoever) of each obligor to the chargee (or any of them) under the finance documents (or any of them), together with all costs charges and expenses incurred by the lenders (or any of them) in connection with the protection, preservation or enforcement of it's respective rights under the finance documents for which any obligor is liable under the finance documents except any obligation, which, if it were so included, would result in the debenture contravening 151 of the companies act 1985, section 60 of the republic of ireland act 1963 or companies (northern ireland) order 1996.
    Breve descripción
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Morgan Guaranty Trust Company of New York (As "Security Agent")
    Transacciones
    • 23 sept 2000Registro de un cargo (395)
    • 28 jul 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 17 jul 1981
    Entregado el 23 jul 1981
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed & floating charge undertaking and all property and assets present and future including goodwill book debts uncalled capital & all buildings fixtures (inc trade fixtures) fixed plant & machinery.
    Personas con derecho
    • Lloyds Bank PLC
    Transacciones
    • 23 jul 1981Registro de una carga
    • 20 jul 2000Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Deposit of deeds without instrument
    Creado el 20 sept 1979
    Entregado el 24 sept 1979
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Breve descripción
    Lease of premises at carpenters place, london SW4.
    Personas con derecho
    • Lloyds Bank PLC
    Transacciones
    • 24 sept 1979Registro de una carga
    • 20 jul 2000Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Deposit of deeds without instrument
    Creado el 20 sept 1979
    Entregado el 24 sept 1979
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Breve descripción
    L/H premises known as unit A3, park hall road trading estate, london SE21.
    Personas con derecho
    • Lloyds Bank PLC
    Transacciones
    • 24 sept 1979Registro de una carga
    • 20 jul 2000Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0