HARGREAVES MACHINES LIMITED
Visión general
Nombre de la empresa | HARGREAVES MACHINES LIMITED |
---|---|
Estado de la empresa | Disuelta |
Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
Número de empresa | 01212175 |
Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
Fecha de constitución | |
Fecha de cese |
Resumen
Tiene PSCs súper seguros | No |
---|---|
Tiene gravámenes | Sí |
Tiene historial de insolvencia | No |
La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de HARGREAVES MACHINES LIMITED?
- Empresa inactiva (99999) / Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales
¿Dónde se encuentra HARGREAVES MACHINES LIMITED?
Dirección de la sede social | 3 The Maltings Wetmore Road DE14 1SE Burton On Trent Staffordshire |
---|---|
Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de HARGREAVES MACHINES LIMITED?
Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
---|---|---|
BOLTON LEISURE LIMITED | 15 ago 1995 | 15 ago 1995 |
MACHINE MANAGEMENT SERVICES LIMITED | 06 sept 1983 | 06 sept 1983 |
CORAL SPORTS DEVELOPMENT LIMITED | 31 dic 1980 | 31 dic 1980 |
STOCKS BROS. (LEISURE) LIMITED | 31 dic 1977 | 31 dic 1977 |
STOCKS BROS (MANAGEMENT) LIMITED | 13 may 1975 | 13 may 1975 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de HARGREAVES MACHINES LIMITED?
Últimas cuentas | |
---|---|
Últimas cuentas cerradas hasta | 30 sept 2018 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para HARGREAVES MACHINES LIMITED?
Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 3 páginas | DS01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 sept 2018 | 5 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 11 may 2019 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 sept 2017 | 5 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 11 may 2018 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Steven John Holmes como director el 22 sept 2017 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Stewart Frank Bradley Baker como director el 21 sept 2017 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 24 sept 2016 | 6 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 11 may 2017 con actualizaciones | 5 páginas | CS01 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 11 may 2016 avec liste complète des actionnaires | 3 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 26 sept 2015 | 5 páginas | AA | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 27 sept 2014 | 4 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 11 may 2015 avec liste complète des actionnaires | 3 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cese del nombramiento de James William O'halleran como director el 02 abr 2015 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Steven John Holmes como director el 24 mar 2015 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Nombramiento de Mrs Carys Damon como secretario el 23 mar 2015 | 2 páginas | AP03 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Steven John Holmes como secretario el 23 mar 2015 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 28 sept 2013 | 1 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 11 may 2014 avec liste complète des actionnaires | 3 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Déclaration annuelle établie au 11 may 2013 avec liste complète des actionnaires | 3 páginas | AR01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 29 sept 2012 | 1 páginas | AA | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 24 sept 2011 | 6 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 11 may 2012 avec liste complète des actionnaires | 3 páginas | AR01 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de HARGREAVES MACHINES LIMITED?
Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAMON, Carys | Secretario | 3 The Maltings Wetmore Road DE14 1SE Burton On Trent Staffordshire | 196165240001 | |||||||
BAKER, Stewart Frank Bradley | Director | 3 The Maltings Wetmore Road DE14 1SE Burton On Trent Staffordshire | United Kingdom | British | Chief Financial Officer | 230753770001 | ||||
ALBION, Susan | Secretario | 7 Brownsfield Road WS13 6BT Lichfield Staffordshire | British | Solicitor | 80142740001 | |||||
HOLMES, Steven John | Secretario | 3 The Maltings Wetmore Road DE14 1SE Burton On Trent Staffordshire | British | General Counsel | 80455940002 | |||||
OLDHAM, Annette | Secretario | Edwards Farm Road Fradley WS13 8NR Lichfield 29 Staffordshire | British | 135120610001 | ||||||
PAGE, David | Secretario | Rye Croft House 11 Outwoods Lane Anslow DE13 9UB Burton On Trent Staffordshire | British | 31059170002 | ||||||
THOMAS, Paul | Secretario | 26 Risegate NG12 3JF Cotgrave Nottinghamshire | British | 29218800001 | ||||||
BEER, Brian Leslie | Director | 52 Meadow View Rolleston On Dove DE13 9AN Burton On Trent Staffordshire | British | Company Director | 61154670001 | |||||
CHILDS, Mervyn Peter | Director | Riverdale Lower High Street DE13 9LU Burton On Trent Staffordshire | British | Company Director | 4619870002 | |||||
CHINN, Neil | Director | 12 Newton Park Newton Solney DE15 0SX Burton On Trent Staffordshire | United Kingdom | British | Company Director | 61154190002 | ||||
DARBY, Otto Charles | Director | 103 Harborne Road Edgbaston B15 3HG Birmingham | British | Chairman | 3928470001 | |||||
DAY, John Michael | Director | 27 Newfield Lane S17 3DB Sheffield South Yorkshire | England | British | Personnel & It Director | 69255730001 | ||||
HARRISON, Gerald Edward | Director | 57 Furlong Lane Alrewas DE13 7EE Burton On Trent Staffordshire | United Kingdom | British | Director Of Operations | 47602430001 | ||||
HOLMES, Steven John | Director | 3 The Maltings Wetmore Road DE14 1SE Burton On Trent Staffordshire | United Kingdom | British | Solicitor | 195545010001 | ||||
HOYLE, Russell Blackburn | Director | 5 Orchard Rise TW10 5BX Richmond Surrey | England | British | Company Director | 52822380002 | ||||
LANGLEY, Paul | Director | 9 Besbury Close Dorridge B93 8NT Solihull | England | British | Sales Director | 99802010001 | ||||
MASSEY, Timothy John | Director | Chestnut Cottage Silver Lane Marchington ST14 8LL Uttoxeter Staffordshire | United Kingdom | British | Free Trade Sales Director | 100259370001 | ||||
NAPIER, Iain John Grant | Director | Loxley 5 Ladywood Road B74 2SN Sutton Coldfield West Midlands | British | Company Chairman | 68802120001 | |||||
O'HALLERAN, James William | Director | 3 The Maltings Wetmore Road DE14 1SE Burton On Trent Staffordshire | England | British | Company Director | 103876820003 | ||||
PAGE, David | Director | Rye Croft House 11 Outwoods Lane Anslow DE13 9UB Burton On Trent Staffordshire | England | British | Finance Director Secretary | 31059170002 | ||||
PORTNO, Antony David, Dr | Director | 91 Burley Lane Quarndon DE22 5JR Derby | British | Company Director | 58363120001 | |||||
PURDY, Brian Mascott | Director | Three Gables Ingoldfield Lane Newtown PO17 6LF Fareham Hampshire | British | Operations Director | 48006930001 | |||||
SHERLOCK, Peter Charles | Director | The Grange Somersal Herbert DE6 5PD Ashbourne Derbyshire | British | Company Director | 27922900001 | |||||
SIMON, Christopher Neil | Director | 89 Ella Road West Bridgford NG2 5GZ Nottingham | England | British | Managing Director | 95528490001 | ||||
SMITH, Keith Ian | Director | Wythtree Manor Park DE13 7JA Kings Bromley Staffordshire | United Kingdom | British | Operations Director | 40284060002 | ||||
THOMAS, Paul | Director | 26 Risegate NG12 3JF Cotgrave Nottinghamshire | British | Company Director | 29218800001 | |||||
THOMPSON, Michael Robert | Director | Park Road Alrewas DE13 7AG Burton On Trent 20 Staffordshire | British | Chartered Accountant | 134817070001 | |||||
WITHERS, Roger Dean | Director | Ivy Cottage The Green Dinton HP17 8UP Aylesbury Buckinghamshire | England | British | Company Director | 29586130001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de HARGREAVES MACHINES LIMITED?
Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inspired Gaming (Uk) Limited | 06 abr 2016 | The Maltings Wetmore Road DE14 1SE Burton-On-Trent 3 Staffordshire England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
|
¿Tiene HARGREAVES MACHINES LIMITED alguna carga?
Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
---|---|---|---|---|
Deed of amendment and restatement to a composite guarantee and debenture dated 3RD august 1998 (the "deed") | Creado el 26 mar 1999 Entregado el 10 abr 1999 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All indebtedness and liabilities and obligations due owing or incurred pursuant to the revolving credit facility, the mezzanine loan facility and that part of the term loan facility not used to repay indebtedness due under the facilities agreement to the chargee by any group company whether actually or contingently, whether pursuant to the guarantee or otherwise | |
Breve descripción L/H unit 6B freshfields industrial estate stevenson road kemp town brighton t/n ESX56825 l/h unit 1 spring meadow trading estate lamby way cardiff t/n WA567171 39 woodall road redburn industrial estate enfield t/n NGL500091 (for further details see form 395). fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Composite guarantee and debenture | Creado el 03 ago 1998 Entregado el 20 ago 1998 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due pursuant to the revolving credit facility to the security beneficiaries by any group company on any account whatsoever | |
Breve descripción L/H unit 6B freshfields industrial estate stevenson road kemp town brighton t/n ESX56825 l/h unit 1 spring meadow trading estate lamby way cardiff t/n WA567171 39 woodall road redburn industrial estate enfield t/n NGL500091 for further details of property charged refer to form 395. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0