LONDON CAR TELEPHONES LIMITED

LONDON CAR TELEPHONES LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaLONDON CAR TELEPHONES LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 01220140
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de LONDON CAR TELEPHONES LIMITED?

    • (7499) /

    ¿Dónde se encuentra LONDON CAR TELEPHONES LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de LONDON CAR TELEPHONES LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    LONDON MESSAGE HANDLING LIMITED 22 jul 197522 jul 1975

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de LONDON CAR TELEPHONES LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 mar 2010

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para LONDON CAR TELEPHONES LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Déclaration annuelle établie au 15 feb 2011 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital15 feb 2011

    Estado de capital el 15 feb 2011

    • Capital: GBP 125,000
    SH01

    Nombramiento de Joanne Sarah Finch como director

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Richard Wolfgang Henry Schäfer como director

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Thomas Nowak como director

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Christian Allen como director

    1 páginasTM01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2010

    6 páginasAA

    Cambio de datos del director Martin John Purkess el 01 jul 2010

    2 páginasCH01

    Déclaration annuelle établie au 15 feb 2010 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01

    Resoluciones

    Resolutions
    32 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resolución de asignación de valores

    RES10
    capital

    Resoluciones

    Section 175(5) 18/12/2009
    RES13
    incorporation

    Resolución de adopción de los Artículos de Asociación

    RES01

    Declaración de los objetos de la sociedad

    2 páginasCC04

    Cambio de datos del director Thomas Nowak el 01 oct 2009

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del director Mr Christian Philip Quentin Allen el 01 oct 2009

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del director Martin Purkess el 01 oct 2009

    2 páginasCH01

    legacy

    1 páginas288a

    legacy

    1 páginas288b

    legacy

    1 páginas288a

    legacy

    1 páginas288b

    Cuentas preparadas hasta el 31 mar 2009

    6 páginasAA

    legacy

    4 páginas363a

    legacy

    1 páginas288b

    Cuentas preparadas hasta el 31 mar 2008

    6 páginasAA

    legacy

    1 páginas288b

    ¿Quiénes son los directivos de LONDON CAR TELEPHONES LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    WRIGHT, Garth Howard
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Vodafone House
    Berkshire
    England
    Secretario
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Vodafone House
    Berkshire
    England
    British130769810001
    FINCH, Joanne Sarah
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Director
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    United KingdomBritish158146620001
    PURKESS, Martin John
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Director
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    EnglandBritish139360020001
    SCHÄFER, Richard Wolfgang Henry
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Vodafone House
    Berkshire
    United Kingdom
    Director
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Vodafone House
    Berkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish158146600001
    COX, Homersham Martin
    Littlewood Park View
    Buxted
    TN22 4LS Uckfield
    East Sussex
    Secretario
    Littlewood Park View
    Buxted
    TN22 4LS Uckfield
    East Sussex
    British1058000001
    EMETULU, Lola
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Secretario
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    British88619360002
    JEFFERSON, Karen
    8 Bailey Close
    SN9 5HU Pewsey
    Wiltshire
    Secretario
    8 Bailey Close
    SN9 5HU Pewsey
    Wiltshire
    British79393480001
    SCOTT, Stephen Roy
    Bracken House
    Bunces Shaw Farley Hill
    RG7 1UU Reading
    Berkshire
    Secretario
    Bracken House
    Bunces Shaw Farley Hill
    RG7 1UU Reading
    Berkshire
    British25660590003
    ALLEN, Christian Philip Quentin
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Director
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    British123612980001
    BREWER, Stephen
    Flat 10 Rushworth House
    Enborne Lodge Lane
    RG14 6RH Newbury
    Berkshire
    Director
    Flat 10 Rushworth House
    Enborne Lodge Lane
    RG14 6RH Newbury
    Berkshire
    British79186090002
    BROCKLEHURST, Nigel
    1 Hollyhocks Reading Road
    Harwell
    OX11 0LX Didcot
    Oxfordshire
    Director
    1 Hollyhocks Reading Road
    Harwell
    OX11 0LX Didcot
    Oxfordshire
    British92967830001
    CHESWORTH, Paul
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Director
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    British99525280001
    COX, Homersham Martin
    Littlewood Park View
    Buxted
    TN22 4LS Uckfield
    East Sussex
    Director
    Littlewood Park View
    Buxted
    TN22 4LS Uckfield
    East Sussex
    British1058000001
    CUTHBERTSON, Gordon
    75 The Manor Drive
    KT4 7LJ Worcester Park
    Surrey
    Director
    75 The Manor Drive
    KT4 7LJ Worcester Park
    Surrey
    British37983930001
    DIPRE, Paul Vincent
    Junta
    Waterhouse Lane
    KT20 6HT Kingswood
    Surrey
    Director
    Junta
    Waterhouse Lane
    KT20 6HT Kingswood
    Surrey
    British3747590001
    DIPRE, Remo
    The Pines
    Farm Lane
    KT21 1LU Ashtead
    Surrey
    Director
    The Pines
    Farm Lane
    KT21 1LU Ashtead
    Surrey
    United KingdomBritish35117250001
    EVANS, Mark
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Director
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    British127017870001
    HALFORD, Andrew Nigel
    The Oxdrove House
    Burghclere
    RG20 9HJ Newbury
    Berkshire
    Director
    The Oxdrove House
    Burghclere
    RG20 9HJ Newbury
    Berkshire
    British33951180005
    HANFORD, Raymond Clifford
    Romney Cottage Park Horsley
    East Horsley
    KT24 5RZ Leatherhead
    Surrey
    Director
    Romney Cottage Park Horsley
    East Horsley
    KT24 5RZ Leatherhead
    Surrey
    United KingdomBritish45868080001
    JONES, David Leslie
    Three Oak Barn
    RH14 0PY Plaistow
    West Sussex
    Director
    Three Oak Barn
    RH14 0PY Plaistow
    West Sussex
    British83517310001
    LANGSTON, Edward
    23 Manilla Road
    Clifton
    BS8 4EB Bristol
    Avon
    Director
    23 Manilla Road
    Clifton
    BS8 4EB Bristol
    Avon
    UkBritish24471140001
    LEE, Simon Christopher
    Moorlands
    Harrow Road West
    RH4 3BH Dorking
    Surrey
    Director
    Moorlands
    Harrow Road West
    RH4 3BH Dorking
    Surrey
    United KingdomBritish86697870001
    NOWAK, Thomas, Dr
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Director
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    United KingdomGerman174443800001
    READ, Nicholas Jonathan
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Director
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    United KingdomBritish87149560001
    SAMUEL, James Charles Marshall
    1 Grove Place
    Tatsfield
    TN16 2BA Westerham
    Kent
    Director
    1 Grove Place
    Tatsfield
    TN16 2BA Westerham
    Kent
    British24141650001
    TOURNON, Emanuele
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Director
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    United KingdomItalian103542080002
    TOWNSEND, John Raymond
    Knowle House
    Chapel Corner Hamstead Marshall
    RG20 0HP Newbury
    Berkshire
    Director
    Knowle House
    Chapel Corner Hamstead Marshall
    RG20 0HP Newbury
    Berkshire
    British95223480001
    WEBB, Denys William
    Oakfield Stud
    Whitemoor Lane, Upper Basildon
    RG8 8SF Reading
    Berkshire
    Director
    Oakfield Stud
    Whitemoor Lane, Upper Basildon
    RG8 8SF Reading
    Berkshire
    United KingdomBritish76074580001

    ¿Tiene LONDON CAR TELEPHONES LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Guarantee and debenture
    Creado el 28 abr 1992
    Entregado el 19 may 1992
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    See form 395 for full details- doc M86. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Svenska Handelsbanken
    Transacciones
    • 19 may 1992Registro de un cargo (395)
    • 19 may 1993Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 15 jun 1989
    Entregado el 20 jun 1989
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Svenska Handels Banken
    Transacciones
    • 20 jun 1989Registro de una carga
    • 19 may 1993Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Suplemental mortgage
    Creado el 26 dic 1982
    Entregado el 26 dic 1982
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    Further securing the monies secured by a mortgage dated 4TH july 1980
    Breve descripción
    Equipment as set out in the schedule to the supplemntal mortgage.
    Personas con derecho
    • Bank Brussels Lambert (UK) Limited
    Transacciones
    • 26 dic 1982Registro de una carga
    Charge
    Creado el 31 ago 1982
    Entregado el 03 sept 1982
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed & floating charges on the undertaking and all property and assets present and future including book debts uncalled capital.
    Personas con derecho
    • Midland Bank PLC
    Transacciones
    • 03 sept 1982Registro de una carga
    • 26 mar 1992Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Supplemental assignment
    Creado el 26 feb 1982
    Entregado el 26 feb 1982
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    Further securing the monies secured by a mortgage dated 4TH july 1980
    Breve descripción
    Leases as set out in the schedule to the supplemental mortgage.
    Personas con derecho
    • Bank Brussels Lambert (UK) Limited
    Transacciones
    • 26 feb 1982Registro de una carga
    Suplemental mortgage
    Creado el 07 abr 1981
    Entregado el 25 abr 1981
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    Further securing the monies secured by amortgage dated 4TH july 1980
    Breve descripción
    Equipment as set out in the schedule to the supplemental mortgage.
    Personas con derecho
    • Bank Brussels Lambert (UK) Limited
    Transacciones
    • 25 abr 1981Registro de una carga
    Supplemental assignment
    Creado el 07 abr 1981
    Entregado el 25 abr 1981
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    Further securing the monies secured by a mortgage dated 4TH july 1980
    Breve descripción
    Leaseas as set out in the schedule to the supplemental assignment.
    Personas con derecho
    • Bank Brussels Lambert (UK) Limited
    Transacciones
    • 25 abr 1981Registro de una carga
    Supplemental mortgage
    Creado el 14 ene 1981
    Entregado el 16 ene 1981
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    Further securing the monies secured by amortgage dated 4TH july 1980
    Breve descripción
    Equipment as described in teh leases as set out in the schedule to the supplementary mortgage.
    Personas con derecho
    • Bank Brussels Lambert (UK) Limited
    Transacciones
    • 16 ene 1981Registro de una carga
    Supplemental assignment
    Creado el 14 ene 1981
    Entregado el 16 ene 1981
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    Further securing all the monies secured by an assignment dated 4TH july 1980
    Breve descripción
    Leases as set out in the schedule of the supplementary assignment.
    Personas con derecho
    • Bank Brussels Lambert (UK) Limited
    Transacciones
    • 16 ene 1981Registro de una carga
    Supplemental mortgage
    Creado el 30 oct 1980
    Entregado el 04 nov 1980
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    Further securing the moneis secured by a mortgage dated 4 july 1980
    Breve descripción
    The equiment described in the leases as set out in the schedule to the supplemental mortgage.
    Personas con derecho
    • Bank Brussels Lambert (UK) Limited
    Transacciones
    • 04 nov 1980Registro de una carga
    Assignment
    Creado el 30 oct 1980
    Entregado el 04 nov 1980
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    Further securing the moneis secured by on assignment dated 4TH july 1980
    Breve descripción
    Lease as set out in the schedule to the assignment.
    Personas con derecho
    • Bank Brussels Lanmbert (UK) Limited
    Transacciones
    • 04 nov 1980Registro de una carga
    Supplementad mortgage
    Creado el 11 oct 1980
    Entregado el 15 oct 1980
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    Further securing the monies secured by a mortgage dated 4 july 1980
    Breve descripción
    The equipment descibed in the leases as set out in the schedule to the supplemental mortgage.
    Personas con derecho
    • Bank Brussels Lambert (UK) Limited
    Transacciones
    • 15 oct 1980Registro de una carga
    Assignment
    Creado el 11 oct 1980
    Entregado el 15 oct 1980
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    Further securing the monies secured by an assignment dated 4 july 1980
    Breve descripción
    Leases as set out in the schedule to the assignment.
    Personas con derecho
    • Bank Brussels Lambert (UK) Limited
    Transacciones
    • 15 oct 1980Registro de una carga
    Suplemental mortgage & assignment
    Creado el 19 sept 1980
    Entregado el 23 sept 1980
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    For securing all monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a charge dated 4 july 1980
    Breve descripción
    Leases as set out in the schedule to thesupplemental mortgage.
    Personas con derecho
    • Bank Brussels Lambert (UK) Limited
    Transacciones
    • 23 sept 1980Registro de una carga
    Suplemental mortgage & assignment
    Creado el 01 sept 1980
    Entregado el 02 sept 1980
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    For securing all monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of an assignment dated 4JULY 1980
    Breve descripción
    28 leases as set out in the schedule to the supplementa assignment.
    Personas con derecho
    • Bank Brussels Lambert (UK) Limited
    Transacciones
    • 02 sept 1980Registro de una carga
    Supplemental mortgage
    Creado el 01 sept 1980
    Entregado el 02 sept 1980
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    For securing all monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a chrge dated 4 july 1980
    Breve descripción
    Equipment as set out in schedule to supplemental mortgage.
    Personas con derecho
    • Bank Brussels Lambert (UK) Limited
    Transacciones
    • 02 sept 1980Registro de una carga
    Mortgage
    Creado el 04 jul 1980
    Entregado el 15 jul 1980
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a facility letter dated 3-6-80
    Breve descripción
    Radiophone equipment as described in the schedule.
    Personas con derecho
    • Bank Brussels Lambert (UK) Limited
    Transacciones
    • 15 jul 1980Registro de una carga
    Deed of assignment
    Creado el 04 jul 1980
    Entregado el 15 jul 1980
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a facility letter dated 3-6-80
    Breve descripción
    All rights and interests udner leases of radiophone equipment.
    Personas con derecho
    • Bank Brussels Lambert (UK) Limited
    Transacciones
    • 15 jul 1980Registro de una carga

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0