HILLSDOWN AMBIENT FOODS GROUP LIMITED

HILLSDOWN AMBIENT FOODS GROUP LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaHILLSDOWN AMBIENT FOODS GROUP LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 01220754
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de HILLSDOWN AMBIENT FOODS GROUP LIMITED?

    • Actividades de oficinas centrales (70100) / Actividades profesionales, científicas y técnicas

    ¿Dónde se encuentra HILLSDOWN AMBIENT FOODS GROUP LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Premier House
    Centrium Business Park
    AL1 2RE Griffiths Way, St. Albans
    Hertfordshire
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de HILLSDOWN AMBIENT FOODS GROUP LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    H.L. FOODS LIMITED01 feb 199101 feb 1991
    HILLSDOWN LIMITED25 jul 197525 jul 1975

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de HILLSDOWN AMBIENT FOODS GROUP LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2013

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para HILLSDOWN AMBIENT FOODS GROUP LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    La acción de exclusión voluntaria ha sido suspendida

    1 páginasSOAS(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Cese del nombramiento de Jim Hepburn como director el 05 abr 2015

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mr Simon Nicholas Wilbraham como director el 05 abr 2015

    2 páginasAP01

    La acción de exclusión voluntaria ha sido suspendida

    1 páginasSOAS(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    GAZ1(A)

    Nombramiento de Mr Duncan Neil Leggett como director el 12 ene 2015

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Emmett Mcevoy como director el 12 ene 2015

    1 páginasTM01

    Cancelación total de la carga 012207540019

    4 páginasMR04

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    legacy

    1 páginasSH20

    Estado de capital el 15 dic 2014

    • Capital: GBP 1
    4 páginasSH19

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Resoluciones

    Resolutions
    RESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resolución de reducción del capital social emitido

    RES06

    Déclaration annuelle établie au 15 sept 2014 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital30 sept 2014

    Estado de capital el 30 sept 2014

    • Capital: GBP 21,822,100
    SH01

    Exercice comptable en cours prolongé du 31 dic 2014 au 31 mar 2015

    1 páginasAA01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2013

    14 páginasAA

    Cancelación total de la carga 12

    4 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 13

    4 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 17

    4 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 16

    4 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 18

    4 páginasMR04

    Registro de la carga 012207540019

    188 páginasMR01

    Déclaration annuelle établie au 15 sept 2013 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital16 sept 2013

    Estado de capital el 16 sept 2013

    • Capital: GBP 21,822,100
    SH01

    ¿Quiénes son los directivos de HILLSDOWN AMBIENT FOODS GROUP LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    WILBRAHAM, Simon Nicholas
    Premier House
    Centrium Business Park
    AL1 2RE Griffiths Way, St. Albans
    Hertfordshire
    Secretario
    Premier House
    Centrium Business Park
    AL1 2RE Griffiths Way, St. Albans
    Hertfordshire
    British125719290002
    LEGGETT, Duncan Neil
    Premier House
    Centrium Business Park
    AL1 2RE Griffiths Way, St. Albans
    Hertfordshire
    Director
    Premier House
    Centrium Business Park
    AL1 2RE Griffiths Way, St. Albans
    Hertfordshire
    United KingdomBritish194179970001
    MCDONALD, Andrew John
    Premier House
    Centrium Business Park
    AL1 2RE Griffiths Way, St. Albans
    Hertfordshire
    Director
    Premier House
    Centrium Business Park
    AL1 2RE Griffiths Way, St. Albans
    Hertfordshire
    EnglandBritish164670820001
    WILBRAHAM, Simon Nicholas
    Premier House
    Centrium Business Park
    AL1 2RE Griffiths Way, St. Albans
    Hertfordshire
    Director
    Premier House
    Centrium Business Park
    AL1 2RE Griffiths Way, St. Albans
    Hertfordshire
    EnglandBritish125719290002
    HINES, Christine Anne
    33 Sandhills Road
    Barnt Green
    B45 8NP Birmingham
    Secretario
    33 Sandhills Road
    Barnt Green
    B45 8NP Birmingham
    British27217290001
    HUNT, Barry Thomas
    Barmadel Gorefield Road
    Leverington
    PE13 5BB Wisbech
    Cambridgeshire
    England
    Secretario
    Barmadel Gorefield Road
    Leverington
    PE13 5BB Wisbech
    Cambridgeshire
    England
    British142070001
    MACKEE, Stephen Patrick
    101 Gayton Road
    PE30 4EW Kings Lynn
    Norfolk
    Secretario
    101 Gayton Road
    PE30 4EW Kings Lynn
    Norfolk
    British29126720002
    BOWEN, Charles John
    Isington Mill
    GU34 4PW Alton
    Hants
    Director
    Isington Mill
    GU34 4PW Alton
    Hants
    British801170002
    CAMPBELL, Rosalind Ilona
    6 Hawthorn Close
    WD17 4SB Watford
    Hertfordshire
    Director
    6 Hawthorn Close
    WD17 4SB Watford
    Hertfordshire
    British58191970001
    CLARE, Nigel John Richard
    The Tower House
    Danesfield
    SL7 2EU Marlow
    Buckinghamshire
    Director
    The Tower House
    Danesfield
    SL7 2EU Marlow
    Buckinghamshire
    British79912700001
    DE BAKKER, Cornelis Gerardus
    Sparrenlaan 15
    3735 Mx
    FOREIGN Bosch En Duin
    Netherlands
    Director
    Sparrenlaan 15
    3735 Mx
    FOREIGN Bosch En Duin
    Netherlands
    Dutch38672120002
    GARDENER, Nigel William
    4 Sudeley Drive
    South Cerney
    GL7 5XN Cirencester
    Gloucestershire
    Director
    4 Sudeley Drive
    South Cerney
    GL7 5XN Cirencester
    Gloucestershire
    British52911930001
    HEPBURN, Jim
    Premier House
    Centrium Business Park
    AL1 2RE Griffiths Way, St. Albans
    Hertfordshire
    Director
    Premier House
    Centrium Business Park
    AL1 2RE Griffiths Way, St. Albans
    Hertfordshire
    ScotlandScottish162125080001
    HINES, Christine Anne
    33 Sandhills Road
    Barnt Green
    B45 8NP Birmingham
    Director
    33 Sandhills Road
    Barnt Green
    B45 8NP Birmingham
    British27217290001
    HUNT, Barry Thomas
    Barmadel Gorefield Road
    Leverington
    PE13 5BB Wisbech
    Cambridgeshire
    England
    Director
    Barmadel Gorefield Road
    Leverington
    PE13 5BB Wisbech
    Cambridgeshire
    England
    British142070001
    LAND, Sian Louise
    11 Clover Drive
    Pickmere
    WA16 0WF Knutsford
    Cheshire
    Director
    11 Clover Drive
    Pickmere
    WA16 0WF Knutsford
    Cheshire
    United KingdomBritish86278210001
    LAPEYRE, Bernard
    3 Chemin Neuf
    69570 Dardilly
    Director
    3 Chemin Neuf
    69570 Dardilly
    French40996690001
    LEACH, Paul Alan
    Station Road
    Bletchingdon
    OX5 3DE Kidlington
    8
    Oxfordshire
    United Kingdom
    Director
    Station Road
    Bletchingdon
    OX5 3DE Kidlington
    8
    Oxfordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish136797430001
    LEACH, Paul Alan
    20 Malvern Road
    SL6 7RH Maidenhead
    Berkshire
    Director
    20 Malvern Road
    SL6 7RH Maidenhead
    Berkshire
    British60788330001
    LILLINGTON, Keith William
    The Old Bowling Green
    Broad Lane Moulton Chapel
    PE12 6PN Spalding
    Lincolnshire
    Director
    The Old Bowling Green
    Broad Lane Moulton Chapel
    PE12 6PN Spalding
    Lincolnshire
    British803140001
    LYONS, Colim Fionbar
    14 Carrickbrack Heath
    Sutton
    IRISH Dublin
    Director
    14 Carrickbrack Heath
    Sutton
    IRISH Dublin
    British32152010001
    MACKEE, Stephen Patrick
    101 Gayton Road
    PE30 4EW Kings Lynn
    Norfolk
    Director
    101 Gayton Road
    PE30 4EW Kings Lynn
    Norfolk
    United KingdomBritish29126720002
    MCEVOY, Emmett
    Premier House
    Centrium Business Park
    AL1 2RE Griffiths Way, St. Albans
    Hertfordshire
    Director
    Premier House
    Centrium Business Park
    AL1 2RE Griffiths Way, St. Albans
    Hertfordshire
    United KingdomIrish168590540001
    NICHOLS, John Ellis
    353 Hills Road
    CB2 2QT Cambridge
    Cambridgeshire
    Director
    353 Hills Road
    CB2 2QT Cambridge
    Cambridgeshire
    British7351450001
    O'NEILL, Anthony Christopher
    1 Ballyhannon Lane
    Portadown
    BT63 5YF County Armagh
    Northern Ireland
    Director
    1 Ballyhannon Lane
    Portadown
    BT63 5YF County Armagh
    Northern Ireland
    Northern IrelandBritish146393340001
    ORCHARD, Stephen William
    The Orchards
    Meadow Lane Houghton
    PE17 2BP Huntingdon
    Cambridgeshire
    Director
    The Orchards
    Meadow Lane Houghton
    PE17 2BP Huntingdon
    Cambridgeshire
    EnglandBritish36964770001
    PEELER, Andrew Michael
    Premier House
    Centrium Business Park
    AL1 2RE Griffiths Way, St. Albans
    Hertfordshire
    Director
    Premier House
    Centrium Business Park
    AL1 2RE Griffiths Way, St. Albans
    Hertfordshire
    United KingdomBritish87359710001
    RITCHIE, Alexander George Malcolm
    Orchard House 29 Burwell Road
    Reach
    CB5 0JH Cambridge
    Cambridgeshire
    Director
    Orchard House 29 Burwell Road
    Reach
    CB5 0JH Cambridge
    Cambridgeshire
    British144538120001
    ROSEN, Andrew Scott
    60 Karens Lane
    NJ 07632 Englewood Cliffs
    Usa
    Director
    60 Karens Lane
    NJ 07632 Englewood Cliffs
    Usa
    American64268220002
    SCHOFIELD, Robert John
    Hunterswood
    Saint Johns Road
    HP15 7QS Hazlemere
    Buckinghamshire
    Director
    Hunterswood
    Saint Johns Road
    HP15 7QS Hazlemere
    Buckinghamshire
    British80018490001
    SIMPSON, Edward Thomas Stephen
    Tilson House 64 Station Road
    Long Sutton
    PE12 9BS Spalding
    Lincolnshire
    Director
    Tilson House 64 Station Road
    Long Sutton
    PE12 9BS Spalding
    Lincolnshire
    British7350120001
    SMITH, Antony David
    Centrium Business Park
    Griffiths Way
    AL1 2RE St Albans
    Premier House
    Hertfordshire
    Director
    Centrium Business Park
    Griffiths Way
    AL1 2RE St Albans
    Premier House
    Hertfordshire
    United KingdomBritish147725160001
    SOLOMON, Harry, Sir
    7 Inverforth House
    North End Way
    NW3 7EU London
    Director
    7 Inverforth House
    North End Way
    NW3 7EU London
    United KingdomBritish59789810004
    THOMAS, Paul
    Gladwyn House 5 Victoria Crescent
    Sherwood
    NG5 4DA Nottingham
    Nottinghamshire
    Director
    Gladwyn House 5 Victoria Crescent
    Sherwood
    NG5 4DA Nottingham
    Nottinghamshire
    British29218800002
    TYLEY, Gwynfor Paul
    12 Prospect Road
    AL1 2AX St. Albans
    Hertfordshire
    Director
    12 Prospect Road
    AL1 2AX St. Albans
    Hertfordshire
    EnglandBritish66169120001

    ¿Tiene HILLSDOWN AMBIENT FOODS GROUP LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    A registered charge
    Creado el 14 abr 2014
    Entregado el 17 abr 2014
    Satisfecho en su totalidad
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía flotante:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Hsbc Corporate Trustee Company (UK) Limited (as Agent and Trustee for the Senior Secured Creditors)
    Transacciones
    • 17 abr 2014Registro de una carga (MR01)
    • 14 ene 2015Satisfacción de una carga (MR04)
    An english law security agreement
    Creado el 30 mar 2012
    Entregado el 04 abr 2012
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from each obligor to any expanded secured party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    By way of first fixed charge all rights in respect of key brand ipr including any interest by way of licence in any such key brand ipr by way of first legal mortgage all the shares see image for full details.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Bank PLC as Agent and Trustee for the Expanded Secured Parties (The Security Trustee)
    Transacciones
    • 04 abr 2012Registro de un cargo (MG01)
    • 02 may 2014Satisfacción de una carga (MR04)
    Supplemental security agreement
    Creado el 30 mar 2012
    Entregado el 04 abr 2012
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from each obligor to any expanded secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    All the additional shares. See image for full details.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Bank PLC, as Agent and Trustee for the Expanded Secured Parties (The Security Trustee)
    Transacciones
    • 04 abr 2012Registro de un cargo (MG01)
    • 02 may 2014Satisfacción de una carga (MR04)
    A security agreement
    Creado el 27 mar 2009
    Entregado el 03 abr 2009
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from each obligor to any expanded secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    The real property all buildings fixtures and fittings (for details of properties charged please refer to the form 395) all the shares owned and first floating charge against all assets not at any time otherwise effectively mortgage charged or assigned under the deed see image for full details.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Bank PLC (The Security Trustee)
    Transacciones
    • 03 abr 2009Registro de un cargo (395)
    • 02 may 2014Satisfacción de una carga (MR04)
    A security agreement
    Creado el 12 ene 2009
    Entregado el 22 ene 2009
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from each obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    First fixed charge the real property land lying to the south of bridge road, long sutton and land lying to the south of bridge road, long sutton t/n's LL294571 and LL294436 all buildings fixtures and fittings plant and machinery the benefit of any covenants intellectual property a first floating charge all its assets. See image for full details.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC as Agent and Trustee for the Finance Parties (The Security Trustee)
    Transacciones
    • 22 ene 2009Registro de un cargo (395)
    • 06 abr 2009Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Group debenture
    Creado el 28 feb 2008
    Entregado el 10 mar 2008
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Floating charge over the undertaking and all property and assets see image for full details.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC (As Security Trustee for the Finance Parties)
    Transacciones
    • 10 mar 2008Registro de un cargo (395)
    • 18 feb 2009Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Group debenture
    Creado el 16 mar 2007
    Entregado el 03 abr 2007
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Floating charge its undertaking and allits property, assets and rights whatsoever and wheresoever both present and future, including any of its property and as. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transacciones
    • 03 abr 2007Registro de un cargo (395)
    • 02 may 2014Satisfacción de una carga (MR04)
    Security over shares
    Creado el 16 mar 2007
    Entregado el 03 abr 2007
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    All shares owned and related rights. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transacciones
    • 03 abr 2007Registro de un cargo (395)
    • 02 may 2014Satisfacción de una carga (MR04)
    Group debenture
    Creado el 06 jun 2005
    Entregado el 13 jun 2005
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Floating charge its undertaking and all its property, assets and rights whatsoever and wheresoever both present and future, including any of its property and assets;. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transacciones
    • 13 jun 2005Registro de un cargo (395)
    • 03 nov 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Group debenture
    Creado el 16 ago 2004
    Entregado el 27 ago 2004
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    F/H property at glenthorn farm whittlesey road march cambridge t/no CB231846, f/h land and buildings on the east and west sides of marriott way melton constable t/nos NK243931 & NK239582, f/h land on the north west side of fenton way slade end chatteris and land lying to the north east of A142 chatteris and land lying to the east of the A141 chatteris t/nos CB207119, CB198960 and CB198959. For details of further properties charged please refer to form 395.. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • J.P. Morgan Europe Limited Acting as Security Trustee for the Secured Parties
    Transacciones
    • 27 ago 2004Registro de un cargo (395)
    • 07 jul 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Group debenture
    Creado el 26 nov 2003
    Entregado el 15 dic 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • J.P. Morgan Europe Limited Acting as Security Agent for the Finance Parties
    Transacciones
    • 15 dic 2003Registro de un cargo (395)
    • 27 may 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Deed of pledge
    Creado el 26 nov 2003
    Entregado el 09 dic 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    The existing shares the further shares and all other rights assets or property (including dividends and all other distributions and bonus or scrip rights). See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • J.P. Morgan Europe Limited
    Transacciones
    • 09 dic 2003Registro de un cargo (395)
    • 27 may 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    A standard security dated 07/10/99 which was presented for registration in scotland on 13/10/99
    Creado el 13 oct 1999
    Entregado el 19 oct 1999
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and hl foods limited to the chargee under the finance documents
    Breve descripción
    Property k/a that area or piece of ground lying to the south of the loch of forfar in the royal burgh and parish of forfar and county of angus extending to 4.77 acres or thereby but excepting therefrom that plot or area of ground extending to 0.005 acres and that area or piece of ground extending to 2,725 square metres at orchardbank industrial estate forfar in the county of angus.
    Personas con derecho
    • Chase Manhattan International Limited as Agent and Security Agent for and on Behalf of Thefinance Parties (As Defined)
    Transacciones
    • 19 oct 1999Registro de un cargo (395)
    • 28 nov 2000Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Creado el 10 ago 1999
    Entregado el 26 ago 1999
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All moneys, obligations and liabilities due or to become due from the company and/or each obligor company (as defined) to the chargee and/or the finance parties or any of them under or pursuant to the finance documents (as defined) on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Chase Manhattan International Limited Acting as Security Agent for the Finance Parties Pursuantto the Facilities Agreement
    Transacciones
    • 26 ago 1999Registro de un cargo (395)
    • 28 nov 2000Declaración de que parte o la totalidad de la propiedad de una carga flotante ha sido liberada (403b)
    • 27 may 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Deed of pledge
    Creado el 10 ago 1999
    Entregado el 24 ago 1999
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to the finance documents and/or any deed or documents supplemental thereto
    Breve descripción
    Pledges the existing shares or further shares and any other secured assets. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Chase Manhattan International Limited
    Transacciones
    • 24 ago 1999Registro de un cargo (395)
    • 27 may 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Standard security
    Creado el 24 ago 1981
    Entregado el 28 ago 1981
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a personal bond
    Breve descripción
    1. 4. 77 acres and 0.817 acres part of orchard bank ind.site forfar. Angus 2. 55 glamis rd, forfar. Angus 3. briar cottage glamis rd forfar angus.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 28 ago 1981Registro de una carga
    • 26 feb 1994Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 11 ago 1981
    Entregado el 11 ago 1981
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    F/H lockwood canning factory, long sutton, lincs. About 4 acres, 1936 sq. Yds at sutton bridge, lincs. Adderley house, long sutton, lincs. Land & buildings at bull lane, long sutton, lincs.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 11 ago 1981Registro de una carga
    Legal charge
    Creado el 11 ago 1981
    Entregado el 11 ago 1981
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    F/H 4 acres adjoining canning factory at long sutton, lincs.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 11 ago 1981Registro de una carga
    Legal charge
    Creado el 28 jul 1981
    Entregado el 11 ago 1981
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    F/H 5 acres adjoining canning factory at long sutton, lincs.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 11 ago 1981Registro de una carga

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0