NORTH SHOE LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaNORTH SHOE LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 01223702
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de NORTH SHOE LIMITED?

    • Compañía no comercial (74990) / Actividades profesionales, científicas y técnicas

    ¿Dónde se encuentra NORTH SHOE LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Trident Business Park
    Leeds Road
    HD2 1UA Huddersfield
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de NORTH SHOE LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    BROWN & JACKSON (RETAIL) LIMITED08 oct 198708 oct 1987
    BROWN & JACKSON (DEVELOPMENTS) LIMITED21 ago 197521 ago 1975

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de NORTH SHOE LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 mar 2016

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para NORTH SHOE LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Declaración de confirmación presentada el 01 oct 2017 con actualizaciones

    4 páginasCS01

    legacy

    1 páginasSH20

    Estado de capital el 08 ago 2017

    • Capital: GBP 1
    3 páginasSH19

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resolución de reducción del capital social emitido

    RES06

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2016

    7 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 01 oct 2016 con actualizaciones

    5 páginasCS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2015

    7 páginasAA

    Nombramiento de Mr Hemant Patel como director el 27 nov 2015

    3 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Ian York como director el 27 nov 2015

    2 páginasTM01

    Déclaration annuelle établie au 01 oct 2015 avec liste complète des actionnaires

    14 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital19 nov 2015

    Estado de capital el 19 nov 2015

    • Capital: GBP 1,000,000
    SH01

    Nombramiento de Ian York como director el 25 mar 2015

    AP01

    Cese del nombramiento de Roy George Ellis como director el 25 mar 2015

    2 páginasTM01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2014

    6 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 01 oct 2014 avec liste complète des actionnaires

    14 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital13 oct 2014

    Estado de capital el 13 oct 2014

    • Capital: GBP 1,000,000
    SH01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2013

    7 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 01 oct 2013 avec liste complète des actionnaires

    14 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital19 nov 2013

    Estado de capital el 19 nov 2013

    • Capital: GBP 1,000,000
    SH01

    Cambio de datos del director Mr Abdul Aziz Tayub el 23 may 2013

    3 páginasCH01

    Nombramiento de Mr Roy George Ellis como director

    3 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Ebrahim Suleman como director

    2 páginasTM01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2012

    7 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 01 oct 2012 avec liste complète des actionnaires

    14 páginasAR01

    ¿Quiénes son los directivos de NORTH SHOE LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    COLLINSON, Martin Donald
    1 Badger Gate
    Meltham
    HD9 5LB Holmfirth
    Secretario
    1 Badger Gate
    Meltham
    HD9 5LB Holmfirth
    British98796330005
    PATEL, Hemant
    Leeds Road
    HD2 1UA Huddersfield
    Trident Business Park
    United Kingdom
    Director
    Leeds Road
    HD2 1UA Huddersfield
    Trident Business Park
    United Kingdom
    EnglandBritish104124100001
    TAYUB, Abdul Aziz
    Leeds Road
    HD2 1UA Huddersfield
    Trident Business Park
    United Kingdom
    Director
    Leeds Road
    HD2 1UA Huddersfield
    Trident Business Park
    United Kingdom
    EnglandBritish16280660001
    KEMP, Helen Anne
    5 Birch Mews Oaklands Manor
    Long Causeway Adel
    LS16 8NX Leeds
    West Yorkshire
    Secretario
    5 Birch Mews Oaklands Manor
    Long Causeway Adel
    LS16 8NX Leeds
    West Yorkshire
    British48922660002
    KERRISON, Michael Arthur
    57 Welldon Crescent
    HA1 1QP Harrow
    Middlesex
    Secretario
    57 Welldon Crescent
    HA1 1QP Harrow
    Middlesex
    British1452630001
    LETHAM, Ian Ritchie
    45 Palin Wood Road
    Delph
    OL3 5UW Oldham
    Lancashire
    Secretario
    45 Palin Wood Road
    Delph
    OL3 5UW Oldham
    Lancashire
    British9252900001
    ROELOFSE, Hendrik
    18 Woodlands Green
    HG2 8QD Harrogate
    North Yorkshire
    Secretario
    18 Woodlands Green
    HG2 8QD Harrogate
    North Yorkshire
    South African40527920003
    SISSON, Hamish Paul
    20 Park View Court
    29 Street Lane
    LS8 1BS Leeds
    West Yorkshire
    Secretario
    20 Park View Court
    29 Street Lane
    LS8 1BS Leeds
    West Yorkshire
    British43874820001
    BROWN, Gary James
    3 Dewberry Fields
    Upholland
    WN8 0BQ Skelmersdale
    Lancashire
    Director
    3 Dewberry Fields
    Upholland
    WN8 0BQ Skelmersdale
    Lancashire
    EnglandBritish125196870001
    BURDON, Peter
    40 Firs Road
    Edwalton
    NG12 4BX Nottingham
    Director
    40 Firs Road
    Edwalton
    NG12 4BX Nottingham
    British70178470002
    CLARKE, Paul
    74 Barons Close
    Kirby Muxloe
    LE9 2BW Leicester
    Leicestershire
    Director
    74 Barons Close
    Kirby Muxloe
    LE9 2BW Leicester
    Leicestershire
    British103719400001
    ELLIS, Robert Keith
    55 Bushy Park Road
    TW11 9DQ Teddington
    Middlesex
    Director
    55 Bushy Park Road
    TW11 9DQ Teddington
    Middlesex
    EnglandBritish45171010001
    ELLIS, Roy George
    Leeds Road
    HD2 1UA Huddersfield
    Trident Business Park
    United Kingdom
    Director
    Leeds Road
    HD2 1UA Huddersfield
    Trident Business Park
    United Kingdom
    WalesBritish161784490001
    GRAY, Ian
    Flat 48 Langtons Wharf
    LS2 7EN Leeds
    Yorkshire
    Director
    Flat 48 Langtons Wharf
    LS2 7EN Leeds
    Yorkshire
    British50246030002
    HAUGHTON, Townsend Andrew
    Staddlestones
    11 Oakdale Manor
    HG1 2NA Harrogate
    North Yorkshire
    Director
    Staddlestones
    11 Oakdale Manor
    HG1 2NA Harrogate
    North Yorkshire
    South Africa39356840002
    KERRISON, Michael Arthur
    57 Welldon Crescent
    HA1 1QP Harrow
    Middlesex
    Director
    57 Welldon Crescent
    HA1 1QP Harrow
    Middlesex
    British1452630001
    ROELOFSE, Hendrik
    18 Woodlands Green
    HG2 8QD Harrogate
    North Yorkshire
    Director
    18 Woodlands Green
    HG2 8QD Harrogate
    North Yorkshire
    South African40527920003
    SMITH, Martin Freeman
    84 Pendle Gardens
    Culcheth
    WA3 4LU Warrington
    Director
    84 Pendle Gardens
    Culcheth
    WA3 4LU Warrington
    British44140230002
    SULEMAN, Ebrahim
    8 St Marys Avenue
    WF17 7PT Batley
    West Yorkshire
    Director
    8 St Marys Avenue
    WF17 7PT Batley
    West Yorkshire
    EnglandBritish52733940001
    VISSER, Johan Jacobus
    22 Mackenzie Gardens
    East Kilbride
    G74 4SA Glasgow
    Lanarkshire
    Director
    22 Mackenzie Gardens
    East Kilbride
    G74 4SA Glasgow
    Lanarkshire
    South African51820380002
    YORK, Ian
    Leeds Road
    HD2 1UA Huddersfield
    Trident Business Park
    United Kingdom
    Director
    Leeds Road
    HD2 1UA Huddersfield
    Trident Business Park
    United Kingdom
    EnglandBritish197002910001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de NORTH SHOE LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Instore Limited
    Leeds Road
    HD2 1UA Huddersfield
    Trident Business Park
    United Kingdom
    06 abr 2016
    Leeds Road
    HD2 1UA Huddersfield
    Trident Business Park
    United Kingdom
    No
    Forma jurídicaLimited Company
    País de registroEngland
    Autoridad legalCompanies Act 2006
    Lugar de registroEngland & Wales
    Número de registro00347453
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.

    ¿Tiene NORTH SHOE LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Debenture
    Creado el 28 mar 1996
    Entregado el 17 abr 1996
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee as trustee for the beneficiaries (as therein defined) under or pursuant to the guarantee (as therein defined) and the expenses (as therein defined) (provided that any expenses incurred prior to an enforcement event (as therein defined) shall be consented to by poundstretcher limited and interest (as therein defined)
    Breve descripción
    The property as described on the form 395 and. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Nedcor Bank Limited
    Transacciones
    • 17 abr 1996Registro de un cargo (395)
    • 26 mar 1998Declaración de que parte o la totalidad de la propiedad de una carga flotante ha sido liberada (403b)
    • 08 may 2000Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 03 jun 1994
    Entregado el 15 jun 1994
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • B & J Holdings
    Transacciones
    • 15 jun 1994Registro de un cargo (395)
    • 04 jul 1996Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Guarantee and debenture
    Creado el 10 ene 1992
    Entregado el 24 ene 1992
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the terms of each or any of the finance documents (as defined) or otherwise
    Breve descripción
    See form 395 ref M26C for full details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Midland Bank Plcthe "Security Agent" and the "Banks"
    Transacciones
    • 24 ene 1992Registro de un cargo (395)
    • 22 jul 1994Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Charge
    Creado el 27 jun 1991
    Entregado el 03 jul 1991
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed charge on all goodwill and uncalled capital and all patents patent applications, inventions, trade marks trade names, registered designs and copyrights see for details.
    Personas con derecho
    • Midland Bank PLC
    Transacciones
    • 03 jul 1991Registro de una carga
    • 22 jul 1994Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Creado el 08 mar 1989
    Entregado el 14 mar 1989
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed & floating charge on all undertaking and assets present and future including book & other debts uncalled capital.
    Personas con derecho
    • Midland Bank PLC
    Transacciones
    • 14 mar 1989Registro de una carga
    • 22 jul 1994Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Deed
    Creado el 17 jun 1982
    Entregado el 24 jun 1982
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever supplemental to a debenture dated 14.1.77
    Breve descripción
    By way of first fixed charge on all book debts and other debts of the company both present and future.
    Personas con derecho
    • Williams & Glyn's Bank PLC
    Transacciones
    • 24 jun 1982Registro de una carga
    Deposit charge & set-off agreement
    Creado el 28 ene 1982
    Entregado el 29 ene 1982
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    All monies now or at any time hereafter held or received by the said bank on behalf of the mortgagor or to its order (see doc M13).
    Personas con derecho
    • Standard Chartered Merchant Bank LTD
    Transacciones
    • 29 ene 1982Registro de una carga
    Legal charge
    Creado el 14 oct 1981
    Entregado el 15 oct 1981
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    F/H 41/43 standishgate, wigan in the county of greater manchester (see doc M12 for further details.).
    Personas con derecho
    • Standard Chartered Merchant Bank LTD
    Transacciones
    • 15 oct 1981Registro de una carga
    Legal charge
    Creado el 21 ago 1981
    Entregado el 28 ago 1981
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    L/H 516 sq. Yds together with the building erected thereon & k/a howard house broadway bradford W. yorkshire. Together with all buildings and erections thereon and all fixtures whatsoever now or at any time hereafter affixed or attached to the property or any part thereof other than trade machinery as defined by section 5 of the bills of sale act 1878.
    Personas con derecho
    • Williams & Glyn's Bank LTD
    Transacciones
    • 28 ago 1981Registro de una carga
    Legal charge
    Creado el 31 jul 1981
    Entregado el 05 ago 1981
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    F/H 50/56 deansgate and 37/47 market street, bolton, lancs.
    Personas con derecho
    • Standard Chartered Merchant Bank LTD
    Transacciones
    • 05 ago 1981Registro de una carga
    Legal charge
    Creado el 06 feb 1981
    Entregado el 19 feb 1981
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Land at junction of queen's rd & dugdale street, nuneaton, warwicks.
    Personas con derecho
    • Trade Development Bank
    Transacciones
    • 19 feb 1981Registro de una carga

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0