INDUSTRIAL SERVICES INTERNATIONAL LIMITED
Visión general
Nombre de la empresa | INDUSTRIAL SERVICES INTERNATIONAL LIMITED |
---|---|
Estado de la empresa | Disuelta |
Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
Número de empresa | 01225706 |
Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
Fecha de constitución | |
Fecha de cese |
Resumen
Tiene PSCs súper seguros | No |
---|---|
Tiene gravámenes | Sí |
Tiene historial de insolvencia | Sí |
La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de INDUSTRIAL SERVICES INTERNATIONAL LIMITED?
- Empresa inactiva (99999) / Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales
¿Dónde se encuentra INDUSTRIAL SERVICES INTERNATIONAL LIMITED?
Dirección de la sede social | 30 Finsbury Square EC2A 1AG London |
---|---|
Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de INDUSTRIAL SERVICES INTERNATIONAL LIMITED?
Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
---|---|---|
NATIONWIDE ENVIRONMENTAL SERVICES LIMITED | 01 abr 1991 | 01 abr 1991 |
WESLEYSHIRE INDUSTRIAL SERVICES LIMITED | 20 dic 1984 | 20 dic 1984 |
WESLEYSHIRE LIMITED | 09 sept 1975 | 09 sept 1975 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de INDUSTRIAL SERVICES INTERNATIONAL LIMITED?
Últimas cuentas | |
---|---|
Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2019 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para INDUSTRIAL SERVICES INTERNATIONAL LIMITED?
Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gaceta final disuelta tras la liquidación | 1 páginas | GAZ2 | ||||||||||
Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros | 9 páginas | LIQ13 | ||||||||||
La dirección de inspección del registro se ha cambiado a Level 12 the Shard 32 London Bridge Street London SE1 9SG | 2 páginas | AD02 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de , Level 12 the Shard, 32 London Bridge Street, London, SE1 9SG, England a 30 Finsbury Square London EC2A 1AG el 08 ene 2022 | 2 páginas | AD01 | ||||||||||
Declaración de solvencia | 6 páginas | LIQ01 | ||||||||||
Nombramiento de un liquidador voluntario | 3 páginas | 600 | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Estado de capital el 02 dic 2021
| 3 páginas | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 páginas | SH20 | ||||||||||
legacy | 1 páginas | CAP-SS | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 2 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Resoluciones Resolutions | 2 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Memorándum y Estatutos | 12 páginas | MA | ||||||||||
Declaración de los objetos de la sociedad | 2 páginas | CC04 | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr Jeremy Mark Williams el 19 jul 2021 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 11 jul 2021 con actualizaciones | 5 páginas | CS01 | ||||||||||
Exercice comptable précédent prolongé du 30 dic 2020 au 31 mar 2021 | 1 páginas | AA01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Jeremy Mark Williams como director el 07 abr 2021 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Modification des détails de Maclellan Integrated Services Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 01 dic 2020 | 2 páginas | PSC05 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de , Capital Tower 91 Waterloo Road, London, SE1 8RT, England a 30 Finsbury Square London EC2A 1AG el 02 dic 2020 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Richard John Butler como director el 30 nov 2020 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Miss Katherine Woods como director el 30 nov 2020 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Nombramiento de Mitie Company Secretarial Services Limited como secretario el 30 nov 2020 | 2 páginas | AP04 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Stephanie Alison Pound como secretario el 30 nov 2020 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de INDUSTRIAL SERVICES INTERNATIONAL LIMITED?
Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MITIE COMPANY SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Secretario corporativo | The Shard 32 London Bridge Street SE1 9SG London Level 12 England England |
| 148474450001 | ||||||||||
POUND, Stephanie Alison | Director | Finsbury Square EC2A 1AG London 30 | England | British | Company Secretary | 213930870002 | ||||||||
WILLIAMS, Jeremy Mark | Director | Finsbury Square EC2A 1AG London 30 | United Kingdom | British | Director | 280831530001 | ||||||||
WOODS, Katherine | Director | Finsbury Square EC2A 1AG London 30 | United Kingdom | British | Director | 237400250001 | ||||||||
BRADBURY, Trevor | Secretario | Interserve House Ruscombe Park Twyford RG10 9JU Reading Berkshire | British | Company Secretary | 47884750003 | |||||||||
BUSH, Daniel | Secretario | Interserve House Ruscombe Park Twyford RG10 9JU Reading Berkshire | 241575560001 | |||||||||||
DAVIS, Hayden Keith | Secretario | 1 Osborne B79 7SZ Tamworth Staffordshire | British | Company Secretary | 88452860001 | |||||||||
GRUNDY, David | Secretario | 12 Saint Peters Close Stonnall WS9 9EN Walsall West Midlands | British | 67582170002 | ||||||||||
MCDONALD, Andrew John | Secretario | 91 Waterloo Road SE1 8RT London Capital Tower England | 247565100001 | |||||||||||
MORROW, George Thomas Woodroofe | Secretario | Carrant Brook House Back Lane Beckford GL20 7AF Tewkesbury Glos | British | 13876540001 | ||||||||||
POUND, Stephanie Alison | Secretario | 91 Waterloo Road SE1 8RT London Capital Tower England | 250399460001 | |||||||||||
SHIPLEY, Stephen Robert | Secretario | 69 Wychwood Avenue Knowle B93 9DL Solihull West Midlands | British | 16575040001 | ||||||||||
BADCOCK, Benjamin Edward | Director | Interserve House Ruscombe Park Twyford RG10 9JU Reading Berkshire | United Kingdom | British | Accountant | 125575240001 | ||||||||
BIGGS, Malcolm John | Director | 5 Dormston Close B91 3QW Solihull West Midlands | British | Company Director | 62229630001 | |||||||||
BRADBURY, Trevor | Director | Interserve House Ruscombe Park Twyford RG10 9JU Reading Berkshire | England | British | Company Secretary | 47884750003 | ||||||||
BUSH, Daniel | Director | Interserve House Ruscombe Park Twyford RG10 9JU Reading Berkshire | England | British | Solicitor | 182845350001 | ||||||||
BUTLER, Richard John | Director | 91 Waterloo Road SE1 8RT London Capital Tower England | England | British | Finance Controller | 213849970003 | ||||||||
CLITHEROE, David Maurice | Director | 3 Norman Court Oadby LE2 4UD Leicester | British | Chartered Accountant | 49800090001 | |||||||||
CULLIFORD, John David | Director | 7 Cheveridge Close B91 3TT Solihull West Midlands | British | Director | 30684700001 | |||||||||
DAVIS, Hayden Keith | Director | 1 Osborne B79 7SZ Tamworth Staffordshire | United Kingdom | British | Accountant | 88452860001 | ||||||||
DAVIS, Paul Robert | Director | Honeyborne 25 Plymouth Road Barnt Green B45 8JF Birmingham West Midlands | British | Company Direcror | 3154980001 | |||||||||
ELLIS, John Leslie | Director | 21 Oakfields Avenue SG3 6NP Knebworth Hertfordshire | England | British | Director | 25380370003 | ||||||||
FELL, James Thomas | Director | 91 Waterloo Road SE1 8RT London Capital Tower England | England | British | Group Financial Controller | 178128810002 | ||||||||
GRUNDY, David | Director | 12 Saint Peters Close Stonnall WS9 9EN Walsall West Midlands | England | British | Director | 67582170002 | ||||||||
HOWES, Peter Frederick Andrew | Director | 23 Harvington Drive Shirley B90 4YN Solihull West Midlands | British | Director | 30050860001 | |||||||||
KENNARD, Martin Robert | Director | Dingle Wood 8 Oak Grove DY10 3AL Kidderminster Worcestershire | British | Commercial Director | 10060690002 | |||||||||
MCDONALD, Andrew John | Director | 91 Waterloo Road SE1 8RT London Capital Tower England | England | British | Company Secretary | 164670820001 | ||||||||
MORROW, George Thomas Woodroofe | Director | Carrant Brook House Back Lane Beckford GL20 7AF Tewkesbury Glos | England | British | Accountant | 13876540001 | ||||||||
OVERTON, David Anthony | Director | Blackdown 66 Tiddington Road CV37 7BA Stratford Upon Avon Warwickshire | England | British | Company Director | 38536590002 | ||||||||
SENDUR, Metin | Director | 31 Abberley Avenue DY13 0LZ Stourport On Severn Worcestershire | British | Director | 30050900001 | |||||||||
SHIPLEY, Stephen Robert | Director | 69 Wychwood Avenue Knowle B93 9DL Solihull West Midlands | England | British | Director | 16575040001 | ||||||||
STEVENTON, Brian George | Director | 4 Littleton Croft B91 3XR Solihull West Midlands | British | Director | 30050870001 | |||||||||
TAYLOR, Richard Ernest | Director | Briars Court Chapel Road RH8 0SX Oxted Surrey | British | Director | 67170590001 | |||||||||
WELLER, Lyndon Frank | Director | 37 Keswick Road B92 7PL Solihull West Midlands | British | Engineering Director | 30050890001 | |||||||||
WRAGG, Peter Graham | Director | Ibstone Cottage Grays Lane Ibstone HP14 3XX High Wycombe Buckinghamshire | British | Company Director | 37626480001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de INDUSTRIAL SERVICES INTERNATIONAL LIMITED?
Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maclellan Integrated Services Limited | 06 abr 2016 | 32 London Bridge Street SE1 9SG London Level 12. The Shard England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
|
¿Tiene INDUSTRIAL SERVICES INTERNATIONAL LIMITED alguna carga?
Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
---|---|---|---|---|
Guarantee & debenture | Creado el 25 oct 2000 Entregado el 06 nov 2000 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Debenture | Creado el 04 feb 1991 Entregado el 05 feb 1991 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Plot 8, aston fields industrial estate bromsgrove worcestershire t/no:- hw 15473SEE form 395 for details.. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Collateral debenture | Creado el 05 abr 1988 Entregado el 20 abr 1988 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the wesleyshire (holdings) limited to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Fixed charge:- l/h property k/a plot 8, aston fields industrial estate, bromsgrove, worcester t/no: hw 15473 fixed & floating charges over undertaking and all property and assets present and future including book & other debts, uncalled capital. (For full details please see form 395). | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Confirmatory charge supplemental to a mortgage debenture | Creado el 05 abr 1988 Entregado el 19 abr 1988 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee supplemenetal to a mortgage debenture d/d 2.2.83 | |
Breve descripción The property and assets of the company as charged by the said mortgage debenture. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Confirmatory charge | Creado el 11 may 1983 Entregado el 19 may 1983 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee supplemental to a legal mortgage d/d 15.3.79 | |
Breve descripción L/H property known as unit 8 aston fields industrial estate bromsgrove. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Mortgage debenture | Creado el 02 feb 1983 Entregado el 08 feb 1983 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción A specific equitable charge over the company's estate or interest in all f/h or l/h properties and/or the proceeds it sale thereof. Fixed & floating charge undertaking and see overleaf. All property and assets present and future including goodwill & book debts. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Legal mortgage | Creado el 15 mar 1979 Entregado el 30 mar 1979 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Unit 8, aston fields industrial estate, bromsgrove, hereford and worcster. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
|
¿Tiene INDUSTRIAL SERVICES INTERNATIONAL LIMITED algún caso de insolvencia?
Número de expediente | Fechas | Tipo | Profesionales | Otro | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| Liquidación voluntaria de socios |
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0