INDUSTRIAL SERVICES INTERNATIONAL LIMITED

INDUSTRIAL SERVICES INTERNATIONAL LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaINDUSTRIAL SERVICES INTERNATIONAL LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 01225706
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de INDUSTRIAL SERVICES INTERNATIONAL LIMITED?

    • Empresa inactiva (99999) / Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales

    ¿Dónde se encuentra INDUSTRIAL SERVICES INTERNATIONAL LIMITED?

    Dirección de la sede social
    30 Finsbury Square
    EC2A 1AG London
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de INDUSTRIAL SERVICES INTERNATIONAL LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    NATIONWIDE ENVIRONMENTAL SERVICES LIMITED01 abr 199101 abr 1991
    WESLEYSHIRE INDUSTRIAL SERVICES LIMITED20 dic 198420 dic 1984
    WESLEYSHIRE LIMITED09 sept 197509 sept 1975

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de INDUSTRIAL SERVICES INTERNATIONAL LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2019

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para INDUSTRIAL SERVICES INTERNATIONAL LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros

    9 páginasLIQ13

    La dirección de inspección del registro se ha cambiado a Level 12 the Shard 32 London Bridge Street London SE1 9SG

    2 páginasAD02

    Domicilio social registrado cambiado de , Level 12 the Shard, 32 London Bridge Street, London, SE1 9SG, England a 30 Finsbury Square London EC2A 1AG el 08 ene 2022

    2 páginasAD01

    Declaración de solvencia

    6 páginasLIQ01

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    3 páginas600

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    liquidation

    Acuerdo especial para la liquidación el 22 dic 2021

    LRESSP

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resoluciones

    Company business 03/12/2021
    RES13

    Estado de capital el 02 dic 2021

    • Capital: GBP 1
    3 páginasSH19

    legacy

    1 páginasSH20

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Resoluciones

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resolución de reducción del capital social emitido

    RES06

    Resoluciones

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    incorporation

    Resolución de adopción de los Artículos de Asociación

    RES01

    Memorándum y Estatutos

    12 páginasMA

    Declaración de los objetos de la sociedad

    2 páginasCC04

    Cambio de datos del director Mr Jeremy Mark Williams el 19 jul 2021

    2 páginasCH01

    Declaración de confirmación presentada el 11 jul 2021 con actualizaciones

    5 páginasCS01

    Exercice comptable précédent prolongé du 30 dic 2020 au 31 mar 2021

    1 páginasAA01

    Nombramiento de Mr Jeremy Mark Williams como director el 07 abr 2021

    2 páginasAP01

    Modification des détails de Maclellan Integrated Services Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 01 dic 2020

    2 páginasPSC05

    Domicilio social registrado cambiado de , Capital Tower 91 Waterloo Road, London, SE1 8RT, England a 30 Finsbury Square London EC2A 1AG el 02 dic 2020

    1 páginasAD01

    Cese del nombramiento de Richard John Butler como director el 30 nov 2020

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Miss Katherine Woods como director el 30 nov 2020

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Mitie Company Secretarial Services Limited como secretario el 30 nov 2020

    2 páginasAP04

    Cese del nombramiento de Stephanie Alison Pound como secretario el 30 nov 2020

    1 páginasTM02

    ¿Quiénes son los directivos de INDUSTRIAL SERVICES INTERNATIONAL LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    MITIE COMPANY SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    The Shard
    32 London Bridge Street
    SE1 9SG London
    Level 12
    England
    England
    Secretario corporativo
    The Shard
    32 London Bridge Street
    SE1 9SG London
    Level 12
    England
    England
    Tipo de identificaciónSociedad limitada del Reino Unido
    Número de registro5228356
    148474450001
    POUND, Stephanie Alison
    Finsbury Square
    EC2A 1AG London
    30
    Director
    Finsbury Square
    EC2A 1AG London
    30
    EnglandBritishCompany Secretary213930870002
    WILLIAMS, Jeremy Mark
    Finsbury Square
    EC2A 1AG London
    30
    Director
    Finsbury Square
    EC2A 1AG London
    30
    United KingdomBritishDirector280831530001
    WOODS, Katherine
    Finsbury Square
    EC2A 1AG London
    30
    Director
    Finsbury Square
    EC2A 1AG London
    30
    United KingdomBritishDirector237400250001
    BRADBURY, Trevor
    Interserve House
    Ruscombe Park Twyford
    RG10 9JU Reading
    Berkshire
    Secretario
    Interserve House
    Ruscombe Park Twyford
    RG10 9JU Reading
    Berkshire
    BritishCompany Secretary47884750003
    BUSH, Daniel
    Interserve House
    Ruscombe Park Twyford
    RG10 9JU Reading
    Berkshire
    Secretario
    Interserve House
    Ruscombe Park Twyford
    RG10 9JU Reading
    Berkshire
    241575560001
    DAVIS, Hayden Keith
    1 Osborne
    B79 7SZ Tamworth
    Staffordshire
    Secretario
    1 Osborne
    B79 7SZ Tamworth
    Staffordshire
    BritishCompany Secretary88452860001
    GRUNDY, David
    12 Saint Peters Close
    Stonnall
    WS9 9EN Walsall
    West Midlands
    Secretario
    12 Saint Peters Close
    Stonnall
    WS9 9EN Walsall
    West Midlands
    British67582170002
    MCDONALD, Andrew John
    91 Waterloo Road
    SE1 8RT London
    Capital Tower
    England
    Secretario
    91 Waterloo Road
    SE1 8RT London
    Capital Tower
    England
    247565100001
    MORROW, George Thomas Woodroofe
    Carrant Brook House
    Back Lane Beckford
    GL20 7AF Tewkesbury
    Glos
    Secretario
    Carrant Brook House
    Back Lane Beckford
    GL20 7AF Tewkesbury
    Glos
    British13876540001
    POUND, Stephanie Alison
    91 Waterloo Road
    SE1 8RT London
    Capital Tower
    England
    Secretario
    91 Waterloo Road
    SE1 8RT London
    Capital Tower
    England
    250399460001
    SHIPLEY, Stephen Robert
    69 Wychwood Avenue
    Knowle
    B93 9DL Solihull
    West Midlands
    Secretario
    69 Wychwood Avenue
    Knowle
    B93 9DL Solihull
    West Midlands
    British16575040001
    BADCOCK, Benjamin Edward
    Interserve House
    Ruscombe Park Twyford
    RG10 9JU Reading
    Berkshire
    Director
    Interserve House
    Ruscombe Park Twyford
    RG10 9JU Reading
    Berkshire
    United KingdomBritishAccountant125575240001
    BIGGS, Malcolm John
    5 Dormston Close
    B91 3QW Solihull
    West Midlands
    Director
    5 Dormston Close
    B91 3QW Solihull
    West Midlands
    BritishCompany Director62229630001
    BRADBURY, Trevor
    Interserve House
    Ruscombe Park Twyford
    RG10 9JU Reading
    Berkshire
    Director
    Interserve House
    Ruscombe Park Twyford
    RG10 9JU Reading
    Berkshire
    EnglandBritishCompany Secretary47884750003
    BUSH, Daniel
    Interserve House
    Ruscombe Park Twyford
    RG10 9JU Reading
    Berkshire
    Director
    Interserve House
    Ruscombe Park Twyford
    RG10 9JU Reading
    Berkshire
    EnglandBritishSolicitor182845350001
    BUTLER, Richard John
    91 Waterloo Road
    SE1 8RT London
    Capital Tower
    England
    Director
    91 Waterloo Road
    SE1 8RT London
    Capital Tower
    England
    EnglandBritishFinance Controller213849970003
    CLITHEROE, David Maurice
    3 Norman Court
    Oadby
    LE2 4UD Leicester
    Director
    3 Norman Court
    Oadby
    LE2 4UD Leicester
    BritishChartered Accountant49800090001
    CULLIFORD, John David
    7 Cheveridge Close
    B91 3TT Solihull
    West Midlands
    Director
    7 Cheveridge Close
    B91 3TT Solihull
    West Midlands
    BritishDirector30684700001
    DAVIS, Hayden Keith
    1 Osborne
    B79 7SZ Tamworth
    Staffordshire
    Director
    1 Osborne
    B79 7SZ Tamworth
    Staffordshire
    United KingdomBritishAccountant88452860001
    DAVIS, Paul Robert
    Honeyborne 25 Plymouth Road
    Barnt Green
    B45 8JF Birmingham
    West Midlands
    Director
    Honeyborne 25 Plymouth Road
    Barnt Green
    B45 8JF Birmingham
    West Midlands
    BritishCompany Direcror3154980001
    ELLIS, John Leslie
    21 Oakfields Avenue
    SG3 6NP Knebworth
    Hertfordshire
    Director
    21 Oakfields Avenue
    SG3 6NP Knebworth
    Hertfordshire
    EnglandBritishDirector25380370003
    FELL, James Thomas
    91 Waterloo Road
    SE1 8RT London
    Capital Tower
    England
    Director
    91 Waterloo Road
    SE1 8RT London
    Capital Tower
    England
    EnglandBritishGroup Financial Controller178128810002
    GRUNDY, David
    12 Saint Peters Close
    Stonnall
    WS9 9EN Walsall
    West Midlands
    Director
    12 Saint Peters Close
    Stonnall
    WS9 9EN Walsall
    West Midlands
    EnglandBritishDirector67582170002
    HOWES, Peter Frederick Andrew
    23 Harvington Drive
    Shirley
    B90 4YN Solihull
    West Midlands
    Director
    23 Harvington Drive
    Shirley
    B90 4YN Solihull
    West Midlands
    BritishDirector30050860001
    KENNARD, Martin Robert
    Dingle Wood 8 Oak Grove
    DY10 3AL Kidderminster
    Worcestershire
    Director
    Dingle Wood 8 Oak Grove
    DY10 3AL Kidderminster
    Worcestershire
    BritishCommercial Director10060690002
    MCDONALD, Andrew John
    91 Waterloo Road
    SE1 8RT London
    Capital Tower
    England
    Director
    91 Waterloo Road
    SE1 8RT London
    Capital Tower
    England
    EnglandBritishCompany Secretary164670820001
    MORROW, George Thomas Woodroofe
    Carrant Brook House
    Back Lane Beckford
    GL20 7AF Tewkesbury
    Glos
    Director
    Carrant Brook House
    Back Lane Beckford
    GL20 7AF Tewkesbury
    Glos
    EnglandBritishAccountant13876540001
    OVERTON, David Anthony
    Blackdown 66 Tiddington Road
    CV37 7BA Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    Director
    Blackdown 66 Tiddington Road
    CV37 7BA Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    EnglandBritishCompany Director38536590002
    SENDUR, Metin
    31 Abberley Avenue
    DY13 0LZ Stourport On Severn
    Worcestershire
    Director
    31 Abberley Avenue
    DY13 0LZ Stourport On Severn
    Worcestershire
    BritishDirector30050900001
    SHIPLEY, Stephen Robert
    69 Wychwood Avenue
    Knowle
    B93 9DL Solihull
    West Midlands
    Director
    69 Wychwood Avenue
    Knowle
    B93 9DL Solihull
    West Midlands
    EnglandBritishDirector16575040001
    STEVENTON, Brian George
    4 Littleton Croft
    B91 3XR Solihull
    West Midlands
    Director
    4 Littleton Croft
    B91 3XR Solihull
    West Midlands
    BritishDirector30050870001
    TAYLOR, Richard Ernest
    Briars Court
    Chapel Road
    RH8 0SX Oxted
    Surrey
    Director
    Briars Court
    Chapel Road
    RH8 0SX Oxted
    Surrey
    BritishDirector67170590001
    WELLER, Lyndon Frank
    37 Keswick Road
    B92 7PL Solihull
    West Midlands
    Director
    37 Keswick Road
    B92 7PL Solihull
    West Midlands
    BritishEngineering Director30050890001
    WRAGG, Peter Graham
    Ibstone Cottage Grays Lane
    Ibstone
    HP14 3XX High Wycombe
    Buckinghamshire
    Director
    Ibstone Cottage Grays Lane
    Ibstone
    HP14 3XX High Wycombe
    Buckinghamshire
    BritishCompany Director37626480001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de INDUSTRIAL SERVICES INTERNATIONAL LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Maclellan Integrated Services Limited
    32 London Bridge Street
    SE1 9SG London
    Level 12. The Shard
    England
    06 abr 2016
    32 London Bridge Street
    SE1 9SG London
    Level 12. The Shard
    England
    No
    Forma jurídicaPrivate Company Limited By Shares
    País de registroUnited Kingdom
    Autoridad legalUk Company Law
    Lugar de registroEngland
    Número de registro02185674
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.
    • La persona tiene el derecho, directa o indirectamente, de nombrar o destituir a la mayoría de la junta directiva de la empresa.

    ¿Tiene INDUSTRIAL SERVICES INTERNATIONAL LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Guarantee & debenture
    Creado el 25 oct 2000
    Entregado el 06 nov 2000
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 06 nov 2000Registro de un cargo (395)
    • 26 ene 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 04 feb 1991
    Entregado el 05 feb 1991
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Plot 8, aston fields industrial estate bromsgrove worcestershire t/no:- hw 15473SEE form 395 for details.. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 05 feb 1991Registro de una carga
    • 02 mar 1996Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Collateral debenture
    Creado el 05 abr 1988
    Entregado el 20 abr 1988
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the wesleyshire (holdings) limited to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed charge:- l/h property k/a plot 8, aston fields industrial estate, bromsgrove, worcester t/no: hw 15473 fixed & floating charges over undertaking and all property and assets present and future including book & other debts, uncalled capital. (For full details please see form 395).
    Personas con derecho
    • Investors in Industry PLC
    Transacciones
    • 20 abr 1988Registro de una carga
    Confirmatory charge supplemental to a mortgage debenture
    Creado el 05 abr 1988
    Entregado el 19 abr 1988
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee supplemenetal to a mortgage debenture d/d 2.2.83
    Breve descripción
    The property and assets of the company as charged by the said mortgage debenture.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 19 abr 1988Registro de una carga
    • 02 mar 1996Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Confirmatory charge
    Creado el 11 may 1983
    Entregado el 19 may 1983
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee supplemental to a legal mortgage d/d 15.3.79
    Breve descripción
    L/H property known as unit 8 aston fields industrial estate bromsgrove. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 19 may 1983Registro de una carga
    • 02 mar 1996Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creado el 02 feb 1983
    Entregado el 08 feb 1983
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    A specific equitable charge over the company's estate or interest in all f/h or l/h properties and/or the proceeds it sale thereof. Fixed & floating charge undertaking and see overleaf. All property and assets present and future including goodwill & book debts.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 08 feb 1983Registro de una carga
    • 02 mar 1996Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal mortgage
    Creado el 15 mar 1979
    Entregado el 30 mar 1979
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Unit 8, aston fields industrial estate, bromsgrove, hereford and worcster. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 30 mar 1979Registro de una carga
    • 02 mar 1996Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    ¿Tiene INDUSTRIAL SERVICES INTERNATIONAL LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    22 dic 2021Inicio de la liquidación
    30 abr 2023Fecha de disolución
    Liquidación voluntaria de socios
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Sean Kenneth Croston
    30 Finsbury Square
    EC2A 1AG London
    Profesional
    30 Finsbury Square
    EC2A 1AG London

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0