BRYAD DEVELOPMENTS LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | BRYAD DEVELOPMENTS LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Activa |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 01226001 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | No |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de BRYAD DEVELOPMENTS LIMITED?
- Empresa inactiva (99999) / Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales
¿Dónde se encuentra BRYAD DEVELOPMENTS LIMITED?
| Dirección de la sede social | Gate House Turnpike Road HP12 3NR High Wycombe Buckinghamshire |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles son las últimas cuentas de BRYAD DEVELOPMENTS LIMITED?
| Vencido | No |
|---|---|
| Próximas cuentas | |
| Próximo período contable finaliza el | 31 dic 2025 |
| Próximas cuentas vencen el | 30 sept 2026 |
| Últimas cuentas | |
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2024 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para BRYAD DEVELOPMENTS LIMITED?
| Última declaración de confirmación cerrada hasta | 08 nov 2026 |
|---|---|
| Próxima declaración de confirmación vence | 22 nov 2026 |
| Última declaración de confirmación | |
| Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 08 nov 2025 |
| Vencido | No |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para BRYAD DEVELOPMENTS LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Declaración de confirmación presentada el 08 nov 2025 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Nombramiento de Sara Hollowell como director el 01 oct 2025 | 2 páginas | AP01 | ||
Nombramiento de Sara Hollowell como secretario el 01 oct 2025 | 2 páginas | AP03 | ||
Cese del nombramiento de Jennifer Canty como director el 30 sept 2025 | 1 páginas | TM01 | ||
Cese del nombramiento de Jennifer Canty como secretario el 30 sept 2025 | 1 páginas | TM02 | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2024 | 5 páginas | AA | ||
Cese del nombramiento de Michael Andrew Lonnon como director el 09 dic 2024 | 1 páginas | TM01 | ||
Nombramiento de Miss Katherine Elizabeth Hindmarsh como director el 09 dic 2024 | 2 páginas | AP01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 08 nov 2024 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cese del nombramiento de Omolola Olutomilayo Adedoyin como director el 24 abr 2024 | 1 páginas | TM01 | ||
Cese del nombramiento de Omolola Olutomilayo Adedoyin como secretario el 24 abr 2024 | 1 páginas | TM02 | ||
Nombramiento de Jennifer Canty como director el 24 abr 2024 | 2 páginas | AP01 | ||
Nombramiento de Jennifer Canty como secretario el 24 abr 2024 | 2 páginas | AP03 | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2023 | 5 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 08 nov 2023 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cese del nombramiento de Katherine Elizabeth Hindmarsh como director el 19 sept 2023 | 1 páginas | TM01 | ||
Nombramiento de Mrs Omolola Olutomilayo Adedoyin como director el 19 sept 2023 | 2 páginas | AP01 | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2022 | 5 páginas | AA | ||
Nombramiento de Mrs Omolola Olutomilayo Adedoyin como secretario el 27 jun 2023 | 2 páginas | AP03 | ||
Cese del nombramiento de Katherine Elizabeth Hindmarsh como secretario el 27 jun 2023 | 1 páginas | TM02 | ||
Declaración de confirmación presentada el 08 nov 2022 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2021 | 5 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 08 nov 2021 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2020 | 5 páginas | AA | ||
Los registros se han trasladado a la ubicación de inspección registrada Highdown House Yeoman Way Worthing West Sussex BN99 3HH | 1 páginas | AD03 | ||
¿Quiénes son los directivos de BRYAD DEVELOPMENTS LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOLLOWELL, Sara | Secretario | Turnpike Road HP12 3NR High Wycombe Gate House Buckinghamshire | 340863010001 | |||||||
| HINDMARSH, Katherine Elizabeth | Director | Turnpike Road HP12 3NR High Wycombe Gate House Buckinghamshire United Kingdom | United Kingdom | British | 330353690001 | |||||
| HOLLOWELL, Sara | Director | Turnpike Road HP12 3NR High Wycombe Gate House Buckinghamshire | United Kingdom | British | 200486170001 | |||||
| ADEDOYIN, Omolola Olutomilayo | Secretario | Turnpike Road HP12 3 NR High Wycombe Gate House Bucks United Kingdom | 310643080001 | |||||||
| ALLINSON, Bernadette | Secretario | Aughton Cottage Monkey Island Lane Bray SL6 2GD Maidenhead Berkshire | British | 42217850001 | ||||||
| ATTERBURY, Karen Lorraine | Secretario | Turnpike Road HP12 3NR High Wycombe Gate House Buckinghamshire United Kingdom | 146825760001 | |||||||
| CANTY, Jennifer | Secretario | Turnpike Road HP12 3NR High Wycombe Gate House Buckinghamshire | 322288820001 | |||||||
| CARR, Peter Anthony | Secretario | South Luffenham LE15 8NP Rutland Foxfoot House | British | 130306120001 | ||||||
| CLAPHAM, Colin Richard | Secretario | Turnpike Road HP12 3NR High Wycombe Gate House Buckinghamshire United Kingdom | 165966530001 | |||||||
| CLAPHAM, Colin Richard | Secretario | Scotland Street Stoke By Nayland CO6 4QF Colchester Homestead Essex | Other | 135438270002 | ||||||
| CONFAVREUX, Andre George | Secretario | 18 Water Tower Close UB8 1XS Uxbridge Middlesex | British | 17552570001 | ||||||
| DE FEO, Caterina | Secretario | 42 The Crescent Hampton In Arden B92 0BP Solihull West Midlands | British | 58246930001 | ||||||
| DE FEO, Caterina | Secretario | 42 The Crescent Hampton In Arden B92 0BP Solihull West Midlands | British | 58246930001 | ||||||
| DENNISON, John Patrick Edmund | Secretario | 21 Linton Avenue B91 3NN Solihull West Midlands | British | 14008270001 | ||||||
| GEORGE, David Stephen | Secretario | 20 Crail Close RG11 2PZ Wokingham Berkshire | British | 6192540001 | ||||||
| HASTINGS, Jonathan Philip | Secretario | 7 Hanger Court Hanger Green W5 3ER London | British | 4733610001 | ||||||
| HINDMARSH, Katherine Elizabeth | Secretario | Turnpike Road HP12 3NR High Wycombe Gate House Buckinghamshire United Kingdom | 219943500001 | |||||||
| JORDAN, James John | Secretario | Grosvenor House 2 Church Lane NN6 6JP Stanford On Avon Northamptonshire | British | 120602100002 | ||||||
| ADEDOYIN, Omolola Olutomilayo | Director | Turnpike Road HP12 3 NR High Wycombe Gate House Bucks United Kingdom | England | British | 193735640001 | |||||
| ALLINSON, Bernadette | Director | Aughton Cottage Monkey Island Lane Bray SL6 2GD Maidenhead Berkshire | British | 42217850001 | ||||||
| ANDREW, Peter Robert | Director | Turnpike Road HP12 3NR High Wycombe Gate House Buckinghamshire United Kingdom | England | British | 113503830003 | |||||
| CANTY, Jennifer | Director | Turnpike Road HP12 3NR High Wycombe Gate House Buckinghamshire | United Kingdom | British | 322288120001 | |||||
| CARNEY, Christopher | Director | Turnpike Road HP12 3NR High Wycombe Gate House Buckinghamshire United Kingdom | United Kingdom | British | 125216670001 | |||||
| CLAPHAM, Colin Richard | Director | Turnpike Road HP12 3NR High Wycombe Gate House Buckinghamshire United Kingdom | United Kingdom | British | 9684390001 | |||||
| CONFAVREUX, Andre George | Director | 18 Water Tower Close UB8 1XS Uxbridge Middlesex | United Kingdom | British | 17552570001 | |||||
| CRAY, Jonathan Malcolm | Director | 60 Starbold Crescent Knowle B93 9JX Solihull West Midlands | England | British | 70470020001 | |||||
| DENNISON, John Patrick Edmund | Director | 21 Linton Avenue B91 3NN Solihull West Midlands | British | 14008270001 | ||||||
| GABB, Colin | Director | 23 Little Fryth RG40 3RN Wokingham Berkshire | England | British | 87309290001 | |||||
| GEORGE, David Stephen | Director | 20 Crail Close RG11 2PZ Wokingham Berkshire | British | 6192540001 | ||||||
| GRANT, Frederick | Director | 6 Sandown Avenue KT10 9NT Esher Surrey | British | 35702080001 | ||||||
| HARLEY, Stanley Martin | Director | Three Barns Loddon Drive Wargrave RG10 8HL Reading Berkshire | British | 19694730001 | ||||||
| HINDMARSH, Katherine Elizabeth | Director | Turnpike Road HP12 3NR High Wycombe Gate House Buckinghamshire United Kingdom | United Kingdom | British | 257671040002 | |||||
| LONNON, Michael Andrew, Mr. | Director | Turnpike Road HP12 3NR High Wycombe Gate House Buckinghamshire United Kingdom | United Kingdom | British | 34521340004 | |||||
| MACKENZIE, Andrew | Director | Badgers Holt Foxcombe Drive Boars Hill OX1 5DL Oxford | British | 1728940001 | ||||||
| MENZIES, Graham Reid | Director | Harcombe House 4 Lambridge Wood Road RG9 3BS Henley On Thames Oxfordshire | British | 68409800001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de BRYAD DEVELOPMENTS LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bryant Homes Southern Limited | 06 abr 2016 | Turnpike Road HP12 3NR High Wycombe Gate House Buckinghamshire United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0