CENTRE FOR MEDIEVAL AND RENAISSANCE STUDIES LIMITED

CENTRE FOR MEDIEVAL AND RENAISSANCE STUDIES LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Cuentas
  • Declaración de confirmación
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Declaraciones de personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaCENTRE FOR MEDIEVAL AND RENAISSANCE STUDIES LIMITED
    Estado de la empresaActiva
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 01234758
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de CENTRE FOR MEDIEVAL AND RENAISSANCE STUDIES LIMITED?

    • Educación superior de primer ciclo (85421) / Educación
    • Educación superior de posgrado (85422) / Educación

    ¿Dónde se encuentra CENTRE FOR MEDIEVAL AND RENAISSANCE STUDIES LIMITED?

    Dirección de la sede social
    St Michael's Hall
    Shoe Lane
    OX1 2DP Oxford
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de CENTRE FOR MEDIEVAL AND RENAISSANCE STUDIES LIMITED?

    VencidoNo
    Próximas cuentas
    Próximo período contable finaliza el31 ago 2024
    Próximas cuentas vencen el31 may 2025
    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 ago 2023

    ¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para CENTRE FOR MEDIEVAL AND RENAISSANCE STUDIES LIMITED?

    Última declaración de confirmación cerrada hasta18 jun 2025
    Próxima declaración de confirmación vence02 jul 2025
    Última declaración de confirmación
    Próxima declaración de confirmación cerrada hasta18 jun 2024
    VencidoNo

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para CENTRE FOR MEDIEVAL AND RENAISSANCE STUDIES LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Cese del nombramiento de Stephen Andrew Cooke como director el 31 oct 2024

    1 páginasTM01
    XDFP74FV

    Declaración de confirmación presentada el 18 jun 2024 sin actualizaciones

    3 páginasCS01
    XD5HZ9F6

    Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 ago 2023

    10 páginasAA
    AD26TUNM

    Declaración de confirmación presentada el 18 jun 2023 sin actualizaciones

    3 páginasCS01
    XC5ZJ6ZT

    Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 ago 2022

    11 páginasAA
    AC0HJ4AR

    Nombramiento de Professor Carlos Javier Vélez-Blasini como director el 25 ago 2022

    2 páginasAP01
    XBB4BJJS

    Cese del nombramiento de Jeffrey Wilson Cason como director el 14 jul 2022

    1 páginasTM01
    XB948ONT

    Declaración de confirmación presentada el 18 jun 2022 sin actualizaciones

    3 páginasCS01
    XB6KQW7F

    Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 ago 2021

    12 páginasAA
    AB2FN7XV

    Cambio de datos del director Prof Jeffrey Wilson Cason el 15 jun 2021

    2 páginasCH01
    XA7KW1IA

    Cambio de datos del director Professor Paul Kleber Monod el 15 jun 2021

    2 páginasCH01
    XA7KW21V

    Declaración de confirmación presentada el 18 jun 2021 con actualizaciones

    4 páginasCS01
    XA7KW38X

    Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 ago 2020

    12 páginasAA
    AA3TFO16

    Nombramiento de Mr Ian Wallace Archer como director el 18 mar 2021

    2 páginasAP01
    XA2Q0BA3

    Nombramiento de Mr Stephen Andrew Cooke como director el 18 mar 2021

    2 páginasAP01
    XA12UPEO

    Cese del nombramiento de Roger John Boden como director el 18 mar 2021

    1 páginasTM01
    XA12P7QJ

    Cese del nombramiento de Andrew Robert Thornhill como director el 06 oct 2020

    1 páginasTM01
    XA0ZX8PM

    Cese del nombramiento de John Ellis Feneley como director el 06 oct 2020

    1 páginasTM01
    X9G3HOYX

    Declaración de confirmación presentada el 18 jun 2020 sin actualizaciones

    3 páginasCS01
    X985AOV4

    Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 ago 2019

    12 páginasAA
    A96YFNMY

    Declaración de confirmación presentada el 18 jun 2019 sin actualizaciones

    3 páginasCS01
    X883QMN6

    Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 ago 2018

    13 páginasAA
    A85696E0

    Cese del nombramiento de James Calvin Davis como director el 16 abr 2019

    1 páginasTM01
    X85GFTW3

    Cese del nombramiento de James Calvin Davis como director el 16 abr 2019

    1 páginasTM01
    X85GFTZV

    Nombramiento de Professor Paul Kleber Monod como director el 16 abr 2019

    2 páginasAP01
    X84KYRLM

    ¿Quiénes son los directivos de CENTRE FOR MEDIEVAL AND RENAISSANCE STUDIES LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    ARCHER, Ian Wallace
    Parks Road
    OX1 3PG Oxford
    Keble College
    England
    Director
    Parks Road
    OX1 3PG Oxford
    Keble College
    England
    EnglandBritishUniversity Lecturer169077110001
    MONOD, Paul Kleber, Professor
    St Michael's Hall
    Shoe Lane
    OX1 2DP Oxford
    Director
    St Michael's Hall
    Shoe Lane
    OX1 2DP Oxford
    UsaUsaProfessor At Middlebury College258074240001
    VÉLEZ-BLASINI, Carlos Javier, Professor
    St Michael's Hall
    Shoe Lane
    OX1 2DP Oxford
    Director
    St Michael's Hall
    Shoe Lane
    OX1 2DP Oxford
    United StatesAmericanDean Of International Programs And Professor299447900001
    FENELEY, Sandra Jean Kathleen Mary
    Cunliffe Close
    OX2 7BL Oxford
    12
    Oxfordshire
    Secretario
    Cunliffe Close
    OX2 7BL Oxford
    12
    Oxfordshire
    Canadian14065870005
    RYLAND, Raine Jasmine
    House
    Steep Marsh
    GU32 2BB Petersfield
    Burnt Ash Farm
    Hampshire
    United Kingdom
    Secretario
    House
    Steep Marsh
    GU32 2BB Petersfield
    Burnt Ash Farm
    Hampshire
    United Kingdom
    166508430001
    BODEN, Roger John
    Flat D
    2 Northmoor Road
    OX2 6UP Oxford
    Director
    Flat D
    2 Northmoor Road
    OX2 6UP Oxford
    EnglandBritishBursar8316860003
    CASON, Jeffrey Wilson, Prof
    Sunderland Language Center 125
    VT 05753 Middlebury
    Middlebury College
    Vermont
    United States
    Director
    Sunderland Language Center 125
    VT 05753 Middlebury
    Middlebury College
    Vermont
    United States
    United StatesAmericanProvost Of Middlebury College192532010002
    COOKE, Stephen Andrew
    Parks Road
    OX1 3PG Oxford
    Keble College
    England
    Director
    Parks Road
    OX1 3PG Oxford
    Keble College
    England
    United KingdomBritishBursar246208860001
    CRAWFORD, Cynthia
    129 Battenhall Road
    WR5 2BU Worcester
    Worcestershire
    Director
    129 Battenhall Road
    WR5 2BU Worcester
    Worcestershire
    EnglandBritishDirector9806600001
    DAVIS, James Calvin, Dr
    Middlebury College
    VT 05753 Middlebury
    Munroe Hall 406
    Vermont
    United States
    Director
    Middlebury College
    VT 05753 Middlebury
    Munroe Hall 406
    Vermont
    United States
    United StatesAmericanCollege Professor198775690001
    DAVIS, James Calvin, Dr
    St Michael's Hall
    Shoe Lane
    OX1 2DP Oxford
    Director
    St Michael's Hall
    Shoe Lane
    OX1 2DP Oxford
    United StatesAmericanCollege Professor198775690001
    DINNING, William Robert John
    The Mill
    High Street
    TN16 1JA Brasted
    Kent
    Director
    The Mill
    High Street
    TN16 1JA Brasted
    Kent
    United KingdomBritishFund Manager73659590001
    FENELEY, John Ellis, Dr
    12 Cunliffe Close
    OX2 7BL Oxford
    Director
    12 Cunliffe Close
    OX2 7BL Oxford
    United KingdomBritishDirector14065880004
    FENELEY, Sandra Jean Kathleen Mary
    Cunliffe Close
    OX2 7BL Oxford
    12
    Oxfordshire
    Director
    Cunliffe Close
    OX2 7BL Oxford
    12
    Oxfordshire
    EnglandCanadianDirector14065870005
    GREEN, Richard Frederick, Dr
    Keble College
    Oxford
    Oxfordshire
    Director
    Keble College
    Oxford
    Oxfordshire
    BritishFellow Of Keble College Facelb30966620001
    HOLLIS, Adrian Swayne
    Keble College
    OX1 3PG Oxford
    Oxfordshire
    Director
    Keble College
    OX1 3PG Oxford
    Oxfordshire
    BritishCompany Director50662490001
    MONOD, Paul Kleber, Professor
    St Michael's Hall
    Shoe Lane
    OX1 2DP Oxford
    Director
    St Michael's Hall
    Shoe Lane
    OX1 2DP Oxford
    EnglandUs/UkLecturer169451130002
    RICHARDSON, George Barclay, Sir
    Wardens Lodgings
    Keble College
    OX1 3PG Oxford
    Director
    Wardens Lodgings
    Keble College
    OX1 3PG Oxford
    BritishWarden34061180001
    ROWELL, Douglas Geoffrey, The Rt Revd Dr
    Bishops Lodge
    Church Road Worth
    RH10 7RT Crawley
    West Sussex
    Director
    Bishops Lodge
    Church Road Worth
    RH10 7RT Crawley
    West Sussex
    EnglandBritishBishop45053390003
    RYLAND, Raine Jasmine
    St Michael's Hall
    Shoe Lane
    OX1 2DP Oxford
    Director
    St Michael's Hall
    Shoe Lane
    OX1 2DP Oxford
    United KingdomBritishSolicitor90859140002
    THORNHILL, Andrew Robert
    16 Bedford Row
    WC1R 4EF London
    Pump Court Tax Chambers
    England
    Director
    16 Bedford Row
    WC1R 4EF London
    Pump Court Tax Chambers
    England
    EnglandBritishBarrister154041610001
    THORNHILL, Andrew Robert
    Pump Court Chambers
    16 Bedford Row
    WC1R 4EB London
    Director
    Pump Court Chambers
    16 Bedford Row
    WC1R 4EB London
    United KingdomBritishQc14065890003
    WEITZEL, Harry John
    43557 Blake Creck Rd
    Leonardtown
    Maryland 20650
    Usa
    Director
    43557 Blake Creck Rd
    Leonardtown
    Maryland 20650
    Usa
    UsaAmericanFinancial Manager116513500001

    ¿Cuáles son las últimas declaraciones sobre personas con control significativo para CENTRE FOR MEDIEVAL AND RENAISSANCE STUDIES LIMITED?

    Declaraciones de personas con control significativo
    Notificado elCesado elDeclaración
    06 abr 2016La empresa sabe o tiene motivos razonables para creer que no existe ninguna persona registrable o entidad jurídica relevante registrable en relación con la empresa.

    ¿Tiene CENTRE FOR MEDIEVAL AND RENAISSANCE STUDIES LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Mortgage debenture
    Creado el 07 sept 2011
    Entregado el 08 sept 2011
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, plant & machinery see image for full details.
    Personas con derecho
    • Svenska Handelsbanken Ab (Publ)
    Transacciones
    • 08 sept 2011Registro de un cargo (MG01)
    Legal mortgage
    Creado el 04 dic 1995
    Entregado el 11 dic 1995
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    L/H property k/a 18C new inn hall street oxford oxfordshire t/no.ON67077 and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 11 dic 1995Registro de un cargo (395)
    • 16 feb 2008Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 05 sept 1984
    Entregado el 25 sept 1984
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    L/H st michaels hall shoe lane, oxford.
    Personas con derecho
    • British Linen Bank Limited
    Transacciones
    • 25 sept 1984Registro de una carga
    Charge
    Creado el 23 abr 1982
    Entregado el 12 may 1982
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £15,000
    Breve descripción
    St. Michael's hall shoe lane oxford. Title no:- on 56476.
    Personas con derecho
    • Benesco Limited
    Transacciones
    • 12 may 1982Registro de una carga
    • 16 feb 2008Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 23 abr 1982
    Entregado el 12 may 1982
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    F/H. property known as st. Michael's hall shoe lane oxford. Title no:- on 56476.
    Personas con derecho
    • The British Linen Bank Limited
    Transacciones
    • 12 may 1982Registro de una carga
    • 16 feb 2008Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Further charge
    Creado el 10 nov 1980
    Entregado el 11 nov 1980
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    For securing £30,000
    Breve descripción
    F/H st michael's hall shoe lane in the city of oxford. Title no. On 56476.
    Personas con derecho
    • The British Linen Bank Limited
    Transacciones
    • 11 nov 1980Registro de una carga
    Further charge
    Creado el 10 nov 1980
    Entregado el 11 nov 1980
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    For securing £15,000
    Breve descripción
    St. Michael's hall, shoe lane oxford. Title no on 56476.
    Personas con derecho
    • Benesco Limited
    Transacciones
    • 11 nov 1980Registro de una carga
    Mortgage
    Creado el 20 nov 1978
    Entregado el 27 nov 1978
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £30,000 and further advances not exceeding a maximum of £120,000
    Breve descripción
    F/H st. Michael's hall shoe lane oxford.
    Personas con derecho
    • The British Linen Bank LTD.
    Transacciones
    • 27 nov 1978Registro de una carga
    • 16 feb 2008Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0