BRACKMILLS BUILDING SUPPLIES LIMITED

BRACKMILLS BUILDING SUPPLIES LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Declaración anual
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaBRACKMILLS BUILDING SUPPLIES LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 01240464
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de BRACKMILLS BUILDING SUPPLIES LIMITED?

    • Compañía no comercial (74990) / Actividades profesionales, científicas y técnicas

    ¿Dónde se encuentra BRACKMILLS BUILDING SUPPLIES LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Parkview 1220
    Arlington Business Park Theale
    RG7 4GA Reading
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de BRACKMILLS BUILDING SUPPLIES LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    GREENHOW & WELCH LIMITED04 dic 198904 dic 1989
    GREENHOW HOLDINGS LIMITED01 dic 198601 dic 1986
    GREENHOW & WRIGHT LIMITED31 dic 197631 dic 1976

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de BRACKMILLS BUILDING SUPPLIES LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 jul 2013

    ¿Cuál es el estado de la última declaración anual para BRACKMILLS BUILDING SUPPLIES LIMITED?

    Declaración anual
    Última declaración anual

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para BRACKMILLS BUILDING SUPPLIES LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    4 páginasDS01

    legacy

    1 páginasSH20

    Estado de capital el 29 abr 2015

    • Capital: GBP 0.0002
    4 páginasSH19

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Resoluciones

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resolución de reducción del capital social emitido

    RES06

    Cambio de datos del secretario Graham Middlemiss el 16 feb 2015

    1 páginasCH03

    Déclaration annuelle établie au 06 ene 2015 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital29 ene 2015

    Estado de capital el 29 ene 2015

    • Capital: GBP 10,000
    SH01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 jul 2013

    5 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 06 ene 2014 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital09 ene 2014

    Estado de capital el 09 ene 2014

    • Capital: GBP 10,000
    SH01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 jul 2012

    5 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 06 ene 2013 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01

    Nombramiento de Graham Middlemiss como secretario

    2 páginasAP03

    Cese del nombramiento de Tom Brophy como secretario

    1 páginasTM02

    Déclaration annuelle établie au 06 ene 2012 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 jul 2011

    5 páginasAA

    Cese del nombramiento de Alison Drew como secretario

    1 páginasTM02

    Nombramiento de Tom Brophy como secretario

    1 páginasAP03

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 jul 2010

    5 páginasAA

    Resoluciones

    Resolutions
    30 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    incorporation

    Resolución del Memorándum de Asociación

    RES01

    Déclaration annuelle établie au 06 ene 2011 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01

    Cese del nombramiento de Stephen Webster como director

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mr Robert Andrew Ross Smith como director

    2 páginasAP01

    Déclaration annuelle établie au 06 ene 2010 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01

    ¿Quiénes son los directivos de BRACKMILLS BUILDING SUPPLIES LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    MIDDLEMISS, Graham
    Arlington Business Park
    Theale
    RG7 4GA Reading
    Parkview 1220
    United Kingdom
    Secretario
    Arlington Business Park
    Theale
    RG7 4GA Reading
    Parkview 1220
    United Kingdom
    174236480001
    SMITH, Robert Andrew Ross
    Arlington Business Park
    Theale
    RG7 4GA Reading
    Parkview 1220
    United Kingdom
    Director
    Arlington Business Park
    Theale
    RG7 4GA Reading
    Parkview 1220
    United Kingdom
    United KingdomBritish150753930001
    WOLSELEY DIRECTORS LIMITED
    Parkview 1220
    Arlington Business Park, Theale
    RG7 4GA Reading
    Director corporativo
    Parkview 1220
    Arlington Business Park, Theale
    RG7 4GA Reading
    122185200001
    BROPHY, Tom
    Parkview 1220
    Arlington Business Park Theale
    RG7 4GA Reading
    Secretario
    Parkview 1220
    Arlington Business Park Theale
    RG7 4GA Reading
    162215330001
    DREW, Alison
    Parkview 1220
    Arlington Business Park Theale
    RG7 4GA Reading
    Secretario
    Parkview 1220
    Arlington Business Park Theale
    RG7 4GA Reading
    British86845230002
    FITCHETT, Angela
    27 Wickery Dene
    Wootton
    NN4 6BE Northampton
    Secretario
    27 Wickery Dene
    Wootton
    NN4 6BE Northampton
    British25979740002
    PARKER, Edward Geoffrey
    The Homestead
    133 Malvern Road
    WR2 4LN Worcester
    Secretario
    The Homestead
    133 Malvern Road
    WR2 4LN Worcester
    British37378570013
    PRIEST, Mark Richard
    2 West Hill Avenue
    LS7 3QH Leeds
    West Yorkshire
    Secretario
    2 West Hill Avenue
    LS7 3QH Leeds
    West Yorkshire
    British60944350002
    WEATHERHEAD, Tina Michelle
    Glencoe
    Hollins Lane, Hampsthwaite
    HG3 2HL Harrogate
    North Yorkshire
    Secretario
    Glencoe
    Hollins Lane, Hampsthwaite
    HG3 2HL Harrogate
    North Yorkshire
    British75258960001
    WHITE, Mark Jonathan
    38 Grange Close
    Church Road Nascot Wood
    WD17 4HQ Watford
    Hertfordshire
    Secretario
    38 Grange Close
    Church Road Nascot Wood
    WD17 4HQ Watford
    Hertfordshire
    British82978250001
    BARDEN, Adrian
    1 Croxton Gardens
    PE28 0SE Catworth
    Cambridgeshire
    Director
    1 Croxton Gardens
    PE28 0SE Catworth
    Cambridgeshire
    British66429950001
    BRADLEY, David
    Hambleton Grange
    Burton Leonard
    HG3 3RX Harrogate
    North Yorkshire
    Director
    Hambleton Grange
    Burton Leonard
    HG3 3RX Harrogate
    North Yorkshire
    British65302630001
    BRANSON, David Anthony
    32 Chestnut Drive
    Shenstone
    WS14 0JH Lichfield
    Staffordshire
    Director
    32 Chestnut Drive
    Shenstone
    WS14 0JH Lichfield
    Staffordshire
    British272310001
    GREENHOW, Frederick
    Tithe Barn South Street
    Isham
    NN14 1HP Kettering
    Northamptonshire
    Director
    Tithe Barn South Street
    Isham
    NN14 1HP Kettering
    Northamptonshire
    British6180130001
    HEMMINGTON, Neil John
    41 Stourhead Drive
    East Hunsbury
    NN4 0UH Northampton
    Director
    41 Stourhead Drive
    East Hunsbury
    NN4 0UH Northampton
    British25979750001
    PARKER, Edward Geoffrey
    The Homestead
    133 Malvern Road
    WR2 4LN Worcester
    Director
    The Homestead
    133 Malvern Road
    WR2 4LN Worcester
    British37378570013
    WEBSTER, Stephen Paul
    Parkview 1220
    Arlington Business Park Theale
    RG7 4GA Reading
    Director
    Parkview 1220
    Arlington Business Park Theale
    RG7 4GA Reading
    United KingdomBritish40201730005
    WELCH, Ian
    20 Rowlandson Close
    Weston Favell
    NN3 3PB Northampton
    Northamptonshire
    Director
    20 Rowlandson Close
    Weston Favell
    NN3 3PB Northampton
    Northamptonshire
    British6246010001
    WHITE, Mark Jonathan
    Hawthorn House
    2 Wards Drive, Sarratt
    WD3 6AE Rickmansworth
    Herts
    Director
    Hawthorn House
    2 Wards Drive, Sarratt
    WD3 6AE Rickmansworth
    Herts
    EnglandBritish82978250002

    ¿Tiene BRACKMILLS BUILDING SUPPLIES LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Legal mortgage
    Creado el 04 ene 1988
    Entregado el 20 ene 1988
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Site at brackmills northampton and the proceeds of sale thereof.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 20 ene 1988Registro de una carga
    • 23 mar 1994Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal mortgage
    Creado el 08 ago 1985
    Entregado el 29 ago 1985
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    L/H property known as land in cambridge road, st. Neats in the county of cambridge and the proceeds of sale thereof.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 29 ago 1985Registro de una carga
    Legal mortgage
    Creado el 14 ene 1985
    Entregado el 15 ene 1985
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Specific equitable charge over all estates or interest in any l/h & f/h property. Specific charge over all stocks, shares, and/or other securities, all book & other debts & the proceeds of sale the goodwill & benefit of any licenes. Floating securty over its undertaking & all its property assets & rights present or future.
    Personas con derecho
    • County Bank Limited
    Transacciones
    • 15 ene 1985Registro de una carga
    Legal mortgage
    Creado el 14 ene 1985
    Entregado el 15 ene 1985
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Land & buildigs on the west side of window road bedford. T/n bd 22471. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personas con derecho
    • County Bank Limited
    Transacciones
    • 15 ene 1985Registro de una carga
    Mortgage debenture
    Creado el 07 oct 1980
    Entregado el 07 oct 1980
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Freehold property known as station yard adjacent to station road kettering northamptonshire a fixed & floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill, book debts & uncalled capital. (See doc M24 for details).
    Personas con derecho
    • County Bank Limited.
    Transacciones
    • 07 oct 1980Registro de una carga
    Legal mortgage
    Creado el 07 oct 1980
    Entregado el 07 oct 1980
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Freehold property known as station yard adjacent to station road kettering northamptonshire together with all easements rights and privileges appartment or belonging thereto.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 07 oct 1980Registro de una carga

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0