VILLIERS STREET GROUP LIMITED

VILLIERS STREET GROUP LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaVILLIERS STREET GROUP LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 01242794
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de VILLIERS STREET GROUP LIMITED?

    • (7415) /

    ¿Dónde se encuentra VILLIERS STREET GROUP LIMITED?

    Dirección de la sede social
    BAKER TILLY RESTRUCTURING AND RECOVERY LLP
    2 Whitehall Quay
    LS1 4HG Leeds
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de VILLIERS STREET GROUP LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    YUILL GROUP LIMITED08 abr 199208 abr 1992
    CECIL M. YUILL INVESTMENTS LIMITED31 dic 197631 dic 1976
    SPONTAV LIMITED03 feb 197603 feb 1976

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de VILLIERS STREET GROUP LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta02 abr 2005

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para VILLIERS STREET GROUP LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 30 nov 2011

    7 páginas4.68

    Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros

    6 páginas4.71

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 01 nov 2011

    8 páginas4.68

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 01 may 2011

    7 páginas4.68

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 01 nov 2010

    8 páginas4.68

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 01 may 2010

    11 páginas4.68

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 01 nov 2009

    7 páginas4.68

    Resoluciones

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resoluciones

    Transfer of shares 06/08/2009
    RES13

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 01 may 2009

    8 páginas4.68

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 01 nov 2008

    9 páginas4.68

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    liquidation

    Acuerdo especial para la liquidación el 02 may 2006

    LRESSP

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    1 páginas600

    Declaración de recibos y pagos del liquidador

    8 páginas4.68

    Declaración de recibos y pagos del liquidador

    6 páginas4.68

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 01 nov 2008

    6 páginas4.68

    legacy

    1 páginas287

    Declaración de recibos y pagos del liquidador

    6 páginas4.68

    Declaración de recibos y pagos del liquidador

    9 páginas4.68

    legacy

    1 páginas287

    legacy

    1 páginas287

    legacy

    1 páginas288b

    legacy

    1 páginas288b

    legacy

    1 páginas288b

    Resoluciones

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    liquidation

    Acuerdo especial para la liquidación

    LRESSP

    ¿Quiénes son los directivos de VILLIERS STREET GROUP LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    GRIEVESON, Dennis
    6 Rosebank
    Elwick Road
    TS26 9PQ Hartlepool
    Secretario
    6 Rosebank
    Elwick Road
    TS26 9PQ Hartlepool
    British2263870001
    WILSON, Patricia Margaret
    Tunstall Hall Farm
    Elwick Road
    TS26 0BH Hartlepool
    Cleveland
    Director
    Tunstall Hall Farm
    Elwick Road
    TS26 0BH Hartlepool
    Cleveland
    United KingdomBritishCompany Director2263880002
    WILSON, Stephen
    Tunstall Hall Farm
    Elwick Road
    TS26 0BH Hartlepool
    Cleveland
    Director
    Tunstall Hall Farm
    Elwick Road
    TS26 0BH Hartlepool
    Cleveland
    United KingdomBritishCompany Director99445860001
    PEGG, Andrew Michael
    58 Nunnery Lane
    DL3 9BA Darlington
    County Durham
    Secretario
    58 Nunnery Lane
    DL3 9BA Darlington
    County Durham
    BritishJoint Company Secretary50020900001
    YUILL, Hilda May
    Holly House 301 Elwick Road
    TS26 0BE Hartlepool
    Cleveland
    Secretario
    Holly House 301 Elwick Road
    TS26 0BE Hartlepool
    Cleveland
    British2399150001
    AINSLEY, Geoffrey Alexander
    6 The Orchard
    NE61 6HT Morpeth
    Northumberland
    Director
    6 The Orchard
    NE61 6HT Morpeth
    Northumberland
    United KingdomBritishBank Official Ret'D102134020001
    BARRAS, Alexander John
    10 Fairisle Close
    Oakwood
    DE21 2SJ Derby
    Director
    10 Fairisle Close
    Oakwood
    DE21 2SJ Derby
    BritishDirector39670670001
    BATES, David Christopher
    24 Norwich Road
    DH1 5QA Durham
    County Durham
    Director
    24 Norwich Road
    DH1 5QA Durham
    County Durham
    United KingdomBritishCompany Director2511130001
    BOSOMWORTH, James William
    28 Crestwood
    TS10 4NN Redcar
    Cleveland
    Director
    28 Crestwood
    TS10 4NN Redcar
    Cleveland
    BritishDirector54625700001
    CARR, Isaac Francis
    Allerton House
    Croft On Tees
    DL2 2SX Darlington
    Co Durham
    Director
    Allerton House
    Croft On Tees
    DL2 2SX Darlington
    Co Durham
    BritishDirector2433090001
    DARCY, Philip Arthur
    Leeward Bank Lane Angulon House
    Bank Lane Faceby
    TS9 7BP Middlesbrough
    Cleveland
    Director
    Leeward Bank Lane Angulon House
    Bank Lane Faceby
    TS9 7BP Middlesbrough
    Cleveland
    EnglandBritishCompany Director63284060001
    DRABBLE, Maurice Jepson
    Firbeck House Easby Lane
    Great Ayton
    TS9 6JT Middlesbrough
    Cleveland
    Director
    Firbeck House Easby Lane
    Great Ayton
    TS9 6JT Middlesbrough
    Cleveland
    BritishCompany Director2531190001
    GRIEVESON, Dennis
    6 Rosebank
    Elwick Road
    TS26 9PQ Hartlepool
    Director
    6 Rosebank
    Elwick Road
    TS26 9PQ Hartlepool
    BritishCompany Director2263870001
    HARBOTTLE, Philip Richard Milnes
    Caponscleugh House
    Allerwash
    NE47 5AB Hexham
    Northumberland
    Director
    Caponscleugh House
    Allerwash
    NE47 5AB Hexham
    Northumberland
    BritishDirector33781550001
    MCNAUGHT, David
    19 Hylton Road
    Newton Hall
    DH1 5LS Durham
    County Durham
    Director
    19 Hylton Road
    Newton Hall
    DH1 5LS Durham
    County Durham
    BritishChief Executive64253010001
    PRATELEY, Peter John
    Quarndon 15a Ladywood Road
    Four Oaks Park
    B74 2SW Sutton Coldfield
    West Midlands
    Director
    Quarndon 15a Ladywood Road
    Four Oaks Park
    B74 2SW Sutton Coldfield
    West Midlands
    BritishCompany Director56742320001
    WILLIAMS, David Nigel
    Chapel Lodge Langthwaite
    Arkengarthdale
    DL11 6RE Richmond
    North Yorkshire
    Director
    Chapel Lodge Langthwaite
    Arkengarthdale
    DL11 6RE Richmond
    North Yorkshire
    EnglandBritishConsultant85380410001
    YUILL, Phillip Guy
    Stone Grange
    Coniscliffe Road
    TS26 0BS Hartlepool
    Cleveland
    Director
    Stone Grange
    Coniscliffe Road
    TS26 0BS Hartlepool
    Cleveland
    EnglandBritishCompany Director21261070003

    ¿Tiene VILLIERS STREET GROUP LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Mortgage of shares
    Creado el 18 ene 2002
    Entregado el 22 ene 2002
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    All stock, shares, bonds, debentures, debenture stock, loan stock, unit trust investments, certificates of deposit and other securities of any and in whatever form. All dividends, interst or other disributions paid or payable in respect of them. All allotments, accretions, offers, rights, benefits and advantages whatever at any time arising in respect of them. All stocks, shares, rights, money or property accruing to them or offered at any time by way of conversion, redemption, bonus, preference, option or otherwise in respect of them. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Hsbc Bank PLC
    Transacciones
    • 22 ene 2002Registro de un cargo (395)
    • 05 may 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 22 sept 1994
    Entregado el 27 sept 1994
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    The arndale shopping centre longbenton newcastle upon tyne. Together with all fixtures and fittings now or at any time hereafter on the property. The benefits of all rights licences and the goodwill of the mortgagor in relation to the business from time to time carried on at the property.
    Personas con derecho
    • Midland Bank PLC
    Transacciones
    • 27 sept 1994Registro de un cargo (395)
    • 06 abr 1995Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Creado el 30 may 1985
    Entregado el 04 jun 1985
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed & floating charge on the:- undertaking and all property and assets present and future including bookdebts uncalled capital.
    Personas con derecho
    • Midland Bank PLC
    Transacciones
    • 04 jun 1985Registro de una carga
    • 05 may 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Mortgage
    Creado el 27 oct 1976
    Entregado el 02 nov 1976
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £38,500
    Breve descripción
    Holly house, elwick rd, hartlepool, cleveland.
    Personas con derecho
    • Hilda May Yuill.
    Transacciones
    • 02 nov 1976Registro de una carga
    • 29 ene 1993Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    ¿Tiene VILLIERS STREET GROUP LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    02 may 2006Inicio de la liquidación
    07 mar 2012Fecha de disolución
    Liquidación voluntaria de socios
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Philip Edward Pierce
    Jupiter House The Drive
    Great Warley
    CM13 3BE Brentwood
    Essex
    Profesional
    Jupiter House The Drive
    Great Warley
    CM13 3BE Brentwood
    Essex
    Mark Nicholas Ranson
    2 Whitehall Quay
    LS1 4HG Leeds
    West Yorkshire
    Profesional
    2 Whitehall Quay
    LS1 4HG Leeds
    West Yorkshire

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0