TURBINE BLADING LIMITED

TURBINE BLADING LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Declaraciones de personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaTURBINE BLADING LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 01265008
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de TURBINE BLADING LIMITED?

    • mecanizado (25620) / Industrias manufactureras

    ¿Dónde se encuentra TURBINE BLADING LIMITED?

    Dirección de la sede social
    1 Bridgewater Place
    Water Lane
    LS11 5QR Leeds
    West Yorkshire
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de TURBINE BLADING LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2015

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para TURBINE BLADING LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros

    12 páginasLIQ13

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 02 abr 2021

    10 páginasLIQ03

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 02 abr 2020

    10 páginasLIQ03

    Cancelación total de la carga 18

    1 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 17

    2 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 14

    1 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 16

    1 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 15

    1 páginasMR04

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 02 abr 2019

    9 páginasLIQ03

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    3 páginas600

    Declaración de solvencia

    5 páginasLIQ01

    Domicilio social registrado cambiado de The Arena Downshire Way Bracknell Berkshire RG12 1PU a 1 Bridgewater Place Water Lane Leeds West Yorkshire LS11 5QR el 26 abr 2018

    2 páginasAD01

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    liquidation

    Acuerdo especial para la liquidación el 03 abr 2018

    LRESSP

    Los registros se han trasladado a la ubicación de inspección registrada 3rd Floor 1 Ashley Road Altrincham Cheshire WA14 2DT

    1 páginasAD03

    Notification de Ge Inspection and Repair Services Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 06 abr 2016

    2 páginasPSC02

    Retrait d'une déclaration relative à une personne disposant d'un contrôle significatif le 29 dic 2017

    2 páginasPSC09

    Declaración de confirmación presentada el 15 oct 2017 con actualizaciones

    4 páginasCS01

    Resoluciones

    Resolutions
    15 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    incorporation

    Resolución del Memorándum y/o Artículos de Asociación

    RES01

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    resolution

    Resolución de capitalización o emisión de acciones de bonificación

    That the sum of £1,196,177.00 being the total amount standing to the credit of the company's other reserves, be and is hereby capitalised and appropriated as capital to the holders of the ordinary shares of £1.00 each in the capital of the company 21/09/2017
    RES14
    capital

    Resolución de asignación de valores

    RES10

    legacy

    2 páginasSH20

    Estado de capital el 27 sept 2017

    • Capital: GBP 1
    3 páginasSH19

    legacy

    2 páginasCAP-SS

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resoluciones

    Cancellation of share premium account 22/09/2017
    RES13
    capital

    Resolución de reducción del capital social emitido

    RES06

    Estado de capital tras una asignación de acciones el 21 sept 2017

    • Capital: GBP 1,208,477
    3 páginasSH01

    ¿Quiénes son los directivos de TURBINE BLADING LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    OAKWOOD CORPORATE SECRETARY LIMITED
    Floor
    1 Ashley Road
    WA14 2DT Altrincham
    3rd
    Cheshire
    United Kingdom
    Secretario corporativo
    Floor
    1 Ashley Road
    WA14 2DT Altrincham
    3rd
    Cheshire
    United Kingdom
    Tipo de identificaciónSociedad limitada del Reino Unido
    Número de registro7038430
    146358090001
    DOWNEY, Stephen Thomas
    Downshire Way
    RG12 1PU Bracknell
    The Arena
    Berkshire
    United Kingdom
    Director
    Downshire Way
    RG12 1PU Bracknell
    The Arena
    Berkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishSenior Operation Manager184747430001
    EVERETT, Peter Daryl
    Downshire Way
    RG12 1PU Bracknell
    The Arena
    Berkshire
    United Kingdom
    Director
    Downshire Way
    RG12 1PU Bracknell
    The Arena
    Berkshire
    United Kingdom
    EnglandBritishTax Manager127244240001
    CATALDO, John
    3306 Jameson Pass
    Alpharotta
    FOREIGN 30022 Georgia
    Usa
    Secretario
    3306 Jameson Pass
    Alpharotta
    FOREIGN 30022 Georgia
    Usa
    British62465990001
    JAFFA, Richard Henry
    32 Malcolmson Close
    Edgbaston
    B15 3LS Birmingham
    West Midlands
    Secretario
    32 Malcolmson Close
    Edgbaston
    B15 3LS Birmingham
    West Midlands
    English9163880001
    A G SECRETARIAL LIMITED
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    Secretario corporativo
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    90084920001
    CLIFFORD CHANCE SECRETARIES LIMITED
    10 Upper Bank Street
    E14 5JJ London
    Secretario corporativo
    10 Upper Bank Street
    E14 5JJ London
    38508390004
    BREMNER, Ian Miller
    1 Melford Hall Road
    B91 2ES Solihull
    West Midlands
    Director
    1 Melford Hall Road
    B91 2ES Solihull
    West Midlands
    EnglandBritishAccountant29995610001
    CARTLEDGE, Andrew
    30 Trailside Road
    MA 02493 Weston
    United States
    Director
    30 Trailside Road
    MA 02493 Weston
    United States
    BritishDirector70072110003
    CHRISTIE, Roderick Angus
    14 Oakfield Road
    SL8 5QN Bourne End
    Buckinghamshire
    Director
    14 Oakfield Road
    SL8 5QN Bourne End
    Buckinghamshire
    BritishGeneral Manager Energy Service82543780001
    CLARK, Alyson Margaret
    Downshire Way
    RG12 1PU Bracknell
    The Arena
    Berkshire
    United Kingdom
    Director
    Downshire Way
    RG12 1PU Bracknell
    The Arena
    Berkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishLegal Counsel56868460002
    COYLE, Feilim Malachy
    24 Saint Davids Drive
    TW20 0BA Englefield Green
    Surrey
    Director
    24 Saint Davids Drive
    TW20 0BA Englefield Green
    Surrey
    IrishDirector70072140002
    DANIELL, Paul Nigel
    7 Lucerne Drive
    Stadhampton
    OX44 7QT Oxford
    Oxfordshire
    Director
    7 Lucerne Drive
    Stadhampton
    OX44 7QT Oxford
    Oxfordshire
    BritishHuman Resources Manager62463920001
    DIGBY, Mark Damien
    Calle Valle Del Roncal 71,
    Las Lomas
    28660 Boadilla Del Monte
    Madrid
    Spain
    Director
    Calle Valle Del Roncal 71,
    Las Lomas
    28660 Boadilla Del Monte
    Madrid
    Spain
    IrishEurope Operations Manager103125610001
    FENECH, Lindy Frances
    Service Centre
    Littlebrook Manor Way
    DA1 5PZ Dartford
    Ge Energy Dartford
    Kent
    United Kingdom
    Director
    Service Centre
    Littlebrook Manor Way
    DA1 5PZ Dartford
    Ge Energy Dartford
    Kent
    United Kingdom
    United KingdomBritishNone172863970001
    FRASER, Gillian Annette
    Badgeworth Manor
    Badgeworth
    GL51 5UL Cheltenham
    Gloucestershire
    Director
    Badgeworth Manor
    Badgeworth
    GL51 5UL Cheltenham
    Gloucestershire
    BritishDirector30720040001
    FRASER, Michael James
    Badgeworth Manor
    Badgeworth
    GL51 5UL Cheltenham
    Gloucestershire
    Director
    Badgeworth Manor
    Badgeworth
    GL51 5UL Cheltenham
    Gloucestershire
    BritishDirector35575120001
    GAULT, Ernest Harold
    520 Fawn Glenn Court
    Roswell
    Georgia
    30075
    Usa
    Director
    520 Fawn Glenn Court
    Roswell
    Georgia
    30075
    Usa
    AmericanCompany Director62463900001
    GRIFFITHS, Kyle
    Downshire Way
    RG12 1PU Bracknell
    The Arena
    Berkshire
    United Kingdom
    Director
    Downshire Way
    RG12 1PU Bracknell
    The Arena
    Berkshire
    United Kingdom
    United KingdomUs CitizenOperations Executive172602560001
    JORDAN, Stephen John
    1 Pike Corner
    Willersey
    WR12 7PZ Broadway
    Worcestershire
    Director
    1 Pike Corner
    Willersey
    WR12 7PZ Broadway
    Worcestershire
    BritishCompany Director32376290001
    KEENAN, John Joseph
    5 Gresham Road
    CM14 4HN Brentwood
    Essex
    Director
    5 Gresham Road
    CM14 4HN Brentwood
    Essex
    BritishUk Controller Ge Energy106985300001
    LEVITCH, Paul Edward
    Spring Rise Whichford Road
    Stourton
    CV36 5HG Shipston On Stour
    Warwickshire
    Director
    Spring Rise Whichford Road
    Stourton
    CV36 5HG Shipston On Stour
    Warwickshire
    BritishSales Director50792110001
    MULHOLLAND, Diarmaid Patrick
    Downshire Way
    RG12 1PU Bracknell
    The Arena
    Berkshire
    United Kingdom
    Director
    Downshire Way
    RG12 1PU Bracknell
    The Arena
    Berkshire
    United Kingdom
    ItalyIrishSales Engineer116288460001
    PARKES, David John William
    35 St Martins Close
    CV37 9QW Stratford
    Warwickshire
    Director
    35 St Martins Close
    CV37 9QW Stratford
    Warwickshire
    BritishAccountant85953530001
    ROBERTSON, Moria Ann
    Downshire Way
    RG12 1PU Bracknell
    The Arena
    Berkshire
    Director
    Downshire Way
    RG12 1PU Bracknell
    The Arena
    Berkshire
    United KingdomBritishCfo Europe203364460001
    TON, Gwaine William
    Beech Hill Lodge
    Ridgemead Road, Englefield Green
    TW20 0YD Egham
    Surrey
    Director
    Beech Hill Lodge
    Ridgemead Road, Englefield Green
    TW20 0YD Egham
    Surrey
    AmericanCompany Director93302530001
    WAKE, Hilary Anne, Mrs.
    Downshire Way
    RG12 1PU Bracknell
    The Arena
    Berkshire
    United Kingdom
    Director
    Downshire Way
    RG12 1PU Bracknell
    The Arena
    Berkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishTax Manager96648390001
    WARDLE, John Malcolm
    Norton Grange
    Norton Grange Lane Knowle
    Solihull
    West Midlands
    Director
    Norton Grange
    Norton Grange Lane Knowle
    Solihull
    West Midlands
    BritishDirector5096040001
    WHITE, Andrew Christopher
    4050 Keswick Drive
    Ga 30339 Atlanta
    FOREIGN Usa
    Director
    4050 Keswick Drive
    Ga 30339 Atlanta
    FOREIGN Usa
    BritishGeneral Manager62466070001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de TURBINE BLADING LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Downshire Way
    RG12 1PU Bracknell
    The Arena
    Berkshire
    United Kingdom
    06 abr 2016
    Downshire Way
    RG12 1PU Bracknell
    The Arena
    Berkshire
    United Kingdom
    No
    Forma jurídicaLimited By Shares
    País de registroEngland
    Autoridad legalUnited Kingdom (England)
    Lugar de registroCompanies House
    Número de registro1182449
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.
    • La persona tiene el derecho, directa o indirectamente, de nombrar o destituir a la mayoría de la junta directiva de la empresa.

    ¿Cuáles son las últimas declaraciones sobre personas con control significativo para TURBINE BLADING LIMITED?

    Declaraciones de personas con control significativo
    Notificado elCesado elDeclaración
    15 oct 201601 dic 2017La empresa aún no ha completado las medidas razonables para determinar si existe alguna persona que sea una persona registrable o una entidad jurídica relevante registrable en relación con la empresa.

    ¿Tiene TURBINE BLADING LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Debenture
    Creado el 26 feb 1998
    Entregado el 04 mar 1998
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Midland Bank PLC
    Transacciones
    • 04 mar 1998Registro de un cargo (395)
    • 04 sept 2019Satisfacción de una carga (MR04)
    Legal mortgage
    Creado el 24 ene 1997
    Entregado el 29 ene 1997
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Car park and adjoining land at station rd,shipston-on-stour warwickshire with all rights,licences,guarantees,rent deposits contracts,undertakings,goodwill of business and all other payments. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Midland Bank PLC
    Transacciones
    • 29 ene 1997Registro de un cargo (395)
    • 04 sept 2019Satisfacción de una carga (MR04)
    Legal mortgage
    Creado el 18 dic 1996
    Entregado el 24 dic 1996
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Station road, shipston-on-stour warwickshire; any goodwill of any business from time to time carried on at the property. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Midland Bank PLC
    Transacciones
    • 24 dic 1996Registro de un cargo (395)
    • 04 sept 2019Satisfacción de una carga (MR04)
    Legal mortgage
    Creado el 18 dic 1996
    Entregado el 19 dic 1996
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Property at berry hill industrial estate droitwich with the benefit of all rights and licences shares or membership rights goodwill of any business rental and other money payable.
    Personas con derecho
    • Midland Bank PLC
    Transacciones
    • 19 dic 1996Registro de un cargo (395)
    • 04 sept 2019Satisfacción de una carga (MR04)
    Fixed and floating charge
    Creado el 03 dic 1996
    Entregado el 07 dic 1996
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital goodwill bookdebts and patents.
    Personas con derecho
    • Midland Bank PLC
    Transacciones
    • 07 dic 1996Registro de un cargo (395)
    • 04 sept 2019Satisfacción de una carga (MR04)
    Chattel mortgage
    Creado el 15 mar 1993
    Entregado el 25 mar 1993
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Heller horizontal - PFH10 - M39498 (for full details of charge see form 395).
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 25 mar 1993Registro de un cargo (395)
    • 16 oct 1998Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Chattel mortgage
    Creado el 06 jul 1992
    Entregado el 15 jul 1992
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Various chattels (see form 395 for full details).
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 15 jul 1992Registro de un cargo (395)
    • 05 ago 1993Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Letter of charge
    Creado el 01 jul 1991
    Entregado el 10 jul 1991
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    All moneys now or at any time hereafter standing to the credit of any account whether already opened or to be opened hereafter and in whatsoever currency such account may be denominated and whether with the bank or opened by the bank.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 10 jul 1991Registro de una carga
    • 16 oct 1998Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 20 jun 1991
    Entregado el 10 jul 1991
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Piece of land near station road, shipston-on-stour, in the county of warwickshire.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 10 jul 1991Registro de una carga
    • 16 oct 1998Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Letter of charge.
    Creado el 12 oct 1989
    Entregado el 31 oct 1989
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    All moneys now or at any time hereafter standing to the credit of any account(s) of the company with the bank designated barclays bank PLC, re: turbine blading limited uum al - jawaby no.2.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 31 oct 1989Registro de una carga
    • 16 oct 1998Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Letter of charge
    Creado el 12 oct 1989
    Entregado el 31 oct 1989
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    All moneys now or at any time hereafter standing to the credit of any account(s) of the company with the bank designated barclays bank PLC, re: turbine blading limited egat.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 31 oct 1989Registro de una carga
    • 16 oct 1998Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Letter of charge
    Creado el 12 sept 1989
    Entregado el 02 oct 1989
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    All moneys now or at any time hereafter standing to the credit of any account. Of the company with the bank designated barclays bank PLC re. Turbine blading limited uum al jawaby.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 02 oct 1989Registro de una carga
    • 16 oct 1998Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Letter of charge
    Creado el 08 feb 1989
    Entregado el 22 feb 1989
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    All monies now or at any time hereafter standing to the credit of any account(s) of the company with the bank designated barclays bank PLC re. Turbine blading limited.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 22 feb 1989Registro de una carga
    • 16 oct 1998Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Chattel mortgage
    Creado el 18 ago 1986
    Entregado el 26 ago 1986
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Various machinery (see continuation sheet NO1. Attached to doc 395).
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 26 ago 1986Registro de una carga
    • 16 oct 1998Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Mortgage
    Creado el 22 jul 1986
    Entregado el 28 jul 1986
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Mandelli machining centre serial no. 7239.81.07000049. (see doc M14 for futher details and attached continuation sheet no 1 for full details).
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 28 jul 1986Registro de una carga
    • 16 oct 1998Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Mortgage
    Creado el 22 jul 1986
    Entregado el 28 jul 1986
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Mitutoyo coordinate measurer with attachments serial no. Cmm-B241-6002 hp 9816. mandelli machining centre (HP9872 plotter 7289/83/07000067) (see doc M13 for further details).
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 28 jul 1986Registro de una carga
    • 16 oct 1998Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 02 may 1986
    Entregado el 12 may 1986
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Dale cross grange. Mearse lane, barnt green, bromsgrove, hereford & worcester. Title no. Hw 17903.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 12 may 1986Registro de una carga
    • 19 ago 1994Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 29 jun 1978
    Entregado el 05 jul 1978
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed & floating charges undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital. With all buildings fixtures fixed plant & machinery.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 05 jul 1978Registro de una carga
    • 26 feb 1997Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    ¿Tiene TURBINE BLADING LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    03 abr 2018Inicio de la liquidación
    06 jul 2022Fecha prevista de disolución
    Liquidación voluntaria de socios
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Derek Hyslop
    1 Bridgewater Place Water Lane
    LS11 5QR Leeds
    West Yorkshire
    Profesional
    1 Bridgewater Place Water Lane
    LS11 5QR Leeds
    West Yorkshire
    Robert Hunter Kelly
    Ernst & Young Llp 1 Bridgewater Place Water Lane
    LS11 5QR Leeds
    West Yorkshire
    Profesional
    Ernst & Young Llp 1 Bridgewater Place Water Lane
    LS11 5QR Leeds
    West Yorkshire

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0